BROMFORD IRON AND STEEL COMPANY LIMITED

BROMFORD IRON AND STEEL COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBROMFORD IRON AND STEEL COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00447036
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BROMFORD IRON AND STEEL COMPANY LIMITED?

    • fabbricazione di ferro e acciaio di base e di ferroleghe (24100) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova BROMFORD IRON AND STEEL COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BROMFORD IRON AND STEEL COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per BROMFORD IRON AND STEEL COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    23 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    28 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    21 pagineAM10

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    12 pagineAM11

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    12 pagineAM16

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    21 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Risultato della riunione dei creditori

    5 pagineAM07

    Risultato della riunione dei creditori

    5 pagineAM07

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    11 pagineAM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Bromford Buildings Bromford Lane West Bromwich West Midlands B70 7JJ England a C/O Pricewaterhousecoopers Llp Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 15 ott 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    41 pagineAM03

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Andrew Charles Rich come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2018

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 004470360011, creata il 12 gen 2018

    45 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 004470360010 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2017

    16 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 004470360010, creata il 10 nov 2017

    30 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Andrew Charles Rich come amministratore in data 10 mag 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di BROMFORD IRON AND STEEL COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COLES, Martyn
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    Segretario
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    190657680001
    COLES, Martyn
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    Amministratore
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    EnglandBritishAccountant79949090001
    DAVIES, Peter Francis
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    Amministratore
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    EnglandBritishManagement Consultant64212680001
    HUTTON-PENMAN, Christopher
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    Amministratore
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    EnglandBritishCompany Director77836950002
    PALFREY, Heather
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    Amministratore
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    EnglandBritishDirector90346520003
    WALTERS, Stephen Harold
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    Amministratore
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    EnglandBritishCompany Director28479190002
    BURR, Christopher John
    Ashmore House
    Norton
    WR11 4YL Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Ashmore House
    Norton
    WR11 4YL Evesham
    Worcestershire
    British11620570002
    BUTLER, Frank George
    10 Essington Close
    Shenstone
    WS14 0LA Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    10 Essington Close
    Shenstone
    WS14 0LA Lichfield
    Staffordshire
    British14549870002
    EVERETT, Howard Caile
    27 Newton Road
    Knowle
    B93 9HL Solihull
    West Midlands
    Segretario
    27 Newton Road
    Knowle
    B93 9HL Solihull
    West Midlands
    BritishDirector3447840001
    FOXALL, Raymond
    216 Bills Lane
    Shirley
    B90 2PJ Solihull
    West Midlands
    Segretario
    216 Bills Lane
    Shirley
    B90 2PJ Solihull
    West Midlands
    British6972300002
    HAYHURST, Fred
    High Paddox
    Main Street
    CV35 8JA Norton Lindsey
    Warks
    Segretario
    High Paddox
    Main Street
    CV35 8JA Norton Lindsey
    Warks
    British48880500001
    HAYHURST, Fred
    High Paddox
    Main Street
    CV35 8JA Norton Lindsey
    Warks
    Segretario
    High Paddox
    Main Street
    CV35 8JA Norton Lindsey
    Warks
    BritishCompany Secretary48880500001
    HUMPHREYS, John Christopher
    46 Cheswick Way
    Cheswick Green
    B90 4HE Solihull
    West Midlands
    Segretario
    46 Cheswick Way
    Cheswick Green
    B90 4HE Solihull
    West Midlands
    British116764360001
    HUMPHREYS, John Christopher
    46 Cheswick Way
    Cheswick Green
    B90 4HE Solihull
    West Midlands
    Segretario
    46 Cheswick Way
    Cheswick Green
    B90 4HE Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Secretary116764360001
    JOHNSON, Andrew Ian
    14 Running Hills
    WS15 4AJ Armitage Rugeley
    Staffordshire
    Segretario
    14 Running Hills
    WS15 4AJ Armitage Rugeley
    Staffordshire
    British63174670001
    BURR, Christopher John
    Ashmore House
    Norton
    WR11 4YL Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Ashmore House
    Norton
    WR11 4YL Evesham
    Worcestershire
    BritishDirector11620570002
    BUTLER, Frank George
    10 Essington Close
    Shenstone
    WS14 0LA Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    10 Essington Close
    Shenstone
    WS14 0LA Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector & Company Secretary14549870002
    EVERETT, Howard Caile
    27 Newton Road
    Knowle
    B93 9HL Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    27 Newton Road
    Knowle
    B93 9HL Solihull
    West Midlands
    BritishDirector3447840001
    GALLAGHER, James Michael
    5 Ivel Close
    Barton Le Clay
    MK45 4NT Bedford
    Amministratore
    5 Ivel Close
    Barton Le Clay
    MK45 4NT Bedford
    BritishDirector36023050001
    GODBERT, Granville John
    The Cottage
    Badger Burnhill Green
    WV6 7JU Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    The Cottage
    Badger Burnhill Green
    WV6 7JU Wolverhampton
    West Midlands
    BritishManaging Director14840350001
    GROVE, David Leslie
    Badgers Holt, Rookery Lane
    Lowsonford
    B95 5EP Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Badgers Holt, Rookery Lane
    Lowsonford
    B95 5EP Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector4174280001
    HADEN, Edward Stanley
    Home Lea 21 Greenfield Avenue
    DY8 1SX Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    Home Lea 21 Greenfield Avenue
    DY8 1SX Stourbridge
    West Midlands
    BritishManaging Director2995740001
    ISHERWOOD, Philip Peter
    Sandelands
    Dunsley Road, Kinver
    DY7 6LN Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    Sandelands
    Dunsley Road, Kinver
    DY7 6LN Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritishManaging Director29591920002
    JOHNSON, Andrew Ian
    14 Running Hills
    WS15 4AJ Armitage Rugeley
    Staffordshire
    Amministratore
    14 Running Hills
    WS15 4AJ Armitage Rugeley
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Director63174670001
    LOMBARDI, Peter Francis
    73 Kemps Green Road
    CV7 7QF Balsall Common
    West Midlands
    Amministratore
    73 Kemps Green Road
    CV7 7QF Balsall Common
    West Midlands
    EnglandBritishDirector90213680001
    MARSHALL, Howard Cleveley
    Hillfields House
    Shatterford
    DY12 1SY Bewdley
    Worcestershire
    Amministratore
    Hillfields House
    Shatterford
    DY12 1SY Bewdley
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector11620350003
    MUIR, Derek William
    2 West Fergus Place
    KY1 1UR Kirkcaldy
    Fife
    Amministratore
    2 West Fergus Place
    KY1 1UR Kirkcaldy
    Fife
    United KingdomBritishCompany Director120442470001
    MYATT, Robert Christopher William
    The Sycamores
    1 Ombersley Road
    WR3 7BW Worcester
    Amministratore
    The Sycamores
    1 Ombersley Road
    WR3 7BW Worcester
    BritishDirector30175570002
    OXNARD, Stanley John
    229 Mill Lane
    Dorridge
    B93 8NU Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    229 Mill Lane
    Dorridge
    B93 8NU Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector35352720002
    PAYNE, Colin Hugh
    Rowena 56 Halton Road
    B73 6NU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Rowena 56 Halton Road
    B73 6NU Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishCompany Director29786970001
    PEGLER, Mark
    Bromford Lane
    B70 7JJ West Bromwich
    Bromford Buildings
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bromford Lane
    B70 7JJ West Bromwich
    Bromford Buildings
    West Midlands
    England
    EnglandBritishDirector82454580021
    RICH, Andrew Charles
    Bromford Lane
    B70 7JJ West Bromwich
    Bromford Buildings
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bromford Lane
    B70 7JJ West Bromwich
    Bromford Buildings
    West Midlands
    England
    EnglandBritishOperations Director196117900001
    RICH, Andrew Charles
    Bromford Lane
    B70 7JJ West Bromwich
    Bromford Buildings
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bromford Lane
    B70 7JJ West Bromwich
    Bromford Buildings
    West Midlands
    England
    EnglandBritishOperations Director196117900001
    RICH, Andrew Charles
    Bromford Lane
    B70 7JJ West Bromwich
    Bromford Buildings
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bromford Lane
    B70 7JJ West Bromwich
    Bromford Buildings
    West Midlands
    England
    EnglandBritishOperations Director196117900001
    YATES, Robert William Frederick
    Durgan
    Whittington
    WR5 2RL Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Durgan
    Whittington
    WR5 2RL Worcester
    Worcestershire
    BritishCompany Director61286760001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BROMFORD IRON AND STEEL COMPANY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Original Steel Services Limited
    Weymouth Road
    Martinstown
    DT2 9JJ Dorchester
    Turnpike House
    Dorset
    England
    06 apr 2016
    Weymouth Road
    Martinstown
    DT2 9JJ Dorchester
    Turnpike House
    Dorset
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione05086274
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    BROMFORD IRON AND STEEL COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 gen 2018
    Consegnato il 12 gen 2018
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited (The “Security Trustee”)
    Transazioni
    • 12 gen 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 10 nov 2017
    Consegnato il 16 nov 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 02 dic 2016
    Consegnato il 19 dic 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers LTD ("the Security Trustee")
    Transazioni
    • 19 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 18 ago 2014
    Consegnato il 21 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    1. by way of equitable mortgage all freehold and leasehold properties and other real property both present and future of the company, including all buildings and other structures from time to time erected thereon and all fixtures (trade or otherwise) from time to time thereon or therein.. 2. all the company's patents (including applications, improvements, prolongations, extensions and rights to apply therefor), designs (whether registered or unregistered), copyrights, design rights, trade marks and service marks (whether registered or unregistered), utility models, trade and business names, know-how, formulae, inventions, confidential information, trade secrets and computer software programs and systems (including the benefit of any licences, sub-licences or consents relating to any of the above) and all fees, royalties or other rights derived therefrom or incidental thereto in any part of the world.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Bank Limited
    Transazioni
    • 21 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 12 set 2003
    Consegnato il 29 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the property specified in schedule 2 of the deed, all estates or interests in any f/h or l/h property now belonging to the chargor, all group shares and all related rights, all plant and machinery, all moneys standing to the credit of any account all benefits in respect of the insurances, all book and other debts, goodwill and uncalled capital the intellectual property rights floating charge all assets not otherwise effectively mortgaged or charged by clause 2 (fixed security) of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 29 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement between the chargor, the original guarantors and the agent (as defined) (the "security agreement")
    Creato il 14 set 2001
    Consegnato il 24 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to any finance party under each finance document (all terms as defined)
    Brevi particolari
    By way of a first legal mortgage the properties k/a land and buildings on the south side of hough lane, wombwell, barnsley, south yorkshire, t/no SYK145448. Poplar works, leven wharf, leven road, london t/no LN16516. Land at rea street south, birmingham, t/nos WM276845, WM32786, WM474880, WM249190, WM614407. (For further properties charged please refer to form 395). all estates or interests in any f/h or l/h property, all group shares.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The "Security Agent") as Agent and Trustee for Thefinance Parties (as Defined in the Credit Agreement)
    Transazioni
    • 24 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 dic 1993
    Consegnato il 18 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 23 dic 1982
    Consegnato il 31 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over all undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage & charge
    Creato il 16 gen 1967
    Consegnato il 25 gen 1967
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc
    Brevi particolari
    Land at bromford lane, west bromwich, staffs. With pplant machinery fixtures implements and utensils thereon floating charge on all the undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1967Registrazione di un'ipoteca
    • 16 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 16 gen 1967
    Consegnato il 19 gen 1967
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000 & premiums of not less than 1% payable in certain events
    Brevi particolari
    Endowment policies issued by chargee:- numbers and assured and sums payable 4085741 j c cooper 75,000 (payable on 16/12/91 or earlier death) 4085778 r a maher 50,000 (payable on 12/12/91 or ealier death) and 4085250 c m grew 75,000 (payable on 16/12/91 or ealier death).
    Persone aventi diritto
    • Scottish Widows Fund & Life Assurance Society
    Transazioni
    • 19 gen 1967Registrazione di un'ipoteca
    • 16 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 gen 1967
    Consegnato il 19 gen 1967
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000 & premiums of not less than 1% payable in certain events
    Brevi particolari
    F/H land at west bromwich, staffs adjoining bromford lane, kelvin way & the birmingham canal comprising 7.2 acres together with landlords fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Widows Fund & Life Assurance Society
    Transazioni
    • 19 gen 1967Registrazione di un'ipoteca
    • 16 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BROMFORD IRON AND STEEL COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 set 2019Inizio dell'amministrazione
    30 set 2021Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ross David Connock
    2 Glass Wharf
    BS2 0FR Bristol
    Praticante
    2 Glass Wharf
    BS2 0FR Bristol
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Michael Thomas Denny
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0