MI HUB LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MI HUB LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00454264 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MI HUB LIMITED?
- fabbricazione di indumenti da lavoro (14120) / Industrie manifatturiere
Dove si trova MI HUB LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 3 Long Acre Willow Farm Business Park DE74 2UG Castle Donington Derbyshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MI HUB LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MWUK LIMITED | 17 mar 2011 | 17 mar 2011 |
| DIMENSIONS CLOTHING LIMITED | 01 mag 2008 | 01 mag 2008 |
| JOHNSON CLOTHING LIMITED | 17 gen 2006 | 17 gen 2006 |
| C. C. M. LIMITED | 08 mag 1985 | 08 mag 1985 |
| C.C.M. RAVEN LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
| C.C.M. (LANCASHIRE) LIMITED | 19 mag 1948 | 19 mag 1948 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MI HUB LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 lug 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 apr 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 03 ago 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MI HUB LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 31 lug 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 14 ago 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 31 lug 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per MI HUB LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
legacy | 4 pagine | RP01SH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2025 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 03 ago 2024 | 38 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2024 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 29 lug 2023 | 41 pagine | AA | ||
Iscrizione dell'ipoteca 004542640014, creata il 28 nov 2023 | 67 pagine | MR01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 3 Long Acres Willow Farm Castle Donington Derbyshire DE74 2UG a 3 Long Acre Willow Farm Business Park Castle Donington Derbyshire DE74 2UG in data 16 nov 2023 | 1 pagine | AD01 | ||
Modifica dei dettagli di Measured Identity Hub Limited come persona con controllo significativo il 16 nov 2023 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Hayley Jayne Brooks il 16 nov 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrzej Rafal Ostrowski il 16 nov 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Anthony Ellis il 16 nov 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2023 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Philip Anthony Ellis come amministratore in data 24 apr 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio redatto al 30 lug 2022 | 43 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Kirk Mark Ehrlich come amministratore in data 29 lug 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 31 lug 2021 | 42 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Andrzej Rafal Ostrowski come amministratore in data 03 mag 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 dic 2021 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Morgan Edward Atherton come amministratore in data 30 set 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Martin John Lyne come amministratore in data 31 lug 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Hayley Jayne Brooks il 12 feb 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio redatto al 01 ago 2020 | 41 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 dic 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Kirk Mark Ehrlich come amministratore in data 30 nov 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di MI HUB LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKS, Hayley Jayne | Amministratore | Long Acre Willow Farm Business Park DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire England | United Kingdom | British | 261710040002 | |||||
| ELLIS, Philip Anthony | Amministratore | Long Acre Willow Farm Business Park DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire England | England | British | 126227120001 | |||||
| OSTROWSKI, Andrzej Rafal | Amministratore | Long Acre Willow Farm Business Park DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire England | United Kingdom | British | 195252290003 | |||||
| CARELESS, Robert | Segretario | 43 Newey Road Hall Green B28 0JQ Birmingham West Midlands | British | 652260001 | ||||||
| CONLON, Michael | Segretario | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | British | 153966160001 | ||||||
| HOLMES, Gary William | Segretario | 48 Badgers Way DT10 1EP Sturminster Newton Dorset | British | 93975060001 | ||||||
| HOLMES, Gary William | Segretario | 48 Badgers Way DT10 1EP Sturminster Newton Dorset | British | 93975060001 | ||||||
| LONGFELLOW, Edwin Charles | Segretario | 5 Upton Grange WA8 9ZA Widnes Cheshire | British | 41674840002 | ||||||
| MONAGHAN, Yvonne May | Segretario | 5 Pikes Bridge Fold Eccleston WA10 5AZ St Helens Merseyside | British | 7934540002 | ||||||
| PEARSON, Graham | Segretario | 15 Clover Drive Pickmere WA16 0WF Knutsford Cheshire | British | 95884040001 | ||||||
| PEARSON, Richard Barrett | Segretario | 20 Croft Road Edwalton NG12 4BW Nottingham Nottinghamshire | British | 121732790001 | ||||||
| RHODES, Archibald Alexander | Segretario | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | 206680560001 | |||||||
| ATHERTON, Morgan Edward | Amministratore | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United Kingdom | British | 247398160001 | |||||
| BARNEY, Stephen George | Amministratore | The Dower House 77 Brook Street LE12 6TT Wymeswold Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 73277610001 | |||||
| BROOME, Raymond | Amministratore | 309 Sandy Lane Droylsden M43 7JU Manchester | British | 36826020001 | ||||||
| BROWN, Keith Peter | Amministratore | 3 Hanover Drive Wigmore ME8 0RF Gillingham Kent | British | 17541780002 | ||||||
| CALANDRA, Jack | Amministratore | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United States | American | 250501440001 | |||||
| CALANDRA, Jack, Director | Amministratore | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United States | American | 250501770001 | |||||
| CARELESS, Robert | Amministratore | 43 Newey Road Hall Green B28 0JQ Birmingham West Midlands | British | 652260001 | ||||||
| COLLIS, Gary Andrew | Amministratore | 5 Whittle Green Woodplumpton PR4 0WG Preston Lancashire | United Kingdom | British | 62361800003 | |||||
| CONLON, Michael | Amministratore | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | Usa | American | 191085330001 | |||||
| DAVIS, Neill | Amministratore | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | Usa | United States | 153966520002 | |||||
| EDWAB, David | Amministratore | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United States | American | 153964010001 | |||||
| EHRLICH, Kirk Mark | Amministratore | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | England | British | 120514920001 | |||||
| EWERT, Douglas | Amministratore | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United States | American | 153963360001 | |||||
| GAWLER, David | Amministratore | 76 Park Road TW12 1HP Hampton Hill Middlesex | United Kingdom | South African | 167282630001 | |||||
| GRAHAM, Stuart William | Amministratore | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United Kingdom | British | 125975700004 | |||||
| HAWKINS, Stephen Kenneth | Amministratore | 1 Cae Glas Sychdyn, Nr Mold CH7 6FD Mold Flintshire | Wales | British | 118780710001 | |||||
| HOLMES, Gary William | Amministratore | 48 Badgers Way DT10 1EP Sturminster Newton Dorset | British | 93975060001 | ||||||
| HUGHES, Simon Ralph | Amministratore | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United Kingdom | British | 121914600001 | |||||
| INCHLEY, Simon Nicholas | Amministratore | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | United Kingdom | British | 64345880007 | |||||
| JACKSON, John Ellis | Amministratore | Ellerslie Coronation Road SL5 9LQ Ascot Berkshire | British | 2219540001 | ||||||
| KIMMINS, Jon | Amministratore | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | Usa | American | 191164530001 | |||||
| LOCHERY, Anthony Francis | Amministratore | 85 Ravelston Dykes EH12 6EZ Edinburgh Midlothian | England | British | 18996670003 | |||||
| LYNE, Martin John | Amministratore | Long Acres Willow Farm DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire | England | British | 164287470001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MI HUB LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measured Identity Hub Limited | 16 ago 2019 | Long Acre Willow Farm Business Park DE74 2UG Castle Donington 3 Derbyshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Ensco 645 Limited | 06 apr 2016 | Willow Farm Castle Donington 3 Long Acre United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0