MI HUB LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMI HUB LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00454264
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di MI HUB LIMITED?

    • fabbricazione di indumenti da lavoro (14120) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova MI HUB LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    Derbyshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MI HUB LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MWUK LIMITED17 mar 201117 mar 2011
    DIMENSIONS CLOTHING LIMITED01 mag 200801 mag 2008
    JOHNSON CLOTHING LIMITED17 gen 200617 gen 2006
    C. C. M. LIMITED08 mag 198508 mag 1985
    C.C.M. RAVEN LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    C.C.M. (LANCASHIRE) LIMITED19 mag 194819 mag 1948

    Quali sono gli ultimi bilanci di MI HUB LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 lug 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 apr 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al03 ago 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MI HUB LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al31 lug 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 ago 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al31 lug 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per MI HUB LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    legacy

    4 pagineRP01SH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2025 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 03 ago 2024

    38 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2024 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 29 lug 2023

    41 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 004542640014, creata il 28 nov 2023

    67 pagineMR01

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Long Acres Willow Farm Castle Donington Derbyshire DE74 2UG a 3 Long Acre Willow Farm Business Park Castle Donington Derbyshire DE74 2UG in data 16 nov 2023

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Measured Identity Hub Limited come persona con controllo significativo il 16 nov 2023

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Hayley Jayne Brooks il 16 nov 2023

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrzej Rafal Ostrowski il 16 nov 2023

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Anthony Ellis il 16 nov 2023

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Philip Anthony Ellis come amministratore in data 24 apr 2023

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 lug 2022

    43 pagineAA

    Cessazione della carica di Kirk Mark Ehrlich come amministratore in data 29 lug 2022

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 lug 2021

    42 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Andrzej Rafal Ostrowski come amministratore in data 03 mag 2022

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 dic 2021 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Morgan Edward Atherton come amministratore in data 30 set 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Martin John Lyne come amministratore in data 31 lug 2021

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Hayley Jayne Brooks il 12 feb 2021

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 01 ago 2020

    41 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 dic 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Kirk Mark Ehrlich come amministratore in data 30 nov 2020

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di MI HUB LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROOKS, Hayley Jayne
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    United KingdomBritish261710040002
    ELLIS, Philip Anthony
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish126227120001
    OSTROWSKI, Andrzej Rafal
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    United KingdomBritish195252290003
    CARELESS, Robert
    43 Newey Road
    Hall Green
    B28 0JQ Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    43 Newey Road
    Hall Green
    B28 0JQ Birmingham
    West Midlands
    British652260001
    CONLON, Michael
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Segretario
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    British153966160001
    HOLMES, Gary William
    48 Badgers Way
    DT10 1EP Sturminster Newton
    Dorset
    Segretario
    48 Badgers Way
    DT10 1EP Sturminster Newton
    Dorset
    British93975060001
    HOLMES, Gary William
    48 Badgers Way
    DT10 1EP Sturminster Newton
    Dorset
    Segretario
    48 Badgers Way
    DT10 1EP Sturminster Newton
    Dorset
    British93975060001
    LONGFELLOW, Edwin Charles
    5 Upton Grange
    WA8 9ZA Widnes
    Cheshire
    Segretario
    5 Upton Grange
    WA8 9ZA Widnes
    Cheshire
    British41674840002
    MONAGHAN, Yvonne May
    5 Pikes Bridge Fold
    Eccleston
    WA10 5AZ St Helens
    Merseyside
    Segretario
    5 Pikes Bridge Fold
    Eccleston
    WA10 5AZ St Helens
    Merseyside
    British7934540002
    PEARSON, Graham
    15 Clover Drive
    Pickmere
    WA16 0WF Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    15 Clover Drive
    Pickmere
    WA16 0WF Knutsford
    Cheshire
    British95884040001
    PEARSON, Richard Barrett
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    British121732790001
    RHODES, Archibald Alexander
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Segretario
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    206680560001
    ATHERTON, Morgan Edward
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Amministratore
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United KingdomBritish247398160001
    BARNEY, Stephen George
    The Dower House
    77 Brook Street
    LE12 6TT Wymeswold Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    The Dower House
    77 Brook Street
    LE12 6TT Wymeswold Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish73277610001
    BROOME, Raymond
    309 Sandy Lane
    Droylsden
    M43 7JU Manchester
    Amministratore
    309 Sandy Lane
    Droylsden
    M43 7JU Manchester
    British36826020001
    BROWN, Keith Peter
    3 Hanover Drive
    Wigmore
    ME8 0RF Gillingham
    Kent
    Amministratore
    3 Hanover Drive
    Wigmore
    ME8 0RF Gillingham
    Kent
    British17541780002
    CALANDRA, Jack
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Amministratore
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United StatesAmerican250501440001
    CALANDRA, Jack, Director
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Amministratore
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United StatesAmerican250501770001
    CARELESS, Robert
    43 Newey Road
    Hall Green
    B28 0JQ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    43 Newey Road
    Hall Green
    B28 0JQ Birmingham
    West Midlands
    British652260001
    COLLIS, Gary Andrew
    5 Whittle Green
    Woodplumpton
    PR4 0WG Preston
    Lancashire
    Amministratore
    5 Whittle Green
    Woodplumpton
    PR4 0WG Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish62361800003
    CONLON, Michael
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Amministratore
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    UsaAmerican191085330001
    DAVIS, Neill
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Amministratore
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    UsaUnited States153966520002
    EDWAB, David
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Amministratore
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United StatesAmerican153964010001
    EHRLICH, Kirk Mark
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Amministratore
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    EnglandBritish120514920001
    EWERT, Douglas
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Amministratore
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United StatesAmerican153963360001
    GAWLER, David
    76 Park Road
    TW12 1HP Hampton Hill
    Middlesex
    Amministratore
    76 Park Road
    TW12 1HP Hampton Hill
    Middlesex
    United KingdomSouth African167282630001
    GRAHAM, Stuart William
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Amministratore
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United KingdomBritish125975700004
    HAWKINS, Stephen Kenneth
    1 Cae Glas
    Sychdyn, Nr Mold
    CH7 6FD Mold
    Flintshire
    Amministratore
    1 Cae Glas
    Sychdyn, Nr Mold
    CH7 6FD Mold
    Flintshire
    WalesBritish118780710001
    HOLMES, Gary William
    48 Badgers Way
    DT10 1EP Sturminster Newton
    Dorset
    Amministratore
    48 Badgers Way
    DT10 1EP Sturminster Newton
    Dorset
    British93975060001
    HUGHES, Simon Ralph
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Amministratore
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United KingdomBritish121914600001
    INCHLEY, Simon Nicholas
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Amministratore
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United KingdomBritish64345880007
    JACKSON, John Ellis
    Ellerslie Coronation Road
    SL5 9LQ Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Ellerslie Coronation Road
    SL5 9LQ Ascot
    Berkshire
    British2219540001
    KIMMINS, Jon
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Amministratore
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    UsaAmerican191164530001
    LOCHERY, Anthony Francis
    85 Ravelston Dykes
    EH12 6EZ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    85 Ravelston Dykes
    EH12 6EZ Edinburgh
    Midlothian
    EnglandBritish18996670003
    LYNE, Martin John
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Amministratore
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    EnglandBritish164287470001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MI HUB LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Measured Identity Hub Limited
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    16 ago 2019
    Long Acre
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies For England And Wales
    Numero di registrazione11414518
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Ensco 645 Limited
    Willow Farm
    Castle Donington
    3 Long Acre
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Willow Farm
    Castle Donington
    3 Long Acre
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleModel Articles Regulations 2008
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0