ENODIS INVESTMENTS LIMITED

ENODIS INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàENODIS INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00455541
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BERISFORD INVESTMENTS LIMITED05 dic 199605 dic 1996
    BERISFORD PROPERTY INVESTMENTS LIMITED26 set 199126 set 1991
    BERISFORD (CREDIT RESOURCES) LIMITED11 giu 198711 giu 1987
    J.H. RAYNER (HOLDINGS) LIMITED25 mar 198325 mar 1983
    ZWANENBERG ASSOCIATED FOOD COMPANIES LIMITED15 giu 194815 giu 1948

    Quali sono gli ultimi bilanci di ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2020

    13 pagineAA

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    36 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2019

    13 pagineAA

    legacy

    28 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 gen 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Esyllt John-Featherby come amministratore in data 19 giu 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Albert James Rourke come amministratore in data 19 giu 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione di Enodis Property Group Limited come persona con controllo significativo il 27 feb 2020

    1 paginePSC07

    Modifica dei dettagli di Enodis Group Limited come persona con controllo significativo il 27 feb 2020

    2 paginePSC05

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 27 feb 2020

    • Capitale: GBP 0.50
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    6 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2018

    12 pagineAA

    legacy

    32 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Chi sono gli amministratori di ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    England
    Segretario
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Amministratore
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JOHN-FEATHERBY, Esyllt
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    EnglandBritish273323780001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Segretario
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Amministratore
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    BOWKETT, Alan John
    Croxton Park
    Croxton
    PE19 6SY St Neots
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Croxton Park
    Croxton
    PE19 6SY St Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritish33301630002
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6996370001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Amministratore
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    British45532880003
    GORDON, Alastair Neil
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    Amministratore
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    EnglandBritish61620710001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Amministratore
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Amministratore
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    LEE, Paul Allan
    Clifton Park Road
    Caversham
    RG4 7PD Reading
    4
    Berkshire
    Amministratore
    Clifton Park Road
    Caversham
    RG4 7PD Reading
    4
    Berkshire
    EnglandBritish70564410001
    MITCHELL, Graham Ramsay
    53 Goodhart Place
    E14 8EQ London
    Amministratore
    53 Goodhart Place
    E14 8EQ London
    EnglandBritish105501360001
    NOBLE, Andrew Villiers
    386 Malden Road
    KT4 7NJ Worcester Park
    Surrey
    Amministratore
    386 Malden Road
    KT4 7NJ Worcester Park
    Surrey
    British64593020001
    O'CONNOR, Patrick Finbarr
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    Amministratore delegato nominato
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    British/Irish900010100001
    ROURKE, John Albert James
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United KingdomBritish77646900002
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    WINTON, Adam Howard
    23 Armitage Road
    Golders Green
    NW11 8QT London
    Amministratore
    23 Armitage Road
    Golders Green
    NW11 8QT London
    EnglandBritish50077250001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    Chi sono le persone con controllo significativo di ENODIS INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    06 apr 2016
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2629464
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Enodis Group Limited
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    06 apr 2016
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneCompanies House
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione4330202
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ENODIS INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 25 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Creato il 20 feb 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Creato il 22 nov 2001
    Consegnato il 30 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 16 set 1993
    Consegnato il 20 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of each of the indebtedness agreements (as defined)
    Brevi particolari
    The f/h property k/a bredbury industrial park stockport t/n gm 625224. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of amendment
    Creato il 01 nov 1991
    Consegnato il 15 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee (the security agent) and the banks or any of them under the terms of each of the indebtedness agreements and under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 ott 1991
    Consegnato il 14 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the chargee (the second security agent) and the banks (as defined therein) or any of them under the terms of the indebtedness agreements and the coffee refinancing agreement and all monies due or to become due from the company under the subordinated guarantee and under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings south side of bulsbrook road, hayes t/no. ALCH3721 - see form 395 for further details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 ott 1991
    Consegnato il 14 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due form each obligor (as defined therein) to the chargee (the security agent) and the banks (as defined therein) or any of them under the terms of each of the indebtedness agreements and under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All f/h land and buildings south side of bulsbrook road, hayes t/no. ALCH3721 and all f/h land k/a 3 and 4 the square, petersfield, hampshire - see form 395 for further details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 30 lug 1991
    Acquisito il 31 gen 1992
    Consegnato il 11 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the refinancing agreement dated 21/09/90
    Brevi particolari
    Units 51, 52, 53, 54, 56 and 57 the maltings, bath street, gravesend, kent title numbers: K709759; K709757; K709758; K709762; K709761; and K709760 land previously k/a the depot, 44 and 45 west street, gravesend, gravesham, kenttitle number: K608279.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1992Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 30 lug 1991
    Acquisito il 31 gen 1992
    Consegnato il 11 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the refinancing agreement dated 21/09/90
    Brevi particolari
    Units 51, 52, 53, 54, 56, and 57 the maltings, bath street, gravesend, kent title numbers: K709759; K709757; K709758; K709762; K709761; and K709760 land previously k/a the depot, 44 and 45 west street, gravesend, gravesham, kent title number: K608279.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1992Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 set 1990
    Consegnato il 09 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (the second security agent) and the banks (as therein defined) or any of them under the terms of the indebtedness agreements and the coffee refinancing agreement and all monies due or to become due from berksford international PLC under the subordinated guarantee
    Brevi particolari
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 gen 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 set 1990
    Consegnato il 09 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (the security agent) and the banks (as therein defined) or any of them under each of the indebtedness agreements
    Brevi particolari
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 09 feb 1990
    Acquisito il 30 set 1991
    Consegnato il 21 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies
    Brevi particolari
    13 lower bristol road, avon bath title no av 190171.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 lug 1988
    Acquisito il 30 set 1991
    Consegnato il 21 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies
    Brevi particolari
    Land on the north & south side of lower bristol road bath, avon title no av 92613.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0