ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED

ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00460836
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Acumen Distribution Services Ltd Boundary Way
    Lufton Trading Estate, Lufton
    BA22 8HZ Yeovil
    Somerset
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MANSPED LIMITED02 gen 199602 gen 1996
    UNITED CARRIERS AUTOMOTIVE LOGISTICS LIMITED18 gen 199418 gen 1994
    MANN & SON LONDON (HOLDINGS) LIMITED31 dic 197831 dic 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 09 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 giu 2015

    Stato del capitale al 26 giu 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 28 feb 2014

    13 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    3 pagineAUD

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Stato del capitale al 23 set 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 12 set 2014

    • Capitale: GBP 7,863,072
    3 pagineSH01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 28 feb 2015 al 30 nov 2014

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 09 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 mag 2014

    Stato del capitale al 28 mag 2014

    • Capitale: GBP 973,750
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di David Harris come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Francis Harris come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr William Stobart come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Avril Palmer-Baunack come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Light come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 09 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2012 al 28 feb 2013

    1 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARRIS, David Francis
    Boundary Way
    Lufton Trading Estate, Lufton
    BA22 8HZ Yeovil
    Acumen Distribution Services Ltd
    Somerset
    United Kingdom
    Segretario
    Boundary Way
    Lufton Trading Estate, Lufton
    BA22 8HZ Yeovil
    Acumen Distribution Services Ltd
    Somerset
    United Kingdom
    British130075020001
    LAMPERT, Timothy Giles
    Boundary Way
    Lufton Trading Estate, Lufton
    BA22 8HZ Yeovil
    Acumen Distribution Services Ltd
    Somerset
    United Kingdom
    Amministratore
    Boundary Way
    Lufton Trading Estate, Lufton
    BA22 8HZ Yeovil
    Acumen Distribution Services Ltd
    Somerset
    United Kingdom
    EnglandBritish74811520007
    STOBART, William
    Langford Way
    Appleton
    WA4 4TQ Warrington
    Stobart Group
    England
    Amministratore
    Langford Way
    Appleton
    WA4 4TQ Warrington
    Stobart Group
    England
    United KingdomBritish153344800001
    ARMSTRONG, Colin
    200 Worle Parkway
    Worle
    BS22 6WA Weston Super Mare
    Somerset
    Segretario
    200 Worle Parkway
    Worle
    BS22 6WA Weston Super Mare
    Somerset
    British77327430003
    ARMSTRONG, Philippa
    162 Muller Road
    Horfield
    BS7 9QX Bristol
    Avon
    Segretario
    162 Muller Road
    Horfield
    BS7 9QX Bristol
    Avon
    British108400480001
    LIGHT, John Michael Heathcote
    Mambury Manor
    East Putford
    EX22 7UH Holsworthy
    Devon
    Segretario
    Mambury Manor
    East Putford
    EX22 7UH Holsworthy
    Devon
    British50795850001
    NIZAN, Jacqueline Kay
    11 Medway Close
    MK16 9DT Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Segretario
    11 Medway Close
    MK16 9DT Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    British30038330001
    SMITH, Thomas Martyn
    3 Winston Drive
    Isham
    NN14 1HS Kettering
    Northamptonshire
    Segretario
    3 Winston Drive
    Isham
    NN14 1HS Kettering
    Northamptonshire
    British522060001
    ALEXANDER, William Norman
    10 Park Road
    Hampton Hill
    TW12 1HB Hampton
    Middlesex
    Amministratore
    10 Park Road
    Hampton Hill
    TW12 1HB Hampton
    Middlesex
    British66253860001
    ASTON, Anthony Lynn
    Eildon Seal Hollow Road
    TN13 3RZ Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Eildon Seal Hollow Road
    TN13 3RZ Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish9012370001
    BINKS, Allan William Spence
    Barton House
    The Green Clipston
    LE16 9RS Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Barton House
    The Green Clipston
    LE16 9RS Market Harborough
    Leicestershire
    British33252740001
    BROWN, Russell Stephen
    Staplehay
    Trull
    TA3 7EZ Taunton
    Westways House
    Somerset
    Amministratore
    Staplehay
    Trull
    TA3 7EZ Taunton
    Westways House
    Somerset
    EnglandBritish132668460001
    CARDLE, David Anthony
    Bakersfield School Road
    School Road
    CO9 2RY Little Maplestead
    Essex
    Amministratore
    Bakersfield School Road
    School Road
    CO9 2RY Little Maplestead
    Essex
    British31944920001
    ELLIS, Stephen James
    10 School Lane
    Lubenham
    LE16 9TW Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    10 School Lane
    Lubenham
    LE16 9TW Market Harborough
    Leicestershire
    British54329470001
    GARVEY, Kevin John
    8 Nightingale Crescent
    New Bradwell
    MK13 7UE Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    8 Nightingale Crescent
    New Bradwell
    MK13 7UE Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British57718780001
    GUINCHARD, Gilles
    5 Upper St Martin's Lane
    WC2H 9EA London
    Amministratore
    5 Upper St Martin's Lane
    WC2H 9EA London
    French93757990002
    HARRIS, David Francis
    Boundary Way
    Lufton
    BA22 8HZ Yeovil
    Stobart Automotive
    Somerset
    England
    Amministratore
    Boundary Way
    Lufton
    BA22 8HZ Yeovil
    Stobart Automotive
    Somerset
    England
    EnglandBritish130075020001
    LIGHT, John Michael Heathcote
    5 Grange Park
    Roman Way
    NN4 5EA Northampton
    Autologic House
    United Kingdom
    Amministratore
    5 Grange Park
    Roman Way
    NN4 5EA Northampton
    Autologic House
    United Kingdom
    EnglandBritish50795850001
    MERRY, John Charles
    Walon
    Boundary Way Lufton
    BA22 8HZ Yeovil
    Somerset
    Amministratore
    Walon
    Boundary Way Lufton
    BA22 8HZ Yeovil
    Somerset
    British9807640012
    NUTTALL, Philip James
    5 Upper St Martins Lane
    WC2H 9EA London
    Amministratore
    5 Upper St Martins Lane
    WC2H 9EA London
    British63716970003
    PAINTER, James
    Stoneleigh House Burley Lane
    DE22 5JR Quarndon
    Derbyshire
    Amministratore
    Stoneleigh House Burley Lane
    DE22 5JR Quarndon
    Derbyshire
    British41731410001
    PALMER-BAUNACK, Avril
    5 Grange Park
    Roman Way
    NN4 5EA Northampton
    Autologic House
    United Kingdom
    Amministratore
    5 Grange Park
    Roman Way
    NN4 5EA Northampton
    Autologic House
    United Kingdom
    EnglandBritish196667380002
    SHUTER, Adam John
    Tudor Cottage
    11 Manor Road, Kilsby
    CV23 8XS Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    Tudor Cottage
    11 Manor Road, Kilsby
    CV23 8XS Rugby
    Warwickshire
    British59297260002
    SMITH, James Fergus Neil
    Stone End
    Chapel Close Towcester Road
    NN12 8JA Litchborough
    Northamptonshire
    Amministratore
    Stone End
    Chapel Close Towcester Road
    NN12 8JA Litchborough
    Northamptonshire
    British17332750002
    SMITH, Thomas Martyn
    3 Winston Drive
    Isham
    NN14 1HS Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    3 Winston Drive
    Isham
    NN14 1HS Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish522060001
    SOMERVILLE, Andy Forbes
    5 Grange Park
    Roman Way
    NN4 5EA Northampton
    Autologic House
    United Kingdom
    Amministratore
    5 Grange Park
    Roman Way
    NN4 5EA Northampton
    Autologic House
    United Kingdom
    EnglandBritish200512970001
    TOYNE, John Richard
    Kingsmoor House
    83 Mill Lane
    NN2 6RQ Northampton
    Amministratore
    Kingsmoor House
    83 Mill Lane
    NN2 6RQ Northampton
    British63406940001
    WARLOW, Roger
    Applewood Faringdon Road
    Southmoor
    OX13 5AF Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Applewood Faringdon Road
    Southmoor
    OX13 5AF Abingdon
    Oxfordshire
    British45977210001
    WOOD, Terry George
    26 The Old Yews
    DA3 7JS Longfield
    Kent
    Amministratore
    26 The Old Yews
    DA3 7JS Longfield
    Kent
    British56487950001

    ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite all assets guarantee and debenture
    Creato il 28 apr 2006
    Consegnato il 12 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 12 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 27 apr 2006
    Consegnato il 08 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 12 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture
    Creato il 09 ott 1998
    Consegnato il 17 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness liabilities and obligations owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee by any group company under the terms of the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 26 mag 1989
    Consegnato il 16 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to became due from each obligor (as defined in each of the credit agreement and the subordenated loan agreement both dated 26.5.89) to the charge as agent and trustee for itself and the lenders (as defined in the charge) on anny account whatsoever under the terms of the finance documents (as defined in the charge).
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • For Itself and as Agent and Truste of or Itself and the Banks
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 27 feb 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 30 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 17 gen 1986
    Consegnato il 30 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys now on hereafter to the credit of any accounts of the company with the bank. Barclays bank PLC remann & son london (holdings) LTD. Cash security account.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    Supplemmental legal mortgage
    Creato il 14 mar 1984
    Consegnato il 15 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeversupplemental to an agreement and & debenture dated 15/12/80
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book debts and other debts due or ouing to the company present ad future.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 15 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 15 dic 1980
    Consegnato il 31 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. Tog with all fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery. (See doc M65).
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transazioni
    • 31 dic 1980Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 15 dic 1980
    Consegnato il 19 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, stock-in-trade work in progress, repayments investments & all cash. Tog with all buildings & fixtures, fixed plant & machenary (please see doc M64).
    Persone aventi diritto
    • Industrial & Commercial Finance Corpn Limited
    Transazioni
    • 19 dic 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0