MARR FOODS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARR FOODS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00467148
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MARR FOODS LIMITED?

    • Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi (10200) / Industrie manifatturiere
    • Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, compresi pesci, crostacei e molluschi (46380) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova MARR FOODS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Merseyside
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MARR FOODS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MARR FROZEN FOODS LIMITED01 ott 198101 ott 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARR FOODS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MARR FOODS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MARR FOODS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 dic 2015

    6 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW a 8 Princes Parade Liverpool Merseyside L3 1QH in data 07 mag 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 apr 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Bilancio annuale redatto al 11 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 set 2014

    Stato del capitale al 01 set 2014

    • Capitale: GBP 3,500,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Hamish Forbes come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Jenny Nancy Loncaster come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 11 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 set 2013

    Stato del capitale al 05 set 2013

    • Capitale: GBP 3,500,000
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 26 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 25 in pieno

    5 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2012

    9 pagineAA

    Nomina di Mr Malcolm Herbert Lofts come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Leadbeater come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Hamish Drummond Forbes come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher Britton come amministratore

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    18 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 20/09/2012
    RES13

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 dic 2012 al 30 set 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 11 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    15 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Seventh senior amendment and restatement deed and other company business 11/06/2012
    RES13

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MARR FOODS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    PO BOX 16
    Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    New Oxford House
    North East Lincolnshire
    Segretario
    PO BOX 16
    Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    New Oxford House
    North East Lincolnshire
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02249348
    75197930001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Amministratore
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    EnglandBritish177239110001
    LONCASTER, Jenny Nancy
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Amministratore
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    EnglandBritish205633180001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Segretario
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    British1031110002
    BERRY, Peter Sidney
    18 St Georges Place
    The Mount
    YO2 2DR York
    North Yorkshire
    Amministratore
    18 St Georges Place
    The Mount
    YO2 2DR York
    North Yorkshire
    British48690810001
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127835580001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Amministratore
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    EnglandBritish1031110002
    CULPIN, Malcolm
    17 High Wheatley
    Ben Rhydding
    LS29 8RX Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    17 High Wheatley
    Ben Rhydding
    LS29 8RX Ilkley
    West Yorkshire
    British37654460001
    DEE, Frank Rigby
    4 West View
    LS29 9JG Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 West View
    LS29 9JG Ilkley
    West Yorkshire
    British780440002
    EVANS, Thomas Jeffrey
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    Amministratore
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    EnglandBritish2183390002
    FORBES, Hamish Drummond
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish66295550001
    GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    Amministratore
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    United KingdomBritish58713750002
    HARKJAER, Per
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    EnglandDanish127032620001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    MILLSON, Steven Roland
    1 The Row
    Walesby
    LN8 3UW Market Rasen
    Lincolnshire
    Amministratore
    1 The Row
    Walesby
    LN8 3UW Market Rasen
    Lincolnshire
    British49260600003
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Amministratore
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    RAINES, Gerald Hector
    19 Marlborough Way
    Country Park
    DN35 0TR Cleethorpes
    South Humberside
    Amministratore
    19 Marlborough Way
    Country Park
    DN35 0TR Cleethorpes
    South Humberside
    British44675880002
    VICKERS, David
    89 Northfield
    Swanland
    HU14 3RE Hull
    Amministratore
    89 Northfield
    Swanland
    HU14 3RE Hull
    British2183410001
    WARD, Peter Selwyn
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritish33803400001

    MARR FOODS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 ott 2008
    Consegnato il 01 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 01 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 set 2008
    Consegnato il 04 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (Security Agent)
    Transazioni
    • 04 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2007
    Consegnato il 31 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale the Security Agent
    Transazioni
    • 31 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 mar 2006
    Consegnato il 25 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The 'Security Agent')
    Transazioni
    • 25 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2005
    Consegnato il 17 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All material premises being f/h interest in land and buildings on the north side of clive sullivan way, kingston upon hull t/no HS262846; l/h interest in land to the east of havelock street, kingston upon hull, land on the west side of gillett street and land and buildings on the south west side of gillett street; l/h interest in land and buildings on the south side of the scarborough street, kingston upon hull, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transazioni
    • 17 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 10 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    With full title guarantee, both present and future by way of first legal mortgage the property specified in schedule 1 to the accession deed, together with all buildings and fixtures and all the subsidiary shares and investments specified in schedule 2 to the accession deed;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Securityagent)
    Transazioni
    • 10 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 15 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 14 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 dic 1997
    Consegnato il 09 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a land and buildings on the west side of gillett street kingston upon hull.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 mar 1997
    Consegnato il 04 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the south of scarborough street, kingston upon hull, city of kingston upon hull.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 08 nov 1996
    Consegnato il 18 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 30 ott 1995
    Consegnato il 31 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum of £36,900.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    A first fixed charge over:1 x yamato sdw 323 WH2 multihead machine,serial no:WG950396.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 31 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 gen 1995
    Consegnato il 27 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land south of hall street sandwell west midlands. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1994
    Consegnato il 04 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings at the south of scarborough street kingston upon hull humberside.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 24 set 1994
    Consegnato il 28 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 5 of a sale agreement dated 24 september 1994
    Brevi particolari
    Floating charge all the stock in trade both present and future wheresoever situated of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ub (Ross Youngs) Limited
    Transazioni
    • 28 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 mag 1991
    Consegnato il 04 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the south side of hermitage way, mansfield, nottinghamshire. Title no nt 247625.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 mag 1990
    Consegnato il 18 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land to the east of havelock street, kingston upon hull, humberside. Title no hs 169178.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mag 1990
    Consegnato il 08 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land to the east of havelock street, kingston upon hull, humberside, title no hs 169179.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 14 apr 1989
    Consegnato il 28 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from pinegain limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    For full details of property see form 395 ref M219C.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 28 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 20 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 14 apr 1989
    Consegnato il 20 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from pinegain limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    (For full list of properties charged see form 395 ref:M613C and attached schedule a). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 20 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 20 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 14 apr 1989
    Consegnato il 19 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/o rpinegain limited to the chargee under the terms of the secured loan and subscription agreement dated 14.4.89 and this charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Marr International Limited
    Transazioni
    • 19 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 14 apr 1989
    Consegnato il 19 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or pinegain limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Leslie Marr
    Transazioni
    • 19 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture.
    Creato il 14 apr 1989
    Consegnato il 26 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company pinegain limited. To the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 gen 1985
    Consegnato il 24 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land on the west side of gillett st.kingston-upon-hull, humberside, togetherwith all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 24 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 nov 1980
    Consegnato il 22 nov 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. With all fixtures and fittings, fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transazioni
    • 22 nov 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MARR FOODS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 mar 2016Data di scioglimento
    16 apr 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian Green
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praticante
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0