SMITH & NEPHEW FARNHAM LIMITED

SMITH & NEPHEW FARNHAM LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSMITH & NEPHEW FARNHAM LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00473439
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SMITH & NEPHEW FARNHAM LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova SMITH & NEPHEW FARNHAM LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Adam Street
    London
    WC2N 6LA
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SMITH & NEPHEW FARNHAM LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HOMECRAFT MANUFACTURING LIMITED 12 apr 199112 apr 1991
    HOMECRAFT SUPPLIES LIMITED13 mar 198713 mar 1987
    HOMECRAFT SUPPLIES (FLEET STREET) LIMITED30 set 194930 set 1949

    Quali sono gli ultimi bilanci di SMITH & NEPHEW FARNHAM LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SMITH & NEPHEW FARNHAM LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 20 ott 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Bilancio annuale redatto al 20 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Smith & Nephew Nominee Services Limited il 28 lug 2011

    2 pagineCH04

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    10 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Susan Maragret Henderson il 18 giu 2010

    3 pagineCH01

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    2 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    2 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    11 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    11 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SMITH & NEPHEW FARNHAM LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITH & NEPHEW NOMINEE SERVICES LIMITED
    Adam Street
    WC2N 6LA London
    15
    Segretario
    Adam Street
    WC2N 6LA London
    15
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione258735
    67416460002
    FULLER, Lucille
    15 Adam Street
    WC2N 6LA London
    Amministratore
    15 Adam Street
    WC2N 6LA London
    United KingdomBritishAccountant6354580004
    HENDERSON, Susan Maragret
    Adam Street
    WC2N 6LA London
    15
    United Kingdom
    Amministratore
    Adam Street
    WC2N 6LA London
    15
    United Kingdom
    UkBritishChartered Secretary138619780001
    PARSONS, Gemma Elizabeth Mary
    Adam Street
    WC2N 6LA London
    15
    Amministratore
    Adam Street
    WC2N 6LA London
    15
    United KingdomBritishCompany Secretary129294510001
    AIKMAN, Alan Alastair, Dr
    3 Kestrel Close
    Ewshot
    GU10 5TW Farnham
    Surrey
    Segretario
    3 Kestrel Close
    Ewshot
    GU10 5TW Farnham
    Surrey
    British21817580001
    CURTIS, John Mark
    15 Reads Field
    GU34 5XA Four Marks
    Hampshire
    Segretario
    15 Reads Field
    GU34 5XA Four Marks
    Hampshire
    British77468380001
    JACKSON, Andrew Michael Warren
    51 Telegraph Lane
    Four Marks
    GU34 5AX Alton
    Hampshire
    Segretario
    51 Telegraph Lane
    Four Marks
    GU34 5AX Alton
    Hampshire
    British60163340002
    MILLER, David John
    8 Savoy Grove
    Blackwater
    GU17 9JW Camberley
    Surrey
    Segretario
    8 Savoy Grove
    Blackwater
    GU17 9JW Camberley
    Surrey
    BritishChartered Accountant24935140002
    AIKMAN, Alan Alastair, Dr
    3 Kestrel Close
    Ewshot
    GU10 5TW Farnham
    Surrey
    Amministratore
    3 Kestrel Close
    Ewshot
    GU10 5TW Farnham
    Surrey
    BritishManager21817580001
    BELL, Stewart William
    8 Beech Cliffe
    Coventry Road
    CV34 5HY Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    8 Beech Cliffe
    Coventry Road
    CV34 5HY Warwick
    Warwickshire
    BritishDirector14893880002
    CHAMBERS, Paul Richard
    15 Adam Street
    WC2N 6LA London
    Amministratore
    15 Adam Street
    WC2N 6LA London
    BritishCompany Secretary40205020002
    DICK, James Lawrence
    Broomhill
    16a Humber Road
    HU14 3DW North Ferriby
    North Humberside
    Amministratore
    Broomhill
    16a Humber Road
    HU14 3DW North Ferriby
    North Humberside
    EnglandBritishCompany Director37270820001
    ENGLAND, Terence
    41 Upper Tilehouse Street
    SG5 2EE Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    41 Upper Tilehouse Street
    SG5 2EE Hitchin
    Hertfordshire
    BritishManager24935150001
    FULLER, Lucille
    55 Grove Way
    KT10 8HQ Esher
    Surrey
    Amministratore
    55 Grove Way
    KT10 8HQ Esher
    Surrey
    BritishAccountant6354580002
    HALL, David George
    6 York Mews
    GU34 1JD Alton
    Hampshire
    Amministratore
    6 York Mews
    GU34 1JD Alton
    Hampshire
    BritishManager23993360001
    HIGGINS, Philip Lyndon
    15 Adam Street
    WC2N 6LA London
    Amministratore
    15 Adam Street
    WC2N 6LA London
    BritishChartered Secretary69977780004
    JACKSON, Andrew Michael Warren
    51 Telegraph Lane
    Four Marks
    GU34 5AX Alton
    Hampshire
    Amministratore
    51 Telegraph Lane
    Four Marks
    GU34 5AX Alton
    Hampshire
    BritishGeneral Manager60163340002
    KNIGHT, Michael Robert Paget
    Kiln Lodge
    Blacknest
    GU34 4QB Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Kiln Lodge
    Blacknest
    GU34 4QB Alton
    Hampshire
    BritishManager29674360002
    LOMAX, Clifford Kenneth
    185 Worlds End Lane
    Chelsfield
    BR6 6AT Orpington
    Kent
    Amministratore
    185 Worlds End Lane
    Chelsfield
    BR6 6AT Orpington
    Kent
    BritishChartered Accountant645540002
    MCHARGUE, James Michael
    339 West White Oak Way
    53092 Mequon
    Wisconsin
    United States
    Amministratore
    339 West White Oak Way
    53092 Mequon
    Wisconsin
    United States
    AmericanPresident57280640001
    MILLER, David John
    8 Savoy Grove
    Blackwater
    GU17 9JW Camberley
    Surrey
    Amministratore
    8 Savoy Grove
    Blackwater
    GU17 9JW Camberley
    Surrey
    EnglandBritishFinancial Controller24935140002
    MILLER, David John
    8 Savoy Grove
    Blackwater
    GU17 9JW Camberley
    Surrey
    Amministratore
    8 Savoy Grove
    Blackwater
    GU17 9JW Camberley
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant24935140002
    O'DONNELL, Christopher John, Sir
    Lambs Acre
    Ingmanthorpe Hall Farm York Road
    LS22 5EQ Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Lambs Acre
    Ingmanthorpe Hall Farm York Road
    LS22 5EQ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director75339080001
    PARSON, Michael George
    Grey Flags
    SN9 6DT Upavon
    Wiltshire
    Amministratore
    Grey Flags
    SN9 6DT Upavon
    Wiltshire
    BritishCompany Secretary28745890002
    ROWLANDS, David Lionel Glyndwr, Dr
    Madeley Court
    Hemingford Grey
    PE28 3DF Huntingdon
    Dunster
    Amministratore
    Madeley Court
    Hemingford Grey
    PE28 3DF Huntingdon
    Dunster
    United KingdomBritishBusiness Consultant130831800001
    SUTTON, Joanna Victoria
    58 Macmillan Way
    SW17 6AS London
    Amministratore
    58 Macmillan Way
    SW17 6AS London
    BritishCompany Secretary83336120001

    SMITH & NEPHEW FARNHAM LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1991
    Consegnato il 25 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or homecroft manufacturing limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Land and bldgs on the west side of sidings road, kirkby-in-ashfield, nottinghamshire.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 21 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 mar 1991
    Consegnato il 21 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governer and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 21 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture & guarantee
    Creato il 11 ago 1988
    Consegnato il 16 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machienry stocks shares, incalled capital see doc for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sds Bank Limited
    Transazioni
    • 16 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0