THAMES RICO SERVICE STATIONS LIMITED

THAMES RICO SERVICE STATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHAMES RICO SERVICE STATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00477257
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THAMES RICO SERVICE STATIONS LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova THAMES RICO SERVICE STATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Gladstone Place
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di THAMES RICO SERVICE STATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per THAMES RICO SERVICE STATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr William Bahlsen Bannister il 06 dic 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr William Bahlsen Bannister il 06 dic 2018

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Building 2 Abbey View Everard Close St Albans Hertfordshire AL1 2QU United Kingdom a Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St Albans Hertfordshire AL1 3UU in data 10 lug 2018

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Leopard Pel Limited come persona con controllo significativo il 02 lug 2018

    2 paginePSC05

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA

    legacy

    52 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    3 pagineSH20

    Stato del capitale al 24 nov 2017

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    20 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 004772570164, creata il 19 giu 2017

    116 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 004772570163, creata il 22 dic 2016

    101 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 004772570162, creata il 16 dic 2016

    11 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 004772570161, creata il 07 nov 2016

    98 pagineMR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2015

    22 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Park Row Leeds LS1 5AB United Kingdom a Building 2 Abbey View Everard Close St Albans Hertfordshire AL1 2QU in data 01 lug 2016

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di THAMES RICO SERVICE STATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02318923
    76579530001
    ALLAN, Timothy Edward Douglas
    Drumburn Farm
    FK14 7JW Muckhart
    Clackmannanshire
    Amministratore
    Drumburn Farm
    FK14 7JW Muckhart
    Clackmannanshire
    United KingdomBritish108784910001
    BANNISTER, William Bahlsen
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish54266450004
    BIGGART, Thomas Mckenzie
    Hillfoot Road
    FK14 7PL By Dollar
    Castleton Farm
    Clackmannanshire
    Amministratore
    Hillfoot Road
    FK14 7PL By Dollar
    Castleton Farm
    Clackmannanshire
    ScotlandBritish82724480005
    HUNT, John Richard
    18 Milden Close
    Frimley Green
    GU16 6PX Camberley
    Surrey
    Segretario
    18 Milden Close
    Frimley Green
    GU16 6PX Camberley
    Surrey
    British51398860001
    JONES, Stephen John
    1 Larch Close
    Speen
    RG14 1UY Newbury
    Berkshire
    Segretario
    1 Larch Close
    Speen
    RG14 1UY Newbury
    Berkshire
    British73291560001
    MAGUIRE, John Michael
    3 Lincoln Court
    226 Willesden Lane
    NW2 5RG London
    Segretario
    3 Lincoln Court
    226 Willesden Lane
    NW2 5RG London
    British87426850001
    PAMELY, Philip
    11 Pages Croft
    RG40 2HN Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    11 Pages Croft
    RG40 2HN Wokingham
    Berkshire
    British36775580002
    SQUIRES, Michael John
    30 Melford Walk
    Nythe
    SN3 3RL Swindon
    Wiltshire
    Segretario
    30 Melford Walk
    Nythe
    SN3 3RL Swindon
    Wiltshire
    British54681230001
    WRIGHT, Maureen Catherine
    36 Westfield Avenue
    WD2 4ED Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    36 Westfield Avenue
    WD2 4ED Watford
    Hertfordshire
    British3196840001
    BARNES, Robert Bruce
    19 Lewisham High Street
    Lewisham
    SE13 5AF London
    Amministratore
    19 Lewisham High Street
    Lewisham
    SE13 5AF London
    British38841560002
    CRAIG, Barrie Pearson
    Masefield House 91 Newcastle Road
    ST15 8LD Stone
    Staffordshire
    Amministratore
    Masefield House 91 Newcastle Road
    ST15 8LD Stone
    Staffordshire
    British59780860001
    DAWSON, Allan George
    Nether Brotherstone House
    EH38 5YS Heriot
    Amministratore
    Nether Brotherstone House
    EH38 5YS Heriot
    ScotlandBritish93178680001
    ESDALE, Gerald Paton Risett
    58 Wildwood Road
    Hampstead
    NW11 6UP London
    Amministratore
    58 Wildwood Road
    Hampstead
    NW11 6UP London
    British1938590001
    ESDALE, Patricia Joyce, Dr
    58 Wildwood Road
    Hampstead
    NW11 6UP London
    Amministratore
    58 Wildwood Road
    Hampstead
    NW11 6UP London
    EnglandBritish3684900001
    FALCONER, Ian
    Cottington House
    Cottington Hill
    RG26 5UD Hannington
    Hampshire
    Amministratore
    Cottington House
    Cottington Hill
    RG26 5UD Hannington
    Hampshire
    EnglandBritish49402550006
    FORSYTH, Angus Alpin
    Waughton House
    EH40 3DY East Linton
    East Lothian
    Amministratore
    Waughton House
    EH40 3DY East Linton
    East Lothian
    ScotlandBritish81456550001
    FRENCH, David Michael
    Winfield The Warren
    East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Winfield The Warren
    East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    British54561370001
    GARRY, Steven Bernard
    Lawhill
    FK14 7PN Dollar
    Lawhill House
    Clackmannanshire
    Amministratore
    Lawhill
    FK14 7PN Dollar
    Lawhill House
    Clackmannanshire
    United KingdomIrish132867110001
    HAACKE, Ronald John
    45 Shepherds Way
    WD3 7NW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    45 Shepherds Way
    WD3 7NW Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish26165300002
    HALL, Clifford Arthur Charles
    23 Mornington
    AL6 0AJ Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    23 Mornington
    AL6 0AJ Welwyn
    Hertfordshire
    British59936330001
    HOOKHAM, Peter
    St Ronan's Drive
    KY13 8AF Perth & Kinross
    St Ronan's
    Amministratore
    St Ronan's Drive
    KY13 8AF Perth & Kinross
    St Ronan's
    UkBritish65880590006
    HUNT, John Richard
    18 Milden Close
    Frimley Green
    GU16 6PX Camberley
    Surrey
    Amministratore
    18 Milden Close
    Frimley Green
    GU16 6PX Camberley
    Surrey
    British51398860001
    LOWE, Peter John Harvey
    The Old Vicarage
    Church Lane Weston
    SG4 7DJ Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Church Lane Weston
    SG4 7DJ Hitchin
    Hertfordshire
    British32528670001
    PORT, David Charles
    Spellar Park
    Brandsby
    YO61 4RN York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Spellar Park
    Brandsby
    YO61 4RN York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish58053990001
    SLADE, Dominic James Haviland
    13 Hasker Street
    SW3 2LE London
    Amministratore
    13 Hasker Street
    SW3 2LE London
    British111640410001
    STAGEN, Frank Peter
    14/20 Fifth Avenue
    Suite 2705
    FOREIGN Seattle
    Washington 98101
    Usa
    Amministratore
    14/20 Fifth Avenue
    Suite 2705
    FOREIGN Seattle
    Washington 98101
    Usa
    American24810900001
    WOODS, Dennis Laurence
    Birch Hall
    Church Road
    GU20 6BN Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Birch Hall
    Church Road
    GU20 6BN Windlesham
    Surrey
    EnglandEnglish19765000002

    Chi sono le persone con controllo significativo di THAMES RICO SERVICE STATIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03391904
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    THAMES RICO SERVICE STATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 19 giu 2017
    Consegnato il 23 giu 2017
    In corso
    Breve descrizione
    Abercynon service station, A470 (northbound), abercynon, mid glamorgan, CF45 4YX (CYM261681); 26 old chester road, bebington, wirrel, CH63 7LQ (MS315088); beechley service station, kingsmills road, hightown, wrexham, LL13 8NH (WA507795); and others. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas, London Branch
    Transazioni
    • 23 giu 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 22 dic 2016
    Consegnato il 23 dic 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Land at A470 (northbound), abercynon, mid glamorgan, CF45 4YX - abercynon service station, mountain ash, CF45 4YX; land at 26 old chester road, bebington, wirrel, CH63 7LQ; land at kingsmill road, hightown, wrexham, LL13 8NH - beechley service station, kingsmills road, wrexham (LL13 8NH); land at eastern bypass, coventry, west midlands, CV3 2ZZ - binley woods service station, A46 eastern bypass, binley woods, coventry (CV3 2ZZ). For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas, London Branch
    Transazioni
    • 23 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 16 dic 2016
    Consegnato il 20 dic 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Freehold land on the south-west side of ystrad road, rhondda. Title number: WA94776.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas, London Branch
    Transazioni
    • 20 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 07 nov 2016
    Consegnato il 16 nov 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Land at A470 (northbound), abercynon, mid glamorgan, CF45 4YX - abercynon service station, mountain ash, CF45 4YX; land at 26 old chester road, bebington, wirrel, CH63 7LQ; land at kingsmill road, hightown, wrexham, LL13 8NH - beechley service station, kingsmills road, wrexham (LL13 8NH); land at eastern bypass, coventry, west midlands, CV3 2ZZ - binley woods service station, A46 eastern bypass, binley woods, coventry (CV3 2ZZ). For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas, London Branch
    Transazioni
    • 16 nov 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 03 set 2015
    Consegnato il 04 set 2015
    In corso
    Breve descrizione
    A-470 northbound abercynon mid glamorgan and abercynon service station mountain ash t/no CYM261681 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas London Branch as Security Agent
    Transazioni
    • 04 set 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 12 lug 2013
    Consegnato il 24 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All the company’s estates or interests in any real property (as defined in the instrument. Evidencing the charge accompanying this form MR01) now or hereafter belonging to. It, including those properties listed in part 1 of schedule 2 of the charge to which this. Form MR01 relates, as shown in the instrument evidencing the charge accompanying this form. MR01.. All the company’s rights under any agreement relating to the purchase of any. Freehold or leasehold property.. All the company's rights under any occupational lease, licence or other right of. Occupation.. All its right, title and interest in any intellectual property rights belonging to it or. (To the extent of its interest) in which it has an interest.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Secured Parties (As Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01)
    Transazioni
    • 24 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 lug 2013
    Consegnato il 23 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Secured Parties (As Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01)
    Transazioni
    • 23 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 2008
    Consegnato il 01 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H all that piece or parcel of land together with the garage underground tanks and any out buildings belonging thereto situate at elton corner elton westbury on severn gloucestershire and fronting on the east side to the main gloucester to south wales road A.48 and the south side to the road from cinderford A.4151 and having a depth on the north boundary of 147 feet or thereabouts the fence dividing the said property from the adjoining property on the west, f/h premises on the north side of havant road emsworth having a frontage of 100 feet or thereabouts and a depth therefrom of 128 feet or thereabouts; by way of fixed charge plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 2008
    Consegnato il 01 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bebington service station 26 old chester road bebington t/no MS315088, beechley service station kingsmills road wrexham t/no WA507795, fosseway service station fosseway lower slaughter cheltenham t/no GR135942; (for further details of properties charged please refer to the form 395); by way of fixed charge all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 ott 2008
    Consegnato il 01 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2008
    Consegnato il 06 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Sandon road service station sandon road bearwood birmingham t/no WM454249, overend service station congreaves road cradley heath warley west midlands t/no WM305182, oldswinford services station hagley road oldswinford stourbridge west midlands t/no WM377700 and bloomfield road tipton west midlands t/no SF112790.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 11 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a supermart bilston (bp) service station, willenhall road, bilston, west midlands t/no SF46019.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 11 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H and l/h property k/a supermart walton le dale (bp) station, victoria road, walton le dale, preston t/no's LA593228 and LAN51527.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 11 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a balby road service station, balby road, doncaster t/no SYK213696.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 11 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a the petrol filling station at hyndburn road, accrington t/no LA605916.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 11 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a the petrol filling station at church street, littleborough, greater manchester t/no GM505006.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 11 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a cleadon garage, shields road, cleadon, sunderland t/no's TY279382 and TY244381.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 11 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a supermart netherton (bp) service station, halesowen road, netherton, dudley t/no WM620849.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 12 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 26 old chester road higher bebington merseyside t/no MS315088.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (Corporate Division)
    Transazioni
    • 12 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 12 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a beechley service station kingsmill road wrexham t/no WA507795.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (Corporate Division)
    Transazioni
    • 12 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 feb 2006
    Consegnato il 22 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a mumbles service station, mumbles road, swansea t/n WA707594. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 feb 2006
    Consegnato il 22 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a hamworthy service station, blandford road, poole, dorset t/n DT187352. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 feb 2006
    Consegnato il 22 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a walsgrave service station, 143 hinkley road, walsgrave on sowe, coventry t/n WM403712. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 ott 2005
    Consegnato il 19 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a tawe service station, neath road, landore, swansea t/no WA970071. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 ott 2005
    Consegnato il 19 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a west moors service station, ringwood road, wimborne, dorset t/no DG282720. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0