C WALKER & SONS LIMITED
Panoramica
Nome della società | C WALKER & SONS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00482552 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di C WALKER & SONS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova C WALKER & SONS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di C WALKER & SONS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
C WALKER & SONS (HOLDINGS) LIMITED | 04 nov 1988 | 04 nov 1988 |
C. WALKER & SONS LIMITED | 24 mag 1950 | 24 mag 1950 |
Quali sono gli ultimi bilanci di C WALKER & SONS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per C WALKER & SONS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sharone Vanessa Gidwani come amministratore in data 31 lug 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 15 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 30 Millbank London SW1P 4WY a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 14 apr 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Corus Management Limited come persona con controllo significativo il 01 apr 2021 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per British Steel Directors (Nominees) Limited il 01 apr 2021 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 ott 2020 | 12 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 04 ott 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Theresa Valerie Robinson come segretario in data 20 ott 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di C WALKER & SONS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRITISH STEEL DIRECTORS (NOMINEES) LIMITED | Amministratore | Grosvenor Place SW1X 7HS London 18 England |
| 57383920004 | ||||||||||
BROCK, John Shields | Segretario | 2 Sparrow Close WS10 9QJ Wednesbury West Midlands | British | 80356940001 | ||||||||||
ROBINSON, Theresa Valerie | Segretario | 30 Millbank London SW1P 4WY | British | 97191200001 | ||||||||||
SCANDRETT, Allison Leigh | Segretario | Warren Road Colliers Wood SW19 2HY London 67 | British | 1037770001 | ||||||||||
BRIGHT, Derek Norman | Amministratore | Pinewood 40 Oriental Road GU22 7AR Woking Surrey | British | Chartered Accountant | 338790001 | |||||||||
CAIN, William John | Amministratore | 30 George Lane Hayes BR2 7LQ Bromley Kent | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 13180001 | ||||||||
CHADWICK, Ian Talbot | Amministratore | 8 The Spinney Cuddington CW8 2UH Northwich Cheshire | British | Director | 51562980001 | |||||||||
CHEETHAM, Barrie | Amministratore | 67 Barnards Hill SL7 2NX Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 4493270001 | ||||||||
DAVIS, John Andrew | Amministratore | Milford House 1 Corbett Street WR9 7BQ Droitwich Worcestershire | British | Chairman | 56695490001 | |||||||||
DODD, Harry James William | Amministratore | 15 Ash Hill WV3 9DR Wolverhampton West Midlands | England | British | Director | 113062490001 | ||||||||
DUFFELL, Geoffrey Douglas | Amministratore | Velmor House 85 Belbroughton Road Blakedown DY10 3JJ Kidderminster Worcestershire | British | Director | 31033930001 | |||||||||
GIDWANI, Sharone Vanessa | Amministratore | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | England | British | Solicitor / Secretary | 174416740001 | ||||||||
GLASSBROOK, George | Amministratore | Tanglewood Ash Leigh Drive Markland Hill BL1 5BD Bolton Lancashire | United Kingdom | British | Director | 20154780001 | ||||||||
GREGSON-PATCHETT, Paul | Amministratore | Bramley 2 Vicarage Close Hallow WR2 6PA Worcester Worcestershire | British | Director | 22027470001 | |||||||||
HARGER, John Witney | Amministratore | Rock Cottage Thornton In Craven BD23 3ST Skipton North Yorkshire | British | Director | 22127750001 | |||||||||
LEGGETT, Anthony Malcolm | Amministratore | 6 The Croft WV15 5AE Bridgnorth Shropshire | United Kingdom | British | Director | 123199410001 | ||||||||
MAGINNIS, William James | Amministratore | Tarquinii Ravernette Lisburn County Antrim | British | Director | 22127730001 | |||||||||
SCANDRETT, Allison Leigh | Amministratore | Warren Road Colliers Wood SW19 2HY London 67 | England | British | Company Secretary | 1037770001 | ||||||||
WESTALL, Ian Benjamin | Amministratore | 679 Preston Old Road BB2 5EN Blackburn Lancashire | British | Director | 38333380001 | |||||||||
WHEELEN, Peter David | Amministratore | The Barn Prickley Green WR6 6QQ Martley Worcs | British | Director | 23352690001 | |||||||||
WHITELAW, Robert Michael | Amministratore | Applegarth 549 Chorley New Road BL1 5DP Bolton Lancashire | British | Director | 22127740001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di C WALKER & SONS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corus Management Limited | 06 apr 2016 | Grosvenor Place SW1X 7HS London 18 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
C WALKER & SONS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Charge | Creato il 26 nov 1987 Consegnato il 30 nov 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £10,500,000 convertible loan stock 1993 of steel stock limited and all other moneys due or to become due secured by a trust deed dated 29/12/86 and deeds supplemental thereto. | |
Brevi particolari 1) land & premises on the south east side of cox's lane, cradley heath warley west midlands title no. Wr 21307 (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 29 dic 1986 Consegnato il 05 gen 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £10,500,000 convertible loan stock 1993 of gkn steelstock limited and all other moneys intended to be secured by the said trust deed | |
Brevi particolari Fixed charge all book debts and other debts. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts & other debts uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 23 dic 1986 Consegnato il 08 gen 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Sub-mortgage | Creato il 28 apr 1982 Consegnato il 30 apr 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 1) book debt of £7,234,734.50 2) sub mortgage over l/h ends in townland of knorkmore co antrim. 3) sub charge over folio no 3180L co antrim 4) sub charge over folio no 27767 co antrim 5) assignment of chattels attached to folio no 27767 co antrim 6) assignment transfer & conveyance by way of sub charge of 12 floating charges over the assets of 12 companies with an unlimited inter-company cross guarantee from the said 12 companies. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Further guarantee & debenture | Creato il 29 set 1980 Consegnato il 17 ott 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 21 nov 1978 Consegnato il 12 dic 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed & floating charges on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital, buildings, fixtures fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
C WALKER & SONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0