MERRYCHEF LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMERRYCHEF LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00487712
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MERRYCHEF LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MERRYCHEF LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MERRYCHEF LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MAX-ARC LIMITED27 ott 195027 ott 1950

    Quali sono gli ultimi bilanci di MERRYCHEF LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per MERRYCHEF LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Stato del capitale al 10 mag 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    3 pagineSH20

    legacy

    4 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium cancelled 26/04/2013
    RES13

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    19 pagineAA

    Cessazione della carica di Robert Arthey come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    23 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Graham Philip Brisley Veal il 30 set 2010

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Kevin Blades come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Robert Michael Arthey il 08 mag 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Prima Secretary Limited il 08 mag 2010

    2 pagineCH04

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    23 pagineAA

    Cessazione della carica di Thomas Doerr come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Adrian David Gray come amministratore

    3 pagineAP01

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di MERRYCHEF LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Segretario
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Amministratore
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritishAccountant146072380001
    HOBBS, Jeremy David
    160 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    160 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritishExecs Op Director30245730001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Amministratore
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmericanCompany Director134328700001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritishBusiness Development Director43215170003
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Segretario
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    JELLY, Jennifer
    Wychanger Hook Lane
    Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    Segretario
    Wychanger Hook Lane
    Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    British1745390001
    KEYWOOD, Joyce Rosalyn
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    Segretario
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    British50397900001
    AIREY, Andrew Robert
    Heywood House
    Mark Way
    GU7 2BB Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Heywood House
    Mark Way
    GU7 2BB Godalming
    Surrey
    EnglandBritishDirector54515590004
    ARTHEY, Robert Michael
    6 Fullerton Close
    GU51 1BJ Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    6 Fullerton Close
    GU51 1BJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director106616280002
    BARKER, Simon Charles
    Timberdene Cottage
    Chalk Road, Ifold
    RH14 0UD Billingshurst
    West Sussex
    Amministratore
    Timberdene Cottage
    Chalk Road, Ifold
    RH14 0UD Billingshurst
    West Sussex
    BritishFinance Director113730600001
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Amministratore
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritishAccountant79449700002
    BRAY, Kenneth Ivor
    Nether Hall
    Main Street, Denton
    NG32 1JR Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    Nether Hall
    Main Street, Denton
    NG32 1JR Grantham
    Lincolnshire
    BritishDeputy Managing Director45153770002
    CAMPBELL, James
    Rent Street Cottages
    60 Chipperfield Road
    HP3 0JW Bovingdon
    Hertfordshire
    Amministratore
    Rent Street Cottages
    60 Chipperfield Road
    HP3 0JW Bovingdon
    Hertfordshire
    BritishDirector53496740001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Amministratore
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United StatesSolicitor134081280001
    EATON, Derek James
    53 Cedars Road
    BR3 4JG Beckenham
    Amministratore
    53 Cedars Road
    BR3 4JG Beckenham
    EnglandBritishAccountant112945120001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    BritishFinancial Director45532880003
    GALE, Robert Geoffrey
    Hurlands Lane
    GU8 4NT Dunsfold
    Hurst Hill Lodge
    Surrey
    Uk
    Amministratore
    Hurlands Lane
    GU8 4NT Dunsfold
    Hurst Hill Lodge
    Surrey
    Uk
    United KingdomBritishManufacturing Director138375430001
    GEORGE, Alan
    Oak Tree Cottage Robin Hood Lane
    Sutton Green
    GU4 7QG Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Oak Tree Cottage Robin Hood Lane
    Sutton Green
    GU4 7QG Guildford
    Surrey
    BritishDirector1745400001
    GREEN, Robert Anthony
    Yew Tree Cottage South Lane
    Nomansland
    SP5 2BZ Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Yew Tree Cottage South Lane
    Nomansland
    SP5 2BZ Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector10281810001
    HAMPTON, Mark Richard
    Bankside 5 Parsonage Road
    HP8 4JW Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Bankside 5 Parsonage Road
    HP8 4JW Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    BritishCorporate Treasurer80408810001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary17023730002
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    BritishCompany Secretary17023730001
    HOUGHTON, Reece
    5 St Barbe Close
    SO51 5RH Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    5 St Barbe Close
    SO51 5RH Romsey
    Hampshire
    BritishDirector27953100001
    JELLY, Aubrey Bruce, Mr.
    Wychanger
    GU5 9QQ Shere
    Surrey
    Amministratore
    Wychanger
    GU5 9QQ Shere
    Surrey
    United KingdomBritishDirector82764370003
    JELLY, Jennifer
    Wychanger Hook Lane
    Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Wychanger Hook Lane
    Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    BritishDirector1745390001
    KEYWOOD, Joyce Rosalyn
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    22 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    BritishAccountant50397900001
    LEE, Paul Allan
    Clifton Park Road
    Caversham
    RG4 7PD Reading
    4
    Berkshire
    Amministratore
    Clifton Park Road
    Caversham
    RG4 7PD Reading
    4
    Berkshire
    EnglandBritishDirector Of Corporate Control70564410001
    MCCULLOCH, David Swinton
    920 Westwinds Boulevard
    Tarpon Springs
    Florida 34689
    Usa
    Amministratore
    920 Westwinds Boulevard
    Tarpon Springs
    Florida 34689
    Usa
    Canadian BritishExecutive78976850002
    MILLER, Stuart Purves
    1 Meadway Park
    SL9 7NN Gerards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Meadway Park
    SL9 7NN Gerards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCfo Group98718070001
    OSBORNE, Ian
    Yorkshire Place
    Warfield
    RG42 3XF Bracknell
    59
    Berkshire
    Uk
    Amministratore
    Yorkshire Place
    Warfield
    RG42 3XF Bracknell
    59
    Berkshire
    Uk
    British CanadianCommercial President Internati137173190001
    ROLT, Jeremy Charles
    4 Sycamore Close
    St Ippolyts
    SG4 7SN Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Sycamore Close
    St Ippolyts
    SG4 7SN Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant35716980001
    SHUR, Irwin Michael
    10007 Tree Tops Lake Road
    FOREIGN Tampa
    Florida 33626
    Usa
    Amministratore
    10007 Tree Tops Lake Road
    FOREIGN Tampa
    Florida 33626
    Usa
    UsAttorney124062640002
    THORNEYWORK, Nigel
    Malden Dale Bailes Lane
    Normandy
    GU3 2AX Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Malden Dale Bailes Lane
    Normandy
    GU3 2AX Guildford
    Surrey
    EnglandBritishTechnical Director9730100001
    TONER, Robert Anthony
    29 Lamb Close
    WD25 0TB Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    29 Lamb Close
    WD25 0TB Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector Corporate Planning70516300002

    MERRYCHEF LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 25 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Creato il 20 feb 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Creato il 20 nov 2001
    Consegnato il 30 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 20 dic 1996
    Consegnato il 03 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 20 dic 1996
    Consegnato il 27 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold premises at station road west,ashvale,aldershot,hampshire GU12 5XA; see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 26 gen 1983
    Consegnato il 11 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts. Uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 11 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee & debenture
    Creato il 10 dic 1982
    Consegnato il 31 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 03 mar 1981
    Consegnato il 10 mar 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to and/or all or any of the othher companies named therein to barclays bank LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property undertaking & assets charged by the principal deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0