PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED

PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00490152
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED?

    • Altri servizi di pulizia (81299) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ground Floor Suite River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GORTON BROS,LIMITED03 gen 195103 gen 1951

    Quali sono gli ultimi bilanci di PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 004901520008 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2016 con aggiornamenti

    8 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    8 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    13 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 004901520008, creata il 30 ago 2016

    46 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 ott 2015

    Stato del capitale al 12 ott 2015

    • Capitale: GBP 3,000
    SH01

    Nomina di Mr Simon Kenneth Giles come segretario in data 28 set 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Mark Ian Saunders come amministratore in data 28 set 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Saunders come segretario in data 28 set 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Jonathan Stephen Levine come amministratore in data 28 set 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Simon Kenneth Giles come amministratore in data 09 mar 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Scott Dudley come amministratore in data 12 feb 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 ott 2014

    Stato del capitale al 14 ott 2014

    • Capitale: GBP 3,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ott 2013

    Stato del capitale al 28 ott 2013

    • Capitale: GBP 3,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GILES, Simon Kenneth
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Segretario
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    201339390001
    GILES, Simon Kenneth
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Amministratore
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    EnglandBritish196768780001
    LEVINE, Jonathan Stephen
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Amministratore
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    EnglandBritish19162600001
    BRIDGWOOD, Dennis Henry
    22 Bronington Close
    Northenden
    M22 4ZQ Manchester
    Segretario
    22 Bronington Close
    Northenden
    M22 4ZQ Manchester
    British18005670003
    DOWE, Stephen William
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    British88908400002
    MCGIVERN, James Patrick
    The Ridge
    CH60 6SP Wirral
    3
    Merseyside
    Segretario
    The Ridge
    CH60 6SP Wirral
    3
    Merseyside
    British120346770001
    SAUNDERS, Mark
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    Segretario
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    167359580001
    SCOBIE, James Martin
    Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    1
    Kent
    England
    Segretario
    Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    1
    Kent
    England
    149576830001
    STRATFORD, Frederick
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    Segretario
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    162167080001
    BOYLE, Eugene Daniel
    Teach Ban
    Parkside Drive
    PR6 7PL Whittle Le Woods Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    Teach Ban
    Parkside Drive
    PR6 7PL Whittle Le Woods Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish86492920001
    BRIDGWOOD, Dennis Henry
    22 Bronington Close
    Northenden
    M22 4ZQ Manchester
    Amministratore
    22 Bronington Close
    Northenden
    M22 4ZQ Manchester
    British18005670003
    DOWE, Stephen William
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish88908400002
    DUDLEY, Scott
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    Amministratore
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    EnglandBritish166551090001
    GORTON, Janice
    Deepdale 33 Jacksons Edge Road
    Disley
    SK12 2LN Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Deepdale 33 Jacksons Edge Road
    Disley
    SK12 2LN Stockport
    Cheshire
    British19948440001
    GORTON, Jeffrey William
    2 Whalley Road
    Hale
    WA15 9DF Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    2 Whalley Road
    Hale
    WA15 9DF Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish6307420001
    GORTON, Kenneth Rodney
    Deepdale 33 Jacksons Edge Road
    Disley
    SK12 2LN Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Deepdale 33 Jacksons Edge Road
    Disley
    SK12 2LN Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish16289860001
    GORTON, Patricia
    2 Whalley Road
    WA15 9DF Hale
    Cheshire
    Amministratore
    2 Whalley Road
    WA15 9DF Hale
    Cheshire
    British84528730001
    HARDY-WILSON, Nigel Andrew
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    Amministratore
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    EnglandBritish149590930001
    HOWROYD, David Rowan
    Bay Tree House
    East Street
    TN20 6TY Mayfield
    East Sussex
    Amministratore
    Bay Tree House
    East Street
    TN20 6TY Mayfield
    East Sussex
    British72333480002
    MCGIVERN, James Patrick
    The Ridge
    CH60 6SP Wirral
    3
    Merseyside
    Amministratore
    The Ridge
    CH60 6SP Wirral
    3
    Merseyside
    EnglandBritish120346770002
    PICKUP, James
    Crooklands Farm Goosnargh Lane
    Goosnargh
    PR3 2JU Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Crooklands Farm Goosnargh Lane
    Goosnargh
    PR3 2JU Preston
    Lancashire
    British35926750001
    SAUNDERS, Mark Ian
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    Amministratore
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    EnglandBritish139588670003
    SCOBIE, James Martin
    1 Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    Kent
    Amministratore
    1 Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    Kent
    United KingdomBritish73982880001
    STRATFORD, Frederick Anthony
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    Amministratore
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    United KingdomBritish151871680001
    WINSTANLEY, Michael, Lord
    93 Bankhall Lane
    Hale
    WA15 0NW Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    93 Bankhall Lane
    Hale
    WA15 0NW Altrincham
    Cheshire
    British21499330001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Roger Leonard Burdett
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06 apr 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Jonathan Stephen Levine
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06 apr 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Mr David Mundell
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06 apr 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Simon Giles
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06 apr 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 ago 2016
    Consegnato il 01 set 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transazioni
    • 01 set 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 ott 2008
    Consegnato il 05 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Capital Partners LLP
    Transazioni
    • 05 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed & floating charge
    Creato il 30 ott 2008
    Consegnato il 04 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 ott 2008
    Consegnato il 04 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 nov 2004
    Consegnato il 16 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1988
    Consegnato il 12 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H - 72 to 76 (even) laindon road, rusholme manchester. Title no. Gm 345742. by way of fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 12 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 mar 1988
    Consegnato il 07 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 set 1978
    Consegnato il 10 ott 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land with buildings known as cumber works, bennett street, ardwick, manchester, greater manchester, title no. Gm 155045 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • William's & Glyn's Bank Limited
    Transazioni
    • 10 ott 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 11 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0