PRENTIS DONEGAN & PARTNERS LIMITED

PRENTIS DONEGAN & PARTNERS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPRENTIS DONEGAN & PARTNERS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00491445
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PRENTIS DONEGAN & PARTNERS LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova PRENTIS DONEGAN & PARTNERS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bentima House
    168-172 Old Street
    EC1V 9BP London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PRENTIS DONEGAN & PARTNERS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MORGAN, DONEGAN & COLEMAN LIMITED07 nov 199407 nov 1994
    MORGAN,WRIGHT & COLEMAN LIMITED 30 ott 199030 ott 1990
    MORGAN, CAMPBELL & WRIGHT LIMITED19 set 199019 set 1990
    B & C MARINE BROKERS LIMITED01 gen 198901 gen 1989
    B & C INTERNATIONAL INSURANCE BROKERS LIMITED01 lug 198801 lug 1988
    CAYZER STEEL BOWATER INTERNATIONAL LIMITED10 feb 195110 feb 1951

    Quali sono gli ultimi bilanci di PRENTIS DONEGAN & PARTNERS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per PRENTIS DONEGAN & PARTNERS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagine4.71
    A1FUTFER

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 nov 2011

    7 pagine4.68
    A0ZUVDDD

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Tower Place West Tower Place London EC3R 5BU in data 07 dic 2010

    2 pagineAD01
    A7HC0PLK

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70
    A7OKUPLT

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600
    A7HBZPLI

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 22 nov 2010

    LRESSP

    Cessazione della carica di Angus Cameron come amministratore

    2 pagineTM01
    ADTOZP7Z

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA
    AN724MJF

    Cessazione della carica di Adrianne Cormack come segretario

    2 pagineTM02
    APFM6IPD

    Nomina di Polly Naher come segretario

    3 pagineAP03
    APFMCIPJ

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 mar 2010

    Stato del capitale al 19 mar 2010

    • Capitale: GBP 1,500,000
    SH01
    AU6QAID5

    legacy

    2 pagine288a
    A3X8DAY3

    legacy

    1 pagine288b
    A3X7HAY6

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA
    ADU8XAEA

    legacy

    5 pagine363a
    AFZXG8CL

    legacy

    5 pagine363a
    ACV5LYCH

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA
    AOQNPXUR

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    12 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    16 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    8 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di PRENTIS DONEGAN & PARTNERS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NAHER, Polly
    Boultwood Road
    E6 5QH London
    25
    Segretario
    Boultwood Road
    E6 5QH London
    25
    British150213770001
    METHARAM, Paul
    52 Dale View Avenue
    Chingford
    E4 6PL London
    Amministratore
    52 Dale View Avenue
    Chingford
    E4 6PL London
    EnglandBritishTax Professional81624910001
    BATES, Susan Elizabeth
    Rambler Cottage
    Houndscroft Rodborough
    GL5 5DG Stroud
    Gloucestershire
    Segretario
    Rambler Cottage
    Houndscroft Rodborough
    GL5 5DG Stroud
    Gloucestershire
    BritishCompany Secretary36822540002
    CORMACK, Adrianne Helen Marie
    7 Little Norsey Road
    CM11 1BL Billericay
    Essex
    Segretario
    7 Little Norsey Road
    CM11 1BL Billericay
    Essex
    British14247690003
    WILLIAMS, Robin John Arthur, Sol
    Willingham Cottage
    Farm Lane Send
    GU23 7AT Woking
    Surrey
    Segretario
    Willingham Cottage
    Farm Lane Send
    GU23 7AT Woking
    Surrey
    British100969560001
    WRIGHT, David Edward
    Home Farm
    Shoreham
    TN14 7RP Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    Home Farm
    Shoreham
    TN14 7RP Sevenoaks
    Kent
    British12638050001
    MORGAN INSURANCE SERVICES
    6 Alie Street
    E1 8DD London
    Segretario
    6 Alie Street
    E1 8DD London
    41703180001
    BARNES, Barry Anthony Reginald
    40 Elms Crescent
    Clapham
    SW4 8QZ London
    Amministratore
    40 Elms Crescent
    Clapham
    SW4 8QZ London
    BritishInsurance Broker49233860001
    BATES, Susan Elizabeth
    Rambler Cottage
    Houndscroft Rodborough
    GL5 5DG Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Rambler Cottage
    Houndscroft Rodborough
    GL5 5DG Stroud
    Gloucestershire
    BritishInsurance Broker36822540002
    BECKER, Gerald Royston Lionel Kendall
    The Old Rectory
    Wrabness
    CO11 2TX Manningtree
    Essex
    Amministratore
    The Old Rectory
    Wrabness
    CO11 2TX Manningtree
    Essex
    BritishInsurance Broker16402020002
    BEDFORD, Christopher Paul
    Waymarks 107 Ashford Road
    ME13 8XW Faversham
    Kent
    Amministratore
    Waymarks 107 Ashford Road
    ME13 8XW Faversham
    Kent
    EnglandBritishInsurance Broker30888260001
    BONNER, David Anthony
    Highmead 259 Roman Road
    Mountnessing
    CM15 0UH Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Highmead 259 Roman Road
    Mountnessing
    CM15 0UH Brentwood
    Essex
    EnglandBritishMarine Insurance Broker12864450002
    CAMERON, Angus Kenneth
    Tower Place West
    Tower Place
    EC3R 5BU London
    1
    Amministratore
    Tower Place West
    Tower Place
    EC3R 5BU London
    1
    United KingdomBritishAccountant134082550001
    CARPENTER, Edward Jeffrey
    Maltings
    11a The Green
    CB2 6ST Foxton
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Maltings
    11a The Green
    CB2 6ST Foxton
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishCompany Director100969820001
    CLARK, Robert John
    11 Great Oak
    TN19 7QF Hurst Green
    East Sussex
    Amministratore
    11 Great Oak
    TN19 7QF Hurst Green
    East Sussex
    BritishInsurance Broker12864460001
    CLEMENTSON, Barry
    Shelley House Shelley Avenue
    Tiptree
    CO5 0SF Colchester
    Essex
    Amministratore
    Shelley House Shelley Avenue
    Tiptree
    CO5 0SF Colchester
    Essex
    BritishInsurance Broker79994510001
    CULVERHOUSE, Jeremy Charles John
    The Castle
    Cranbury Park, Otterbourne
    SO21 2HN Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    The Castle
    Cranbury Park, Otterbourne
    SO21 2HN Winchester
    Hampshire
    BritishInsurance Broker55075220003
    DARBY, Michael Charles
    38 Consort House
    St Davids Square
    E14 3WA London
    Amministratore
    38 Consort House
    St Davids Square
    E14 3WA London
    BritishCompany Director80995290001
    DONEGAN, Michael Piers
    Spode Lane
    Cowden
    TN8 7HJ Edenbridge
    Crippenden Manor
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Spode Lane
    Cowden
    TN8 7HJ Edenbridge
    Crippenden Manor
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishInsurance Broker141024460001
    FINDLAY, Graham Alexander
    6 Parkgate
    SE3 9XB London
    Amministratore
    6 Parkgate
    SE3 9XB London
    EnglandBritishInsurance Broker46391040001
    FOSTER, Toni Elisabeth
    39 Hazel Grove
    RH15 0BZ Burgess Hill
    West Sussex
    Amministratore
    39 Hazel Grove
    RH15 0BZ Burgess Hill
    West Sussex
    BritishChartered Secretary6114050003
    GARDNER, Andrew
    32 Furrowfelde
    Kingswood
    SS16 5EY Basildon
    Essex
    Amministratore
    32 Furrowfelde
    Kingswood
    SS16 5EY Basildon
    Essex
    BritishInsurance Broker50948350002
    GOUGH, John Robert
    Flat 49 New Crane Place
    Wapping
    E1 9TX London
    Amministratore
    Flat 49 New Crane Place
    Wapping
    E1 9TX London
    BritishInsurance Broker45224610001
    HOLLINGWORTH, Stephen
    41 Dunthorpe Road
    CO16 8YN Clacton On Sea
    Essex
    Amministratore
    41 Dunthorpe Road
    CO16 8YN Clacton On Sea
    Essex
    BritishDirector50728410001
    HOWETT, Bryan James
    Northcote Hill Northcote Lane
    Shamley Green
    GU5 0RB Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Northcote Hill Northcote Lane
    Shamley Green
    GU5 0RB Guildford
    Surrey
    EnglandIrishFinance Director105191180001
    HUTCHINSON, Jeremy Mark
    43 Earlsfield Road
    SW18 3DB London
    Amministratore
    43 Earlsfield Road
    SW18 3DB London
    BritishInsurance Broker25016840002
    KHAN, Ferdous Ahmed
    76 Lord Avenue
    Clayhall
    IG5 0HW Ilford
    Essex
    Amministratore
    76 Lord Avenue
    Clayhall
    IG5 0HW Ilford
    Essex
    United KingdomBritishChartered Accountant58530180003
    KNIGHT, Robert Charles
    10 West Close
    Middleton On Sea
    PO22 7RP Bognor Regis
    West Sussex
    Amministratore
    10 West Close
    Middleton On Sea
    PO22 7RP Bognor Regis
    West Sussex
    BritishCompany Director88953210001
    LAMBERT, Donald Mark
    177 Banstead Road
    SM5 4DP Carshalton
    Surrey
    Amministratore
    177 Banstead Road
    SM5 4DP Carshalton
    Surrey
    BritishInsurance Broker99450590001
    MASTERTON, James Andrew
    Poveys Farm
    Ramsdell
    RG26 5SN Tadley
    Hampshire
    Amministratore
    Poveys Farm
    Ramsdell
    RG26 5SN Tadley
    Hampshire
    EnglandBritishInsurance Broker63292320002
    OWEN, David Lionel Godwin
    4 Lower Blackhouse Hill
    CT21 5LS Hythe
    Kent
    Amministratore
    4 Lower Blackhouse Hill
    CT21 5LS Hythe
    Kent
    EnglandBritishInsurance Broker88997320001
    PEERS, Richard Laird
    Woodcote Manor
    Bramdean
    SO24 0LL Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    Woodcote Manor
    Bramdean
    SO24 0LL Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritishInsurance Broker106470370001
    PRENTIS, Henry Barrel
    Flat 7 63 Haverstock Hill
    Hampstead
    NW3 4SL London
    Amministratore
    Flat 7 63 Haverstock Hill
    Hampstead
    NW3 4SL London
    BritishInsurance Broker75274070002
    REA, Brian Patrick
    12 Glebe Road
    Barnes
    SW13 0EA London
    Amministratore
    12 Glebe Road
    Barnes
    SW13 0EA London
    BritishInsurance Broker15474140001
    RIDER, Christopher John
    Elmlake House
    Hall Road
    SS4 1NN Rochford
    Essex
    Amministratore
    Elmlake House
    Hall Road
    SS4 1NN Rochford
    Essex
    United KingdomBritishInsurance Broker88774660001

    PRENTIS DONEGAN & PARTNERS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 20 dic 2002
    Consegnato il 27 dic 2002
    In corso
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each charging company to the chargee acting as agent for national westminster bank PLC on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of variation modyfying the security and trust deed dated 18 sept 1989 (the principal deed) õas modified by a deed of variation dated 29 sept 1993 (the first deed of variation!
    Creato il 20 set 1999
    Consegnato il 30 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of insurance transactions under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw or otherwise required to be paid into an insurance broking account of the company and all approved iba assets of the company (and all assets of the company but for the breach of or failure to observe relevant condition or requirement prescribed under the byelaw) and all debts and obligations for the time being due, owing or incurred to the company in respect of insurance transactions.
    Persone aventi diritto
    • Lloyd's as Trustee for the Creditors
    Transazioni
    • 30 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ago 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 24 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation
    Creato il 29 set 1993
    Consegnato il 19 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For varying terms of the security and trust deed dated 18 september 1989
    Brevi particolari
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw required to be paid into an insurance broking account of the company and all approved iba assets. A second floating charge and subject to all provisisons mutatis mutandis of the security trust deed.
    Persone aventi diritto
    • Lloyd'sd Banks (As Defined in the Byelaw)(a Statutory Corporation) as Trustee for Approve
    Transazioni
    • 19 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ago 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 24 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security and trust deed
    Creato il 18 set 1989
    Consegnato il 23 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of insurance transactions under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of or pursuant to lloyd's brokers byelaw (no. 5 of 1988) (for full details see from 295).
    Persone aventi diritto
    • Lloyd'S.
    Transazioni
    • 23 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ago 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 24 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PRENTIS DONEGAN & PARTNERS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 nov 2012Data di scioglimento
    22 nov 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian Martin Tuite
    Broughton Tuite Tan & Co
    168-172 Old Street
    EC1V 9BP London
    Praticante
    Broughton Tuite Tan & Co
    168-172 Old Street
    EC1V 9BP London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0