EUROHIKE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEUROHIKE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00502385
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EUROHIKE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova EUROHIKE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o KPMG LLP
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EUROHIKE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    R.& A.MILLETT(SHOPS)LIMITED15 dic 195115 dic 1951

    Quali sono gli ultimi bilanci di EUROHIKE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al26 feb 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per EUROHIKE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 14 dic 2012

    21 pagine2.24B
    A20C6997

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 02 gen 2013

    21 pagine2.35B
    A1ZENC6X

    Risultato della riunione dei creditori

    28 pagine2.23B
    A1NYD3WJ

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 08 lug 2012

    18 pagine2.24B
    A1EI9RIZ

    Risultato della riunione dei creditori

    30 pagine2.23B
    A15B1A17

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    25 pagine2.17B
    A14NWHKJ

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    8 pagine2.16B
    A13AVTMX

    Indirizzo della sede legale modificato da 440-450 Cob Drive Swan Valley Northampton Northamtonshire NN4 9BB in data 24 gen 2012

    2 pagineAD01
    A10XR88Y

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B
    A10AI0PK

    Cessazione della carica di Marcello Lombardo come amministratore in data 16 dic 2011

    1 pagineTM01
    X0OAKAJL

    Nomina di Dominic Joseph Lavelle come amministratore in data 21 nov 2011

    2 pagineAP01
    XED8XZG8

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 ott 2011

    Stato del capitale al 03 ott 2011

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01
    XXBCRY28

    Conto per una società dormiente redatto al 26 feb 2011

    4 pagineAA
    L50UAWSI

    Nomina di Ms Julia Reynolds come amministratore

    2 pagineAP01
    XDA34WCZ

    Cessazione della carica di Richard Hitt come amministratore

    1 pagineTM01
    XMTATU7G

    Nomina di Mr Mark Derrick Beacham come amministratore

    2 pagineAP01
    XMTARU7E

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    XHSFFNVI

    Conto per una società dormiente redatto al 27 feb 2010

    4 pagineAA
    AANYEL6A

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    PTLJVFPL

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04
    ANTQ0E3X

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    XMXNTE5F

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard John Hitt il 01 ott 2009

    2 pagineCH01
    XMXNSE5E

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Mark Derrick Beacham il 01 ott 2009

    3 pagineCH03
    APY7WDYB

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Marcello Lombardo il 01 ott 2009

    3 pagineCH01
    APY7HDYW

    Chi sono gli amministratori di EUROHIKE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BEACHAM, Mark Derrick
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    Segretario
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    British135313320001
    BEACHAM, Mark Derrick
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    Amministratore
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    United KingdomBritishCompany Secretary160095260001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    Amministratore
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    United KingdomBritishFinance Director137285750001
    REYNOLDS, Julia
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    Amministratore
    c/o Kpmg Llp
    St James's Square
    M2 6DS Manchester
    EnglandBritishChief Executive127468460001
    FOOT, Peter John Lewis
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    Segretario
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    British51176110002
    HALL, Vikki
    28 Burman Drive
    Coleshill
    B46 3NB Birmingham
    Segretario
    28 Burman Drive
    Coleshill
    B46 3NB Birmingham
    British82602670001
    HEATHER, John Langdale
    32 Beauchamp Avenue
    CV32 5TA Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    32 Beauchamp Avenue
    CV32 5TA Leamington Spa
    Warwickshire
    British33307810001
    O'KEEFFE, Mark John
    5 Fowey Close
    NN8 5WW Wellingborough
    Northamptonshire
    Segretario
    5 Fowey Close
    NN8 5WW Wellingborough
    Northamptonshire
    British57880430001
    PILLAY, Paul Vijayasingam
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    Segretario
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    OtherHead Of Finance & Company Secr79416150001
    SIMKINS, Paul Charles
    49 Hazel Crescent
    NN12 6UQ Towcester
    Northamptonshire
    Segretario
    49 Hazel Crescent
    NN12 6UQ Towcester
    Northamptonshire
    British37115350001
    SEARS SPORTS AND LEISUREWEAR PLC
    Sunningdale Road
    LE3 1TP Leicester
    Segretario
    Sunningdale Road
    LE3 1TP Leicester
    16600870001
    ASTLEY, Brian Martin
    25 Marjorie Grove
    SW11 5SH London
    Amministratore
    25 Marjorie Grove
    SW11 5SH London
    BritishDirector75795040001
    CHAMBERLAIN, Adrian
    Butlers Hall
    Wareside
    SG12 7QL Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    Butlers Hall
    Wareside
    SG12 7QL Ware
    Hertfordshire
    BritishDirector117106730001
    CROSLAND, Roy Nicholson
    35 Addison Avenue
    W11 4QS London
    Amministratore
    35 Addison Avenue
    W11 4QS London
    BritishDirector30882970002
    FALLON, John Edward
    Gardeners Cottage Old Hall Drive
    Widmerpool Keyworth
    NG12 5PZ Nottingham
    Amministratore
    Gardeners Cottage Old Hall Drive
    Widmerpool Keyworth
    NG12 5PZ Nottingham
    BritishDirector52124910001
    FLEMING, Keith
    Brookmead House
    The Warren, East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Brookmead House
    The Warren, East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritishDirector112723440002
    FOOT, Peter John Lewis
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    BritishCompany Director51176110002
    HARDY, Russell Stephen Mons
    The Reddings
    Langley Road, Claverdon
    CV35 8P Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    The Reddings
    Langley Road, Claverdon
    CV35 8P Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritishChief Executive45844210003
    HARTLEY, Peter Christopher
    17 Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    Amministratore
    17 Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    United KingdomBritishFinance Director96458190001
    HITT, Richard John
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamtonshire
    Amministratore
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamtonshire
    United KingdomBritishBusiness Analysis & Insight127468180001
    JONES, Anthony David
    32 Howe Lane
    LE7 7LB Rothley
    Leicestershire
    Amministratore
    32 Howe Lane
    LE7 7LB Rothley
    Leicestershire
    BritishDirector41640680002
    LOASBY, Andrew
    11 Nene Close
    NN8 5WB Wellingborough
    Northamptonshire
    Amministratore
    11 Nene Close
    NN8 5WB Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishDirector48081840001
    LOMBARDO, Marcello
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamtonshire
    Amministratore
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamtonshire
    EnglandBritishFinance Director135699240001
    MALONE, Desmond Philip
    1 Morpeth
    B77 1JF Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    1 Morpeth
    B77 1JF Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector87170450001
    MAYWOOD, Terry Osborn
    Longston House
    School Lane Islip
    NN14 3LQ Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    Longston House
    School Lane Islip
    NN14 3LQ Kettering
    Northamptonshire
    BritishRetail Director39631730004
    MEEHAN, Andrew David
    Southview Church Lane
    Lighthorne
    CV35 0AT Warwick
    Amministratore
    Southview Church Lane
    Lighthorne
    CV35 0AT Warwick
    EnglandBritishDirector62737150001
    SHEATH, Christopher Gordon
    Avonlea
    Hop Gardens, Whiteparish
    SP5 2SS Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Avonlea
    Hop Gardens, Whiteparish
    SP5 2SS Salisbury
    Wiltshire
    BritishFinance Director69543550002
    STAINES, Michael John
    4 Fleetwind Drive
    NN4 0ST Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Fleetwind Drive
    NN4 0ST Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector16626330001
    VICKERS, Alan Christopher
    The Ashes 8 Cross Hedge
    Rothley
    LE7 7RR Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    The Ashes 8 Cross Hedge
    Rothley
    LE7 7RR Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector1971520001

    EUROHIKE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 04 mar 1996
    Consegnato il 13 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All liabilities and obligations due or to become due from the company and any group company to the chargees pursuant to the terms of the hedging arrangements and the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 13 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 lug 1986
    Consegnato il 10 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 10,12,14,16 car street, ipswich and/or proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 06 giu 1986
    Consegnato il 10 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold 17-18 high street, colchester and/or proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 mag 1986
    Consegnato il 19 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises known as unit 49 arndale centre manchester and/or proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 09 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 mag 1986
    Consegnato il 30 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property known as 24 market square, northampton and/or proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 09 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 feb 1986
    Consegnato il 27 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    29 linthorpe road middlesborough cleveland and/or the proceeds of sale thereof, together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 31 gen 1986
    Consegnato il 04 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 35 union street, birmingham and/or proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 17 gen 1986
    Consegnato il 23 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 105 market jew street, penzance, cornwall, t/no cl 22334 and/or proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 nov 1985
    Consegnato il 04 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 24 cricklade street, cirencester and/or proceeds of thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 01 nov 1985
    Consegnato il 07 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H shop unit 1, 66/82 the broadway west ealing london and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 01 nov 1985
    Consegnato il 07 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 193 high st, bromley kent, and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 01 nov 1985
    Consegnato il 07 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 21 friary st, guildford surrey, and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 nov 1985
    Consegnato il 07 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 50, 52 & 54 high street and 53, 54 surrey street, croydon and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 27 ago 1985
    Consegnato il 29 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 6 market street, york and/or the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 16 ago 1985
    Consegnato il 19 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 49 market street crewe and/or the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 12 ago 1985
    Consegnato il 14 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 53 sedney street cambridge and/or the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 07 ago 1985
    Consegnato il 09 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 146 high street, erdington and/or the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 07 ago 1985
    Consegnato il 09 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 82/84 mersey way stockport and/or the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 07 ago 1985
    Consegnato il 14 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 16 new street, huddersfield and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 16 lug 1985
    Consegnato il 18 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H. 25 the mall shopping centre. Burnley and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 29 giu 1985
    Consegnato il 10 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Lh 86/88 high street, watford and the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 29 giu 1985
    Consegnato il 10 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Lh 16 market place and 5 dolphin lane and the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 25 giu 1985
    Consegnato il 27 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Lh 71 london road north lowestoft, suffolk and the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 09 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 giu 1985
    Consegnato il 27 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Lh 26 st. Andrews street, cambridge and the proceeds.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 17 giu 1985
    Consegnato il 20 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 28-30 strait bargate, boston and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1985Registrazione di un'ipoteca

    EUROHIKE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 gen 2013Fine dell'amministrazione
    09 gen 2012Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praticante
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    David James Costley-Wood
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    Praticante
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0