MONTCO NOMINEES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MONTCO NOMINEES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00503419 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MONTCO NOMINEES LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova MONTCO NOMINEES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | GRIFFINS Tavistock House South Tavistock Square WC1H 9LG London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di MONTCO NOMINEES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 ott 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per MONTCO NOMINEES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 18 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 100 Bishopsgate London EC2N 4AA United Kingdom a Tavistock House South Tavistock Square London WC1H 9LG in data 16 giu 2022 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 7 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2021 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ms Caroline Mccann come amministratore in data 01 apr 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Karen Jane Harris-Busch come amministratore in data 01 apr 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Rachel Vickery come segretario in data 23 feb 2022 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Siobhan Majella Dowdall come segretario in data 23 feb 2022 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 gen 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2020 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 gen 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Ms Siobhan Majella Dowdall come segretario in data 04 gen 2021 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mirabelle Osaro come segretario in data 02 nov 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2019 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Riverbank House 2 Swan Lane London EC4R 3BF a 100 Bishopsgate London EC2N 4AA in data 22 giu 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Miss Mirabelle Osaro come segretario in data 10 dic 2019 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Siobhan Majella Dowdall come segretario in data 10 dic 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mrs Karen Jane Harris-Busch come amministratore in data 27 giu 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Raymond Anthony Fletcher come amministratore in data 27 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MONTCO NOMINEES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICKERY, Rachel | Segretario | Tavistock Square WC1H 9LG London Tavistock House South | 292846570001 | |||||||
| KINSELEY, Nicholas | Amministratore | Tavistock Square WC1H 9LG London Tavistock House South | England | British | 230333410001 | |||||
| MCCANN, Caroline | Amministratore | Tavistock Square WC1H 9LG London Tavistock House South | Scotland | Irish | 216985280001 | |||||
| ADEJUMO, Oluremi | Segretario | 2 Swan Lane EC4R 3BF London Riverbank House United Kingdom | 154951840001 | |||||||
| ADEJUMO, Oluremi Temitope | Segretario | 90 Dursley Road Blackheath SE3 8PG London | British | 121555550001 | ||||||
| BIRKS, Charlotte | Segretario | 2 Swan Lane EC4R 3BF London Riverbank House | 220435450001 | |||||||
| BUTTERWORTH, Adrian | Segretario | 98 Whitley Close TW19 7EY Staines Middlesex | British | 66882030001 | ||||||
| COATMAN, Helen Joanna | Segretario | 197 Hanging Hill Lane Hutton CM13 2QG Brentwood Essex | British | 91617040002 | ||||||
| DOWDALL, Siobhan Majella | Segretario | Bishopsgate EC2N 4AA London 100 United Kingdom | 278346380001 | |||||||
| DOWDALL, Siobhan Majella | Segretario | 2 Swan Lane EC4R 3BF London Riverbank House | 250449090001 | |||||||
| OSARO, Mirabelle | Segretario | Bishopsgate EC2N 4AA London 100 United Kingdom | 265805640001 | |||||||
| RICHARDSON, Alex | Segretario | 2 Swan Lane EC4R 3BF London Riverbank House England | 243993450001 | |||||||
| RICHARDSON, Martin | Segretario | 71 Queen Victoria Street London EC4V 4DE | 149957670001 | |||||||
| ROWAN-HAMILTON, Charles John Hamilton | Segretario | 15 Foskett Road SW6 3LY London | British | 30658800003 | ||||||
| SHAH, Farhat | Segretario | Flat 2/2, 8 Grantley Gardens Shawlands G41 3QA Glasgow | British | 101169780001 | ||||||
| BELLHOUSE, Suzanne Margaret | Amministratore | 145 Worlds End Lane BR6 6AN Chelsfield Kent | British | 32542540001 | ||||||
| BROWN, Cortland Scott | Amministratore | Beechcroft Holly Bank Road KT14 6JS West Byfleet Surrey | Canadian | 39419830002 | ||||||
| CAVE, Gregory Miles | Amministratore | 6 The Larches GU21 4RE Woking Surrey | British | 89925150001 | ||||||
| CUTTS, Philip Martin | Amministratore | 71 Queen Victoria Street London EC4V 4DE | England | British | 60999500001 | |||||
| CUTTS, Philip Martin | Amministratore | 65 Cole Park Road TW1 1HT Twickenham Middlesex | England | British | 60999500001 | |||||
| EDWARDS, Alan Charles | Amministratore | 111 Birling Avenue Bearsted ME14 4LL Maidstone Kent | England | English | 2911550001 | |||||
| EGAN, Pauline Fidelis Mary | Amministratore | 2 Swan Lane EC4R 3BF London Riverbank House United Kingdom | England | Irish | 66794750002 | |||||
| FLANAGAN, Kevin Marshall | Amministratore | 71 Queen Victoria Street London EC4V 4DE | England | Canadian | 121787390002 | |||||
| FLETCHER, Timothy Raymond Anthony | Amministratore | 2 Swan Lane EC4R 3BF London Riverbank House | England | British | 78406720001 | |||||
| FRANKS, Kate Tamar | Amministratore | 12 Gordon Avenue St Margarets TW1 1NQ Twickenham Middlesex | British | 76161900001 | ||||||
| GALE, Pauline Audrey | Amministratore | Crosier Close SE3 8NT Blackheath 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 133445630001 | |||||
| GOWDY, Barry Anthony | Amministratore | 2 Swan Lane EC4R 3BF London Riverbank House United Kingdom | United Kingdom | British | 88984400002 | |||||
| HARRIS-BUSCH, Karen Jane | Amministratore | Bishopsgate EC2N 4AA London 100 United Kingdom | England | British | 260568920001 | |||||
| JONES, Clare Elizabeth | Amministratore | 36 Hawthorn Way AL2 3BQ St Albans Hertfordshire | British | 59669640003 | ||||||
| KELLER-HOBSON, Donald Stephen Douglas | Amministratore | 18 Scarsdale Villas W8 6PR London | Canadian | 36228770002 | ||||||
| LUCHINI, Francis Gerard | Amministratore | 9 Hollis Lock CM2 6RR Chelmsford Essex | United Kingdom | British | 51808440001 | |||||
| MOODY, Patricia Joan | Amministratore | 8 Riverdene HA8 9TD Edgware Middlesex | British | 5286990001 | ||||||
| ROBINS, Andrew Stephen | Amministratore | 2 Swan Lane EC4R 3BF London Riverbank House | United Kingdom | British | 203150010001 | |||||
| SCOTT, Richard Herbert | Amministratore | 31 Beaulieu Close Datchet SL3 9DD Slough Berkshire | British | 2911570001 | ||||||
| STOKES, Kevin David | Amministratore | 2 Swan Lane EC4R 3BF London Riverbank House United Kingdom | England | British | 100772250001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MONTCO NOMINEES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank Of Canada Holdings (U.K.) Limited | 06 apr 2016 | Swan Lane EC4R 3BF London Riverbank House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MONTCO NOMINEES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 26 giu 2014 Consegnato il 02 lug 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 17 ott 2013 Consegnato il 19 ott 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 20 dic 2007 Consegnato il 29 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 11 egerton place london with all fixtures assigns all rents fixed charge on all insurances relating to the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 20 dic 2007 Consegnato il 29 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 11 tregunter road london with all fixtures assigns all rents fixed charge on all insurances relating to the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over securities | Creato il 15 giu 2007 Consegnato il 29 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each borrower and the company to the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Right, title and interest in all securities, all related rights and all property and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage of shares | Creato il 22 dic 2004 Consegnato il 04 gen 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from each obligr to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The secured liabilities and all shares and all related rights thereon; any dividend or interest paid and any right,money or property accruing. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
MONTCO NOMINEES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0