KUNICK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKUNICK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00506827
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KUNICK LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova KUNICK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o GRANT THORNTON UK LLP
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KUNICK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KUNICK PLC25 ago 198725 ago 1987
    KUNICK LEISURE GROUP PLC24 mag 198424 mag 1984
    KUNICK HOLDINGS PLC09 apr 195209 apr 1952

    Quali sono gli ultimi bilanci di KUNICK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per KUNICK LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per KUNICK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    27 pagine4.72

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 03 apr 2013

    29 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    32 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    87 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Leisure Connection Ltd Potton House Great North Road Wyboston Bedford MK44 3BA United Kingdom* in data 15 nov 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    3 pagineMG04

    legacy

    3 pagineMG04

    legacy

    3 pagineMG04

    Indirizzo della sede legale modificato da * Low Lane Horsforth Leeds LS18 4ER* in data 03 ago 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    19 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG04

    legacy

    3 pagineMG04

    legacy

    3 pagineMG04

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 apr 2012

    Stato del capitale al 19 apr 2012

    • Capitale: GBP 24,049,359.85
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Derek Lloyd come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr Julian Frederick Nicholls come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Mr Richard Matthew Still come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Paul Meehan come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    20 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di KUNICK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STILL, Richard Matthew
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant71581460002
    NICHOLLS, Julian Frederick
    c/o Danoptra Limited
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    c/o Danoptra Limited
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishNone95086050001
    STILL, Richard Matthew
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    Amministratore
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector71581460002
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    BURNETT, Christopher Thomas
    Moorfield Rombalds Lane
    Ben Rhydding
    LS29 8RT Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Moorfield Rombalds Lane
    Ben Rhydding
    LS29 8RT Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director905440001
    CAMPBELL, Paul Adam
    4 Estelle Road
    Hampstead
    NW3 2JY London
    Amministratore
    4 Estelle Road
    Hampstead
    NW3 2JY London
    BritishDirector53606250001
    DANIELS, Colin
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    BritishDirector1278190001
    HONEYBORNE, Christopher Henry Bruce, Dr
    Scawton Croft
    Rievaulx
    YO62 5LE York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Scawton Croft
    Rievaulx
    YO62 5LE York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director90021860001
    HUDD, David Leslie
    Flat D
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    Amministratore
    Flat D
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    EnglandBritishDirector26032950005
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant35569170001
    LLOYD, Derek Thomas
    55 Westerdale Drive
    Banks
    PR9 8DG Southport
    Merseyside
    Amministratore
    55 Westerdale Drive
    Banks
    PR9 8DG Southport
    Merseyside
    United KingdomBritishDirector98695040001
    MAWSON, Eric Peter
    Crimple Brow
    Hillfoot Lane Pannal
    HG3 1NY Harrogate
    North Yorksh
    Amministratore
    Crimple Brow
    Hillfoot Lane Pannal
    HG3 1NY Harrogate
    North Yorksh
    BritishRetired Solicitor15622760001
    MEEHAN, Paul Alan
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector130608590001
    MELLOR, David Glynn
    Fieldhead
    92 Victoria Road
    HX5 0QF Elland
    West Yorkshire
    Amministratore
    Fieldhead
    92 Victoria Road
    HX5 0QF Elland
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director57198790001
    SIMONDS-GOODING, Anthony James Joseph
    Burchetts Brook
    Holmbury St Mary
    RH5 6NA Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Burchetts Brook
    Holmbury St Mary
    RH5 6NA Dorking
    Surrey
    BritishDirector50867110002
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant142125320001
    SMITH, Russell Stansfield
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    Amministratore
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    BritishEngineer809230004
    TAYLOR-CLAGUE, Albert Clive
    Swindon Hall Swindon Lane
    Kirkby Overblow
    HG3 1HR Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Swindon Hall Swindon Lane
    Kirkby Overblow
    HG3 1HR Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector36517460001
    DANOPTRA DIRECTOR I LIMITED
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Yorkshire
    125899680001
    DANOPTRA DIRECTOR II LIMITED
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Yorkshire
    125899730001

    KUNICK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debentures
    Creato il 19 ago 2008
    Consegnato il 21 ago 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse, London Branch (Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 03 nov 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 22 may 2002 and
    Creato il 13 ago 2002
    Consegnato il 22 ago 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee and/or the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a main warehouse, low lane, horsfield, leeds t/no. WYK588050 and f/h property k/a miles warehouse, low lane, horsfield, leeds t/no. WYK48128. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 03 nov 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 13 ago 2002
    Consegnato il 21 ago 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the security trustee and/or the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all that freehold property known as main warehouse, low lane, horsfield, leeds t/n WYK588050. All that freehold property known as miles warehouse, low lane, horsfield, leeds t/n WYK48128, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 03 nov 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Creato il 13 ago 2002
    Consegnato il 21 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (I) policy no L019603301 for £1,000,000 over life of colin daniels and (ii) policy no L0190923001 for £1,000,000 over life of john graham jones; all monies payable including bonuses thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 1995
    Consegnato il 05 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargees; as trustees for the stockholders (as defined in the loan stock contained in an agreement of even date) on any account whatsoever and any liability arising under the agreement
    Brevi particolari
    504,000 ordinary shares of 10P each comprising the whole of the issued share capital of relaxion group PLC (the shares) and all allotments benefits and advantages etc. accrued offered or arising in respect of the same whether by way of bonus, preference, option, redemption or concession or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • John Francis Mcginley
    • Robert William Ring
    • Paul Adam Campbell
    Transazioni
    • 05 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 12 ott 1992
    Consegnato il 21 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in "the debenture"
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of leen gate,lenton,nottingham title number nt 199170 see doc ref M551C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcin Its Capacity as Agent and Trustee for Itselfand Each of the Banks
    Transazioni
    • 21 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 mar 1991
    Consegnato il 20 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the financing documents and the security documents. (As defined).
    Brevi particolari
    Various properties as specified in form 395 ref M72.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC.(For Itself National Westminster Bank PLC. and the Govenor and Company of the Bank of Scotland).
    Transazioni
    • 20 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 17 dic 1990
    Consegnato il 21 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts and uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 28 mar 1984
    Consegnato il 28 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 1 normanby road scunthorpe t/n:- hs 80015.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 01 mar 1984
    Consegnato il 08 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1983
    Consegnato il 10 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H the farringford hotel, freshwater bay, isle of wight.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 nov 1983Registrazione di un'ipoteca

    KUNICK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 nov 2012Inizio dell'amministrazione
    03 apr 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DataTipo
    03 apr 2013Inizio della liquidazione
    12 mag 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0