THE OUTDOOR GROUP LIMITED

THE OUTDOOR GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE OUTDOOR GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00507794
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE OUTDOOR GROUP LIMITED?

    • Commercio al dettaglio di abbigliamento in negozi specializzati (47710) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio al dettaglio di calzature in negozi specializzati (47721) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova THE OUTDOOR GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o KPMG LLP
    St. James's Square
    M2 6DS Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE OUTDOOR GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE OUTDOOR GROUP (TRADING) LIMITED05 mar 199905 mar 1999
    THE OUTDOOR GROUP LIMITED05 mar 199705 mar 1997
    MILLETS LEISURE LIMITED12 gen 198712 gen 1987
    MILLETS OF BRISTOL LIMITED25 ott 198425 ott 1984
    MILLETS OF BRISTOL (HOLDINGS) LIMITED09 mag 195209 mag 1952

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE OUTDOOR GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 feb 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per THE OUTDOOR GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    0 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 25 giu 2013

    22 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 mag 2013

    23 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 nov 2012

    25 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    25 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 08 lug 2012

    26 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    43 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    43 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    15 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da 440-450 Cob Drive Swan Valley Northampton NN4 9BB in data 12 gen 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Marcello Lombardo come amministratore in data 16 dic 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Dominic Joseph Lavelle come amministratore in data 21 nov 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 ott 2011

    Stato del capitale al 03 ott 2011

    • Capitale: GBP 9,110,001
    SH01

    Cessazione della carica di Neil Gillis come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Julia Reynolds come amministratore

    2 pagineAP01

    Memorandum e Statuto

    39 pagineMA

    Chi sono gli amministratori di THE OUTDOOR GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BEACHAM, Mark Derrick
    c/o Kpmg Llp
    St. James's Square
    M2 6DS Manchester
    Segretario
    c/o Kpmg Llp
    St. James's Square
    M2 6DS Manchester
    British135313320001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    c/o Kpmg Llp
    St. James's Square
    M2 6DS Manchester
    Amministratore
    c/o Kpmg Llp
    St. James's Square
    M2 6DS Manchester
    United KingdomBritish137285750001
    REYNOLDS, Julia
    c/o Kpmg Llp
    St. James's Square
    M2 6DS Manchester
    Amministratore
    c/o Kpmg Llp
    St. James's Square
    M2 6DS Manchester
    EnglandBritish127468460001
    FOOT, Peter John Lewis
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    Segretario
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    British51176110002
    HEATHER, John Langdale
    32 Beauchamp Avenue
    CV32 5TA Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    32 Beauchamp Avenue
    CV32 5TA Leamington Spa
    Warwickshire
    British33307810001
    O'KEEFFE, Mark John
    5 Fowey Close
    NN8 5WW Wellingborough
    Northamptonshire
    Segretario
    5 Fowey Close
    NN8 5WW Wellingborough
    Northamptonshire
    British57880430001
    PILLAY, Paul Vijayasingam
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    Segretario
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    Other79416150001
    REECE, David Alexander
    6 Plough Steep
    Main Road Itchen Abbas
    SO21 1BQ Winchester
    Hampshire
    Segretario
    6 Plough Steep
    Main Road Itchen Abbas
    SO21 1BQ Winchester
    Hampshire
    British37124410001
    SIMKINS, Paul Charles
    49 Hazel Crescent
    NN12 6UQ Towcester
    Northamptonshire
    Segretario
    49 Hazel Crescent
    NN12 6UQ Towcester
    Northamptonshire
    British37115350001
    SEARS SPORTS AND LEISUREWEAR PLC
    Sunningdale Road
    LE3 1TP Leicester
    Segretario
    Sunningdale Road
    LE3 1TP Leicester
    16600870001
    ASTLEY, Brian Martin
    Woodend Farmhouse
    Woodend
    SL7 2HW Medmenham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Woodend Farmhouse
    Woodend
    SL7 2HW Medmenham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish75795040002
    ASTLEY, Brian Martin
    25 Marjorie Grove
    SW11 5SH London
    Amministratore
    25 Marjorie Grove
    SW11 5SH London
    British75795040001
    BENTLEY, Simon Anthony
    Glen Wood House
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    Amministratore
    Glen Wood House
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    United KingdomBritish3007630001
    CLIFFE, Nigel John
    40 Queens Avenue
    N10 3NR London
    Amministratore
    40 Queens Avenue
    N10 3NR London
    British60195630001
    COOPER, Andrea
    23b Green Lane
    Wootton
    NN4 6LH Northampton
    Amministratore
    23b Green Lane
    Wootton
    NN4 6LH Northampton
    British106515750002
    CROSLAND, Roy Nicholson
    35 Addison Avenue
    W11 4QS London
    Amministratore
    35 Addison Avenue
    W11 4QS London
    British30882970002
    DAWSON, Nicola Marie
    The Greys
    The Green, Cavendish
    CO10 8BB Sudbury
    Suffolk
    Amministratore
    The Greys
    The Green, Cavendish
    CO10 8BB Sudbury
    Suffolk
    British127468760001
    FALLON, John Edward
    Gardeners Cottage Old Hall Drive
    Widmerpool Keyworth
    NG12 5PZ Nottingham
    Amministratore
    Gardeners Cottage Old Hall Drive
    Widmerpool Keyworth
    NG12 5PZ Nottingham
    British52124910001
    FERGUSON, Fiona Claire
    Cleveland Cottage
    Main Street
    NG23 5BA Claypole
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Cleveland Cottage
    Main Street
    NG23 5BA Claypole
    Nottinghamshire
    British55116100001
    FLEMING, Keith
    Brookmead House
    The Warren, East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Brookmead House
    The Warren, East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish112723440002
    FORREST, Annabel
    1 Henderson Road
    Wandsworth Common
    SW18 3RR London
    Amministratore
    1 Henderson Road
    Wandsworth Common
    SW18 3RR London
    British85480920001
    FORREST, Annabel Claire
    35 Louisville Road
    SW17 8RL London
    Amministratore
    35 Louisville Road
    SW17 8RL London
    British42978640002
    GILLIS, Neil Duncan
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Amministratore
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    EnglandBritish69204500003
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    HARDY, Russell Stephen Mons
    The Reddings
    Langley Road, Claverdon
    CV35 8P Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    The Reddings
    Langley Road, Claverdon
    CV35 8P Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish45844210003
    HARTLEY, Peter Christopher
    17 Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    Amministratore
    17 Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    United KingdomBritish96458190001
    HERRICK, Susan Elizabeth
    4 Lower Paxton Road
    AL1 1PG St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Lower Paxton Road
    AL1 1PG St. Albans
    Hertfordshire
    British115256820001
    HITT, Richard John
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Amministratore
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    United KingdomBritish127468180001
    HOBBS, Sebastian
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Amministratore
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    United KingdomBritish124410620002
    JOHNSON, Allan
    11 Squarey Street
    SW17 0AB London
    Amministratore
    11 Squarey Street
    SW17 0AB London
    British106521530001
    JONES, Anthony David
    32 Howe Lane
    LE7 7LB Rothley
    Leicestershire
    Amministratore
    32 Howe Lane
    LE7 7LB Rothley
    Leicestershire
    British41640680002
    KERR-MUIR, James Rodier
    Flat 8 71 Elm Park Gardens
    SW10 9QE London
    Amministratore
    Flat 8 71 Elm Park Gardens
    SW10 9QE London
    British37895700002
    LOASBY, Andrew
    11 Nene Close
    NN8 5WB Wellingborough
    Northamptonshire
    Amministratore
    11 Nene Close
    NN8 5WB Wellingborough
    Northamptonshire
    British48081840001
    LOMBARDO, Marcello
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Amministratore
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    EnglandBritish135699240001
    LOVELOCK, Derek John
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116560620001

    THE OUTDOOR GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A rent deposit
    Creato il 18 mag 2010
    Consegnato il 26 mag 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The amount from time to time standing to the credit of the tenant in an account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Crown Estate Commisioners on Behalf of Her Majesty Acting in Exercise of the Powers Conferred by the Crown Estate Act 1961
    Transazioni
    • 26 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 02 nov 2009
    Consegnato il 06 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 feb 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Charge of deposit
    Creato il 18 feb 2009
    Consegnato il 24 feb 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 39446298 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 07 dic 1999
    Consegnato il 14 dic 1999
    In corso
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities ( whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or as principal debtor, guarantor, surety or otherwise or as the equivalent obligor under the laws of any other jurisdiction) of each obligor to the security trustee and the secured parties
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Security Trustee for Itself and for Each of the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 04 mar 1996
    Consegnato il 13 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All liabilities and obligations due or to become due from the company and any group company to the chargees pursuant to the terms of the hedging arrangements and the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 13 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 05 apr 1979
    Consegnato il 07 apr 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £35,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee and/or john leopdd spiedmon on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    F/H property known as 3 and 5 king st., Ramsgate kent title no. K 410666.
    Persone aventi diritto
    • Hambro Provident Assurance
    Transazioni
    • 07 apr 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 05 dic 1978
    Consegnato il 12 dic 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H. 9 high street, banbury, oxford. Together with allfixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 15 nov 1978
    Consegnato il 23 nov 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land & premises being 2 ainsworth st. Blackburn together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 23 nov 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 21 set 1977
    Consegnato il 29 set 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property known as: 56/57, biggin street, dover together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Samuel & Montagu Co.
    Transazioni
    • 29 set 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 20 apr 1977
    Consegnato il 28 apr 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H lands & premises being: 205 high street, lewisham, together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 20 apr 1977
    Consegnato il 28 apr 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H lands & premises at rear of 205 high street, lewisham, together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 gen 1977
    Consegnato il 03 feb 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £35,000
    Brevi particolari
    Shop & other buildings being 104, east street, southampton, hants.
    Persone aventi diritto
    • Bristol & West Building Society.
    Transazioni
    • 03 feb 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 01 nov 1976
    Consegnato il 03 nov 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    31 & 33 friagate walk preston together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 03 nov 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 01 nov 1976
    Consegnato il 03 nov 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    10I/104 queen street cardiff together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 03 nov 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 01 nov 1976
    Consegnato il 03 nov 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2, ainsworth street blackburn together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 03 nov 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 13 feb 1976
    Consegnato il 24 feb 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    19/20 the rhiw bridgent tog. With all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 13 feb 1976
    Consegnato il 24 feb 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    102/104 queen street, cardiff tog. With all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 13 feb 1976
    Consegnato il 03 nov 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    19/20 the rhiw bridgend together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 03 nov 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 18 set 1974
    Consegnato il 24 set 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land heredits and premises being 31 & 33 friargate walk, preston (together with all fixtures etc.).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 lug 1973
    Consegnato il 09 ago 1973
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due, etc.
    Brevi particolari
    Units 9 & 10 the hampshires centre, bournemouth, hants together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1973Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 lug 1973
    Consegnato il 08 ago 1973
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Shop unit no. 2 86/88 above bar street, southampton and all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Finance Corporation LTD.
    Transazioni
    • 08 ago 1973Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 lug 1973
    Consegnato il 08 ago 1973
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    140A commercial street, newport, monmouth and all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Finance Corporation LTD.
    Transazioni
    • 08 ago 1973Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 lug 1973
    Consegnato il 08 ago 1973
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    10 northgate street, gloucester and all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Finance Corporation LTD.
    Transazioni
    • 08 ago 1973Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 lug 1973
    Consegnato il 08 ago 1973
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 the shopping centre, 2 & 3 south street, dorchester and all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Finance Corportion LTD.
    Transazioni
    • 08 ago 1973Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 lug 1973
    Consegnato il 08 ago 1973
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Shop unit no. 2, 5 foee street, poridgwater, somerset and all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Finance Corporation LTD.
    Transazioni
    • 08 ago 1973Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    THE OUTDOOR GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 nov 2009Data della riunione per approvare il CVA
    22 dic 2010Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian Green
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DataTipo
    09 gen 2012Inizio dell'amministrazione
    25 giu 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praticante
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    David James Costley-Wood
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    Praticante
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0