WGL REALISATIONS 2010 LIMITED

WGL REALISATIONS 2010 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWGL REALISATIONS 2010 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00510283
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WGL REALISATIONS 2010 LIMITED?

    • (2811) /
    • (2875) /
    • (4534) /
    • (5114) /

    Dove si trova WGL REALISATIONS 2010 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o KPMG LLP
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WGL REALISATIONS 2010 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WELCONSTRUCT GROUP LIMITED17 feb 200417 feb 2004
    GRIMMITT HOLDINGS LIMITED05 ago 198805 ago 1988
    GRIMMITT FINANCE (HOLDINGS) LIMITED21 giu 198221 giu 1982
    WELCONSTRUCT COMPANY LIMITED(THE)02 ago 195202 ago 1952

    Quali sono gli ultimi bilanci di WGL REALISATIONS 2010 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per WGL REALISATIONS 2010 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 mar 2016

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 set 2015

    20 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 set 2015

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 mar 2015

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 mar 2014

    20 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 set 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 mar 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 set 2013

    21 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 set 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 mar 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 set 2012

    22 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 set 2012

    7 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 mar 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 set 2011

    24 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    24 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 set 2011

    6 pagine4.68

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    22 pagine2.34B

    Cessazione della carica di Frank Lewis come amministratore

    2 pagineTM01

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    21 pagine2.34B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed welconstruct group LIMITED\certificate issued on 10/08/10
    2 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name10 ago 2010

    Risoluzione di cambio di nome della società il 04 ott 2009

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Chi sono gli amministratori di WGL REALISATIONS 2010 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOORE, Duncan James, Mr.
    Atherstone-On-Stour
    CV37 8NE Stratford On Avon
    River House
    Warwickshire
    Segretario
    Atherstone-On-Stour
    CV37 8NE Stratford On Avon
    River House
    Warwickshire
    BritishCompany Director78671940004
    KENRICK, Christine
    September House
    DY10 4QE Wood Row
    Worcestershire
    Amministratore
    September House
    DY10 4QE Wood Row
    Worcestershire
    BritishChairman9905930005
    MOORE, Duncan James, Mr.
    Atherstone-On-Stour
    CV37 8NE Stratford On Avon
    River House
    Warwickshire
    Amministratore
    Atherstone-On-Stour
    CV37 8NE Stratford On Avon
    River House
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director78671940004
    REEVE, Adrian
    Stone Meadow
    OX2 6TD Oxford
    95
    Oxfordshire
    Amministratore
    Stone Meadow
    OX2 6TD Oxford
    95
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director91896330002
    EVERITT, David William
    4 Swale Road
    Walmley
    B76 2BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    4 Swale Road
    Walmley
    B76 2BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    British2262790003
    CHASE, Catherine Elizabeth
    43 Pembroke Croft
    B28 9EY Birmingham
    Amministratore
    43 Pembroke Croft
    B28 9EY Birmingham
    BritishNon Executive Director38992660001
    COLLINS, David
    Woodcot Lawnswood Drive
    Lawnswood
    DY7 5QW Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    Woodcot Lawnswood Drive
    Lawnswood
    DY7 5QW Stourbridge
    West Midlands
    BritishNon Executive Director9054250001
    DAVIES, David Charles
    8 Church Lane
    Westbere
    CT2 0HA Canterbury
    Kent
    Amministratore
    8 Church Lane
    Westbere
    CT2 0HA Canterbury
    Kent
    BritishNon Executive Director43095130001
    DICKINS, Paul
    86 London Road
    DN22 7DX Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    86 London Road
    DN22 7DX Retford
    Nottinghamshire
    BritishNon Executive Director62756170002
    EVERITT, David William
    4 Swale Road
    Walmley
    B76 2BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    4 Swale Road
    Walmley
    B76 2BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishAccountant2262790003
    FISHER, Michael George
    27 Beechwood Road
    Hollywood Grange
    B47 5QS Wythall
    West Midlands
    Amministratore
    27 Beechwood Road
    Hollywood Grange
    B47 5QS Wythall
    West Midlands
    BritishProject Sales Director11494270001
    HUMPHREYS, Christopher John
    16 Medici Road
    B60 2RL Bromsgrove
    Amministratore
    16 Medici Road
    B60 2RL Bromsgrove
    EnglandBritishCompany Director47664530002
    HYLAND, Peter Bernard
    44 Huntlands Road
    B63 4LZ Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    44 Huntlands Road
    B63 4LZ Halesowen
    West Midlands
    United KingdomBritishDirectors12329320001
    LEWIS, Frank
    14 Franklin Close
    N20 9QG Whetstone
    London
    Amministratore
    14 Franklin Close
    N20 9QG Whetstone
    London
    United KingdomBritishCompany Director55302020001
    OWEN, Alfred David
    Mill Dam House Mill Lane
    Aldridge
    WS9 0NB Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    Mill Dam House Mill Lane
    Aldridge
    WS9 0NB Walsall
    West Midlands
    EnglandBritishNon Executive Director7038720001
    QUIGLEY, Peter
    Sugars Farm Sugars Lane
    Rock
    DY14 9UW Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    Sugars Farm Sugars Lane
    Rock
    DY14 9UW Kidderminster
    Worcestershire
    BritishNon Executive Director7981680001
    SYKES, John Stuart
    Chantry Farm House
    Thorney Lanes, Hoar Cross
    DE13 8QT Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Chantry Farm House
    Thorney Lanes, Hoar Cross
    DE13 8QT Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishMarketing Director11494260002
    WELCH, Marjorie Eileen
    43 Wellington Road
    Edgbaston
    B15 2EP Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    43 Wellington Road
    Edgbaston
    B15 2EP Birmingham
    West Midlands
    BritishNon Executive Director13387380001
    WELCH, Patrick William
    43 Wellington Road
    Edgbaston
    B15 2EP Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    43 Wellington Road
    Edgbaston
    B15 2EP Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritishChairman11153750001

    WGL REALISATIONS 2010 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of deposit
    Creato il 11 gen 2007
    Consegnato il 16 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now or in the future credited to account designated 10363484 and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 gen 2006
    Consegnato il 08 feb 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Chattel mortgage
    Creato il 31 gen 2006
    Consegnato il 07 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Pimesco E3/15N 3 wheel truck komatsu MWS10-1R (pedestrian) paint spray kit for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Paul Dickins (The Security Trustee) as Security Trustee for the Noteholders
    Transazioni
    • 07 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 gen 2006
    Consegnato il 07 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Paul Dickins (The Security Trustee) as Security Trustee for the Noteholders
    Transazioni
    • 07 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2006
    Consegnato il 07 feb 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H 112 greenfell mansions,glaisher street,millenium quay,london.t/n TGL212374 by way of fixed charge and all rents and proceeds of any insurance from time to time and by way of assignment all right to the interest and any rental income.
    Persone aventi diritto
    • Welconstruct Pension & Life Assurance Scheme
    Transazioni
    • 07 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage deed
    Creato il 16 ott 2002
    Consegnato il 29 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property being plot 412,millennium quays,london. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 14 mar 1996
    Consegnato il 26 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 25 lug 1995
    Consegnato il 04 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-124/136 nathan way, thamesmead london t/nos. TGL100878 and LN137615 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 25 lug 1995
    Consegnato il 04 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-unit 25, pedmore road industrial estate pedmore road dudley west midlands t/n-WM67148 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 25 lug 1995
    Consegnato il 04 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-land and buildings on the south side of timmis road lye stourbridge dudley west midlands t/n-WM273033 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 25 lug 1995
    Consegnato il 04 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-land lying on the west side of stafford park, 13 stafford park telford the wrekin, shropshire t/n-SL50763 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 25 lug 1995
    Consegnato il 04 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-land and buildings on the south side of timms road lye stourbridge dudley west midlands t/n-WM324848 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 27 feb 1991
    Consegnato il 28 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Britannia works, ladon road, mirelin in marsh gloucestershire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 17 mag 1983
    Consegnato il 25 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 13 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 dic 1974
    Consegnato il 10 gen 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Britannia works moreton in the marsh gloucestershire.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 02 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 31 dic 1974
    Consegnato il 10 gen 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property in kingston works station rd acocks gn burmingham west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 dic 1974
    Consegnato il 10 gen 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    75/83 brealey street newtown birmingham west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank LTD
    Transazioni
    • 10 gen 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 31 dic 1974
    Consegnato il 10 gen 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital together with fixed plant & machinery (see doc 52).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 13 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WGL REALISATIONS 2010 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 set 2010Fine dell'amministrazione
    10 set 2009Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Praticante
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Richard James Philpott
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    2
    DataTipo
    10 gen 2017Data di scioglimento
    03 set 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard James Philpott
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0