TERMINUS 65 LIMITED

TERMINUS 65 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTERMINUS 65 LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00510793
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TERMINUS 65 LIMITED?

    • altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere
    • Edizione di riviste per il grande pubblico e per le imprese (58142) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova TERMINUS 65 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Apex Business Centre
    Boscombe Road
    LU5 4SB Dunstable
    Bedfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TERMINUS 65 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    POLESTAR GREAVES LIMITED06 nov 199806 nov 1998
    D.H. GREAVES LIMITED23 ago 195223 ago 1952

    Quali sono gli ultimi bilanci di TERMINUS 65 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2010
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2011
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2009

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TERMINUS 65 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 ago 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 ago 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TERMINUS 65 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per TERMINUS 65 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Catherine Ann Hearn come amministratore in data 30 set 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ago 2014

    Stato del capitale al 20 ago 2014

    • Capitale: GBP 2,000,000
    SH01

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed polestar greaves LIMITED\certificate issued on 12/05/11
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name12 mag 2011

    Risoluzione di cambio di nome della società il 10 mag 2011

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 01 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 ago 2010

    Stato del capitale al 02 ago 2010

    • Capitale: GBP 2,000,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TERMINUS 65 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GOODWIN, Alan
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Segretario
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    British98921850001
    GOODWIN, Alan James
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Amministratore
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    United KingdomBritish98921850003
    HIBBERT, Barry Alan
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    Amministratore
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritish68122470005
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Peters Lane
    HP27 0LQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    Amministratore
    Peters Lane
    HP27 0LQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    EnglandBritish138015860001
    STEVENSON, John Cyril
    2 Queen Elizabeth Drive
    Scalby
    YO13 0SR Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    2 Queen Elizabeth Drive
    Scalby
    YO13 0SR Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritish53677600002
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    HAINSWORTH, Paul
    28 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    Yorkshire
    Segretario
    28 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    Yorkshire
    British84514980001
    HIRST, Andrew Patrick
    The Meadows
    Ogle Road
    YO15 1NT Flamborough
    East Yorkshire
    Segretario
    The Meadows
    Ogle Road
    YO15 1NT Flamborough
    East Yorkshire
    British89191830001
    HOWELL, Michael Wayne
    Ings Green 17 Ings Lane
    Brompton By Sawdon
    YO13 9DR Scarborough
    North Yorkshire
    Segretario
    Ings Green 17 Ings Lane
    Brompton By Sawdon
    YO13 9DR Scarborough
    North Yorkshire
    British15478430001
    ALDREN, Stephen
    59 Seward Road
    WR11 7HQ Badsey
    Evesham
    Amministratore
    59 Seward Road
    WR11 7HQ Badsey
    Evesham
    United KingdomBritish105696350001
    ALLAN, Russell
    Stonebeck 6 Beech Drive
    Scalby
    YO13 0NP Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Stonebeck 6 Beech Drive
    Scalby
    YO13 0NP Scarborough
    North Yorkshire
    British9908720001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    BROWN, Frederick James
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British16105360002
    CHAPMAN, Peter William
    Cawood Cottage
    Cloughton
    YO13 0AX Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Cawood Cottage
    Cloughton
    YO13 0AX Scarborough
    North Yorkshire
    British15478440001
    CLARK, Stephen John
    Beaumont House Evesham Road
    Salford Priors
    WR11 5UU Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Beaumont House Evesham Road
    Salford Priors
    WR11 5UU Evesham
    Worcestershire
    British49702240002
    HEARN, Catherine Ann
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    Amministratore
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish83713930001
    HENNERS, Brian Anthony
    7 Newlands Park Drive
    YO12 6DW Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    7 Newlands Park Drive
    YO12 6DW Scarborough
    North Yorkshire
    British37532310001
    HIRST, Andrew Patrick
    The Meadows
    Ogle Road
    YO15 1NT Flamborough
    East Yorkshire
    Amministratore
    The Meadows
    Ogle Road
    YO15 1NT Flamborough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish89191830001
    HOWELL, Michael Wayne
    Ings Green 17 Ings Lane
    Brompton By Sawdon
    YO13 9DR Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Ings Green 17 Ings Lane
    Brompton By Sawdon
    YO13 9DR Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritish15478430001
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    Amministratore
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    British83714120001
    LYALL, Peter Edward
    Chalkpit House
    The Dell Kingsclere
    RG15 8NL Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Chalkpit House
    The Dell Kingsclere
    RG15 8NL Newbury
    Berkshire
    British44633140001
    MAUGHAN, Colin
    The Grange Moorhead Crescent
    BD18 4LQ Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Grange Moorhead Crescent
    BD18 4LQ Shipley
    West Yorkshire
    British2000880001
    MCQUILLAN, Paul John
    18e Market Place
    YO17 7LX Malton
    North Yorkshire
    Amministratore
    18e Market Place
    YO17 7LX Malton
    North Yorkshire
    British78958070002
    OXFORD, Jonathan James
    19 Cayley Lane
    Brompton By Sawdon
    YO13 9DL Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    19 Cayley Lane
    Brompton By Sawdon
    YO13 9DL Scarborough
    North Yorkshire
    British54046870001
    POCKNALL, Michael George
    74 Abbots Garth
    Seamer
    YO12 4QN Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    74 Abbots Garth
    Seamer
    YO12 4QN Scarborough
    North Yorkshire
    British49294360001
    POWELL, George Christopher James
    16 Wellington Square
    GL50 4JS Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    16 Wellington Square
    GL50 4JS Cheltenham
    Gloucestershire
    British71388200001
    RACKLEY, Ralph William Derek
    43 Hovingham Drive
    YO12 5DT Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    43 Hovingham Drive
    YO12 5DT Scarborough
    North Yorkshire
    British15478450001
    ROBERTSON, Malcolm Murray
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritish39155140002
    RUDSTON, Anthony
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    Amministratore
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    EnglandBritish44908110001
    SALTER, Declan John
    Woodcote
    Burtons Lane
    HP8 4BA Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Woodcote
    Burtons Lane
    HP8 4BA Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish67413330001
    SCHOFIELD, Raymond
    6 Whitham Close
    Boston Spa
    LS23 6DU Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    6 Whitham Close
    Boston Spa
    LS23 6DU Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish10127810002
    STEVENSON, John Cyril
    2 Sea View Grove
    YO11 3JA Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    2 Sea View Grove
    YO11 3JA Scarborough
    North Yorkshire
    British53677600001
    TIMMINS, Richard Keith
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    Amministratore
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    United KingdomBritish127238050003
    TOPHAM, Bryan
    17 Pullan Avenue
    BD2 3RS Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    17 Pullan Avenue
    BD2 3RS Bradford
    West Yorkshire
    British9908710001
    WALKER, Patrick Granville
    Plumpton House Mitchell Lane Thackley
    BD10 0TA Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Plumpton House Mitchell Lane Thackley
    BD10 0TA Bradford
    West Yorkshire
    British23217500001

    TERMINUS 65 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 26 nov 2008
    Consegnato il 08 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of properties charged please refer to the form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited as Agent and Trustee for the Benefit of the Lenders
    Transazioni
    • 08 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Amendment agreement relating to the security agreement dated 13 december 2006 and
    Creato il 25 nov 2008
    Consegnato il 08 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For properties charged please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited as Agent and Trustee for the Benefit of the Lenders
    Transazioni
    • 08 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental security agreement
    Creato il 09 mar 2007
    Consegnato il 19 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The real estate being l/h land situated between brunel way and newcomen way colchester. L/h petty house whitehall road & coleman street leeds t/n WYK767996. L/h unit 2 lockwood house lockwood way parkside industrial estate leeds. For further details of property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited (In Its Capacity as Security Agent)
    Transazioni
    • 19 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 13 dic 2006
    Consegnato il 22 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P.Morgan Europe Limited for Itself and as Agent and Trustee for Each of the Secured Creditors
    Transazioni
    • 22 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998
    Creato il 28 ott 2004
    Consegnato il 10 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) as Security Trusteefor Itself and the Other Secured Parties or Such Other Person as May from Time to Time Be Appointed Security Trustee
    Transazioni
    • 10 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A composite guarantee and debenture between polestar,the polestar corporation PLC,certain subsidiaries of polestar and J.P.morgan europe limited
    Creato il 28 gen 2002
    Consegnato il 15 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities due or to become due from the chargor to the secured parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including (I) l/hold over unit B5 blenheim industrial park estate,bury st edmunds,suffolk; (ii) l/hold unit 14 luton stadium estate,craddock rd,luton,bedfordshire; BD77546; (iii) l/hold over wigman rd,aspley,nottingham; t/nos NT78782 and NT180765; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • J.P.Morgan Europe Limited,as Security Trstee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 15 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A composite guarantee and debenture between the chargor, the polestar corporation PLC, certain subsidiaries of the chargor and chase manhattan international limited
    Creato il 26 ott 2001
    Consegnato il 14 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited (As Security Trustee for Itself and Investcorp Fundinglimited)
    Transazioni
    • 14 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental deed (supplemental to a composite guarantee & debenture dated 19 june 1998)
    Creato il 04 set 1998
    Consegnato il 24 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other watmoughs UK charging subsidiary (as therein defined) to the secured parties or any of them including all monies due under or pursuant to the finance documents (as defined) and/or the deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited(As Security Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 24 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 20 feb 1959
    Consegnato il 02 mar 1959
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mar 1959Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0