TERMINUS 65 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TERMINUS 65 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00510793 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TERMINUS 65 LIMITED?
- altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere
- Edizione di riviste per il grande pubblico e per le imprese (58142) / Informazione e comunicazione
Dove si trova TERMINUS 65 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Apex Business Centre Boscombe Road LU5 4SB Dunstable Bedfordshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TERMINUS 65 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| POLESTAR GREAVES LIMITED | 06 nov 1998 | 06 nov 1998 |
| D.H. GREAVES LIMITED | 23 ago 1952 | 23 ago 1952 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TERMINUS 65 LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 set 2010 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 giu 2011 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2009 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TERMINUS 65 LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 01 ago 2016 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 15 ago 2016 |
| Scaduto | Sì |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TERMINUS 65 LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per TERMINUS 65 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripristino per ordine del tribunale | 3 pagine | AC92 | ||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Ripristino per ordine del tribunale | 3 pagine | AC92 | ||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Cessazione della carica di Catherine Ann Hearn come amministratore in data 30 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ago 2014 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ripristino per ordine del tribunale | 3 pagine | AC92 | ||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed polestar greaves LIMITED\certificate issued on 12/05/11 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ago 2010 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TERMINUS 65 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOODWIN, Alan | Segretario | Ensign House Juniper Drive SW18 1TR London 104 | British | 98921850001 | ||||||
| GOODWIN, Alan James | Amministratore | Ensign House Juniper Drive SW18 1TR London 104 | United Kingdom | British | 98921850003 | |||||
| HIBBERT, Barry Alan | Amministratore | River Steps Gibraltar Lane SL6 9TR Cookham Dean Berkshire | United Kingdom | British | 68122470005 | |||||
| JOHNSTON, Peter Douglas | Amministratore | Peters Lane HP27 0LQ Whiteleaf Tanglewood Bucks | England | British | 138015860001 | |||||
| STEVENSON, John Cyril | Amministratore | 2 Queen Elizabeth Drive Scalby YO13 0SR Scarborough North Yorkshire | England | British | 53677600002 | |||||
| BRIDGES, Clive | Segretario | 334 Wendover Road Weston Turville HP22 5TN Aylesbury Buckinghamshire | British | 987230001 | ||||||
| HAINSWORTH, Paul | Segretario | 28 Oakleigh View Baildon BD17 5TP Shipley Yorkshire | British | 84514980001 | ||||||
| HIRST, Andrew Patrick | Segretario | The Meadows Ogle Road YO15 1NT Flamborough East Yorkshire | British | 89191830001 | ||||||
| HOWELL, Michael Wayne | Segretario | Ings Green 17 Ings Lane Brompton By Sawdon YO13 9DR Scarborough North Yorkshire | British | 15478430001 | ||||||
| ALDREN, Stephen | Amministratore | 59 Seward Road WR11 7HQ Badsey Evesham | United Kingdom | British | 105696350001 | |||||
| ALLAN, Russell | Amministratore | Stonebeck 6 Beech Drive Scalby YO13 0NP Scarborough North Yorkshire | British | 9908720001 | ||||||
| BRIDGES, Clive | Amministratore | 334 Wendover Road Weston Turville HP22 5TN Aylesbury Buckinghamshire | British | 987230001 | ||||||
| BROWN, Frederick James | Amministratore | 61 Handside Lane AL8 6SH Welwyn Garden City Hertfordshire | British | 16105360002 | ||||||
| CHAPMAN, Peter William | Amministratore | Cawood Cottage Cloughton YO13 0AX Scarborough North Yorkshire | British | 15478440001 | ||||||
| CLARK, Stephen John | Amministratore | Beaumont House Evesham Road Salford Priors WR11 5UU Evesham Worcestershire | British | 49702240002 | ||||||
| HEARN, Catherine Ann | Amministratore | White Gate House Ellesborough Road HP22 6ES Wendover Buckinghamshire | United Kingdom | British | 83713930001 | |||||
| HENNERS, Brian Anthony | Amministratore | 7 Newlands Park Drive YO12 6DW Scarborough North Yorkshire | British | 37532310001 | ||||||
| HIRST, Andrew Patrick | Amministratore | The Meadows Ogle Road YO15 1NT Flamborough East Yorkshire | United Kingdom | British | 89191830001 | |||||
| HOWELL, Michael Wayne | Amministratore | Ings Green 17 Ings Lane Brompton By Sawdon YO13 9DR Scarborough North Yorkshire | England | British | 15478430001 | |||||
| JOHNSTON, Peter Douglas | Amministratore | Flat 3 76 Carter Lane EC4V 5EA London | British | 83714120001 | ||||||
| LYALL, Peter Edward | Amministratore | Chalkpit House The Dell Kingsclere RG15 8NL Newbury Berkshire | British | 44633140001 | ||||||
| MAUGHAN, Colin | Amministratore | The Grange Moorhead Crescent BD18 4LQ Shipley West Yorkshire | British | 2000880001 | ||||||
| MCQUILLAN, Paul John | Amministratore | 18e Market Place YO17 7LX Malton North Yorkshire | British | 78958070002 | ||||||
| OXFORD, Jonathan James | Amministratore | 19 Cayley Lane Brompton By Sawdon YO13 9DL Scarborough North Yorkshire | British | 54046870001 | ||||||
| POCKNALL, Michael George | Amministratore | 74 Abbots Garth Seamer YO12 4QN Scarborough North Yorkshire | British | 49294360001 | ||||||
| POWELL, George Christopher James | Amministratore | 16 Wellington Square GL50 4JS Cheltenham Gloucestershire | British | 71388200001 | ||||||
| RACKLEY, Ralph William Derek | Amministratore | 43 Hovingham Drive YO12 5DT Scarborough North Yorkshire | British | 15478450001 | ||||||
| ROBERTSON, Malcolm Murray | Amministratore | Mardale 85 Harmer Green Lane Digswell AL6 0ER Welwyn Hertfordshire | United Kingdom | British | 39155140002 | |||||
| RUDSTON, Anthony | Amministratore | Minstrels Barn Henton OX9 4AE Chinnor Oxfordshire | England | British | 44908110001 | |||||
| SALTER, Declan John | Amministratore | Woodcote Burtons Lane HP8 4BA Chalfont St. Giles Buckinghamshire | England | British | 67413330001 | |||||
| SCHOFIELD, Raymond | Amministratore | 6 Whitham Close Boston Spa LS23 6DU Wetherby West Yorkshire | England | British | 10127810002 | |||||
| STEVENSON, John Cyril | Amministratore | 2 Sea View Grove YO11 3JA Scarborough North Yorkshire | British | 53677600001 | ||||||
| TIMMINS, Richard Keith | Amministratore | 3 Maxey View Deeping Gate PE6 9BE Peterborough | United Kingdom | British | 127238050003 | |||||
| TOPHAM, Bryan | Amministratore | 17 Pullan Avenue BD2 3RS Bradford West Yorkshire | British | 9908710001 | ||||||
| WALKER, Patrick Granville | Amministratore | Plumpton House Mitchell Lane Thackley BD10 0TA Bradford West Yorkshire | British | 23217500001 |
TERMINUS 65 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creato il 26 nov 2008 Consegnato il 08 dic 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari For details of properties charged please refer to the form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Amendment agreement relating to the security agreement dated 13 december 2006 and | Creato il 25 nov 2008 Consegnato il 08 dic 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari For properties charged please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental security agreement | Creato il 09 mar 2007 Consegnato il 19 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The real estate being l/h land situated between brunel way and newcomen way colchester. L/h petty house whitehall road & coleman street leeds t/n WYK767996. L/h unit 2 lockwood house lockwood way parkside industrial estate leeds. For further details of property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 13 dic 2006 Consegnato il 22 dic 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998 | Creato il 28 ott 2004 Consegnato il 10 nov 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A composite guarantee and debenture between polestar,the polestar corporation PLC,certain subsidiaries of polestar and J.P.morgan europe limited | Creato il 28 gen 2002 Consegnato il 15 feb 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys and liabilities due or to become due from the chargor to the secured parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Including (I) l/hold over unit B5 blenheim industrial park estate,bury st edmunds,suffolk; (ii) l/hold unit 14 luton stadium estate,craddock rd,luton,bedfordshire; BD77546; (iii) l/hold over wigman rd,aspley,nottingham; t/nos NT78782 and NT180765; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A composite guarantee and debenture between the chargor, the polestar corporation PLC, certain subsidiaries of the chargor and chase manhattan international limited | Creato il 26 ott 2001 Consegnato il 14 nov 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed (supplemental to a composite guarantee & debenture dated 19 june 1998) | Creato il 04 set 1998 Consegnato il 24 set 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and each other watmoughs UK charging subsidiary (as therein defined) to the secured parties or any of them including all monies due under or pursuant to the finance documents (as defined) and/or the deed | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 20 feb 1959 Consegnato il 02 mar 1959 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0