MINET LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMINET LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00513938
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MINET LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MINET LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Devonshire Square
    London
    EC2M 4PL
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MINET LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    J.H.MINET & CO.LIMITED05 dic 195205 dic 1952

    Quali sono gli ultimi bilanci di MINET LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per MINET LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Paul Francis Clayden come amministratore in data 21 set 2012

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 17 set 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 14/09/2012
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 08 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    15 pagineAA

    Nomina di Paul Arthur Hogwood come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Yvonne Fisher come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 08 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata

    2 pagineAD04

    Bilancio annuale redatto al 08 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    16 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    2 pagineAD02

    Nomina di Yvonne Jane Fisher come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Stephen Dudley Gale come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Edward Cruttwell come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Heap come amministratore

    2 pagineTM01

    legacy

    6 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    15 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MINET LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COSEC 2000 LIMITED
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Segretario
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    64208180001
    GALE, Stephen Dudley
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Amministratore
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United KingdomBritish152013590001
    HOGWOOD, Paul Arthur
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish7453920004
    ALLAM, Richard John
    Rose Cottage Tower Hill
    Offham
    ME19 5NH West Malling
    Kent
    Segretario
    Rose Cottage Tower Hill
    Offham
    ME19 5NH West Malling
    Kent
    British13466180001
    ASPINALL, Nicholas
    45 Southdean Gardens
    Wimbledon
    SW19 6NT London
    Segretario
    45 Southdean Gardens
    Wimbledon
    SW19 6NT London
    British29662910003
    BEGLEY, John Patrick
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Amministratore
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    British110985340001
    CHRISTIE, Peter Steele
    36 Lonsdale Square
    Islington
    N1 1EW London
    Amministratore
    36 Lonsdale Square
    Islington
    N1 1EW London
    British65068940003
    CLAYDEN, Paul Francis
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Amministratore
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United KingdomBritish138098080001
    COTTERILL, Paul
    4 Banckside
    Hartley
    DA3 7RD Longfield
    Kent
    Amministratore
    4 Banckside
    Hartley
    DA3 7RD Longfield
    Kent
    British5479100001
    CRUTTWELL, Edward Robert Charles
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Amministratore
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    British34367480002
    CRUTTWELL, Edward Robert Charles
    Skurrays
    Petteridge Lane
    TN12 7LT Matfield
    Kent
    Amministratore
    Skurrays
    Petteridge Lane
    TN12 7LT Matfield
    Kent
    British34367480001
    DESAI, Vinodrai Kikubhai
    Treetops
    299 Beulah Hill
    SE19 3UZ Upper Norwood
    London
    Amministratore
    Treetops
    299 Beulah Hill
    SE19 3UZ Upper Norwood
    London
    EnglandBritish34312730001
    DIXEY, Charles Richard
    Upper Shelspit Farm
    MK18 2DY Thornborough
    Bucks
    Amministratore
    Upper Shelspit Farm
    MK18 2DY Thornborough
    Bucks
    British50281920001
    FISHER, Yvonne Jane
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    England
    Amministratore
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    England
    EnglandBritish152086390001
    GILBERT, Stephen Harry
    Whitedown South Hanningfield Road
    South Hanningfield
    CM3 8HJ Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Whitedown South Hanningfield Road
    South Hanningfield
    CM3 8HJ Chelmsford
    Essex
    British25975470002
    GILBERT, Stephen Harry
    Whitedown South Hanningfield Road
    South Hanningfield
    CM3 8HJ Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Whitedown South Hanningfield Road
    South Hanningfield
    CM3 8HJ Chelmsford
    Essex
    British25975470002
    HATTON, Robert William
    29 Forden Avenue
    Westmount
    H37 Montreal
    Quebec
    Amministratore
    29 Forden Avenue
    Westmount
    H37 Montreal
    Quebec
    Canadian9411480001
    HAYES, Bryan Joseph
    1 Abbotts Court Thackeray Street
    W8 4AL London
    Amministratore
    1 Abbotts Court Thackeray Street
    W8 4AL London
    Irish49014750001
    HEAP, Michael Conrad
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Amministratore
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    British93892910002
    HILL, John Lawrence
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Amministratore
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    British663680003
    HILL, John Lawrence
    Bramley Farm House
    Romford Road Pembury
    TN2 4BA Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Bramley Farm House
    Romford Road Pembury
    TN2 4BA Tunbridge Wells
    Kent
    British663680001
    HOPE, Duncan Patrick Nicholson
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Amministratore
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    British110985300001
    MACGREGOR, Alpin Findanus
    79 Stockwell Park Road
    SW9 0DB London
    Amministratore
    79 Stockwell Park Road
    SW9 0DB London
    United KingdomBritish45926520001
    MCGRISKIN, James Reilly
    4 Thomas Place
    W8 5UG London
    Amministratore
    4 Thomas Place
    W8 5UG London
    British52234580001
    MURRAY, Richard Henry
    54 Bedford Gardens
    Kensington
    W8 7EH London
    Amministratore
    54 Bedford Gardens
    Kensington
    W8 7EH London
    American40103250001
    ORAM, William John
    8 Devonshire Square
    EC4M 2PL London
    Amministratore
    8 Devonshire Square
    EC4M 2PL London
    United KingdomOther98212820001
    PARMENTER, Michael Peter
    65 Woodlands Road
    SS5 4PY Hockley
    Essex
    Amministratore
    65 Woodlands Road
    SS5 4PY Hockley
    Essex
    British58496290002
    QUICK, Stephen John
    27 St Marys Road
    Wimbledon
    SW19 7BT London
    Amministratore
    27 St Marys Road
    Wimbledon
    SW19 7BT London
    British44268960001
    REID, Michael Montgomery
    5 The Coppice Bitchet Green
    Seal
    TN15 0NB Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    5 The Coppice Bitchet Green
    Seal
    TN15 0NB Sevenoaks
    Kent
    British62555650001
    ROBERTS, Julian Victor Frow
    27 Fairway
    Merrow
    GU1 2XJ Guildford
    Surrey
    Amministratore
    27 Fairway
    Merrow
    GU1 2XJ Guildford
    Surrey
    British57259630001
    ROSSOR, Michael Keith
    72 Links Way
    Eden Park
    BR3 3DQ Beckenham
    Kent
    Amministratore
    72 Links Way
    Eden Park
    BR3 3DQ Beckenham
    Kent
    British55457000001
    WALL, David Neil
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Amministratore
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    British25408090002
    WALL, David Neil
    Wythburn
    3 Park Avenue
    AL1 4PB St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Wythburn
    3 Park Avenue
    AL1 4PB St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish25408090001

    MINET LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of variation made between minet limited and lloyd's containing a second floating charge and modifying the security and trust deed dated 19TH september 1989 between the parties aforesaid both deeds being pursuant to the lloyd's brokers byelaw (no 5 of 1988) (the byelaw)
    Creato il 04 giu 1997
    Consegnato il 12 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security and trust deed dated 19TH september 1989 and the deed of variation
    Brevi particolari
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw required to be paid into an insurance broking account of the company and all approved iba assets (as defined in the byelaw). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyd's as Trustee for Approved Banks (As Defined)
    Transazioni
    • 12 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security & trust deed.
    Creato il 19 set 1989
    Consegnato il 26 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The payment of all debts and obligations for the time being due, owing or incurred, whether actually or contingently, by the company to lloyd's in respect of insurance transactions.
    Brevi particolari
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyd's brokers byelaw (no.5 Of 1988) (for full details see doc M43C).
    Persone aventi diritto
    • Lloyd's
    Transazioni
    • 26 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 06 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 24 feb 1983
    Consegnato il 04 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All the company's right, title interest in the monies standing to the credit of the company's "c" account at the date of the trust deed, & in the monies & investments at the date of the trust deed standing to the credit of or held in other iba accounts of the company or from time to time after such date received by the company from any source (see doc M83).
    Persone aventi diritto
    • The Corporation of Lloyd's
    Transazioni
    • 04 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 21 giu 1976
    Consegnato il 30 giu 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    66, prescot street, tower hamlets, london E1. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • International Westminster Bank LTD And
    • County Bank LTD
    Transazioni
    • 30 giu 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 21 giu 1976
    Consegnato il 30 giu 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    84/100 leman street, tower hamlets, london E1.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • International Westminster Bank LTD And
    • County Bank LTD.
    Transazioni
    • 30 giu 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0