WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED

WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWHEWAY HAMPSHIRE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00516469
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED?

    • (7487) /

    Dove si trova WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL)LLP
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ATLAS (HAMPSHIRE) LIMITED02 dic 199302 dic 1993
    WRIGHT RAIN LIMITED26 feb 195326 feb 1953

    Quali sono gli ultimi bilanci di WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 08 set 2010

    LRESEX

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da Begbies Traynor (Central) Llp 2 Collingwood Street Newcastle upon Tyne NE1 1JF in data 07 set 2010

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5DR in data 07 set 2010

    2 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    13 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    15 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    18 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    19 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine190

    Chi sono gli amministratori di WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SOHAL, Balkar
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    Segretario
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    British122186580001
    LILLY, Kevin Lucius
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Amministratore
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican110636870001
    O'LEARY, Patrick Joseph
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Amministratore
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican61807850002
    REILLY, Michael Andrew
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    Amministratore
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    United StatesAmerican103500870001
    M.R. SERVICES LIMITED
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Segretario
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    55567600012
    MR SERVICES LIMITED
    Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way
    Abingdon Business Park
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    Segretario
    Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way
    Abingdon Business Park
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    55567600003
    WHEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Suite Two Hitching Court
    Blacklands Way Abingdon Business Par
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    Segretario
    Suite Two Hitching Court
    Blacklands Way Abingdon Business Par
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    39955810002
    BOSWELL, Brian Peter
    Garden Cottage Hawford House
    Hawford
    WR3 7SQ Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Garden Cottage Hawford House
    Hawford
    WR3 7SQ Worcester
    Worcestershire
    British52804120001
    BRICKER, Ross Benjamin
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Amministratore
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Canadian105172080001
    COLE, Ian Robert
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    Amministratore
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    British42980510001
    COOK, Norman Joseph
    69 Northbourne Avenue
    BH10 6DQ Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    69 Northbourne Avenue
    BH10 6DQ Bournemouth
    Dorset
    British29686540001
    COTTON, Richard John
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    Amministratore
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    EnglandBritish45397090001
    DAMEN, Michael John
    Chartmead 360 Vale Road
    Ash Vale
    GU12 5LW Aldershot
    Hampshire
    Amministratore
    Chartmead 360 Vale Road
    Ash Vale
    GU12 5LW Aldershot
    Hampshire
    British21170030001
    DETHERIDGE, Ian Martin
    81 Dalkeith Court
    Dudsbury Avenue
    BH22 8DY Ferndown
    Dorset
    Amministratore
    81 Dalkeith Court
    Dudsbury Avenue
    BH22 8DY Ferndown
    Dorset
    British48986470001
    DOHERTY, James Patrick
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    Amministratore
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    Irish105328280001
    FITCHFORD, Andrew Michael John
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    British99141670001
    GOPSILL, Michael Clement
    Wood Cottage
    Norton Road Iverley
    Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    Wood Cottage
    Norton Road Iverley
    Stourbridge
    West Midlands
    British32481900001
    HAZLEHURST, Ian James
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    British43476760001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    British33223550001
    JONES, Alan Martin
    5 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    5 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    British47891670001
    KEARNEY, Christopher James
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    Amministratore
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    American85114770001
    LADENBERGER, Daniel Timothy
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    Amministratore
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    American110032170001
    MCGOWAN, John Peter
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    British62509010002
    MUNDELL, James Joseph
    Woodcote Barn
    B61 9EE Dodford
    Worcestershire
    Amministratore
    Woodcote Barn
    B61 9EE Dodford
    Worcestershire
    United KingdomBritish13970540001
    WALKER, Craig Allen
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    Amministratore
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    Usa109340980001
    WINOWIECKI, Ronald Lee
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    Amministratore
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    American95572300001

    WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Cross guarantee and debenture
    Creato il 04 apr 2003
    Consegnato il 09 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the security beneficiaries on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transazioni
    • 09 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 22 dic 1992
    Consegnato il 07 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined) under the financing agreement dated 22ND december 1992 and/or the security documents (as defined) or any of them
    Brevi particolari
    See doc ref M76 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcas "Security Trustee" for the Beneficiaries (Asdefined)
    Transazioni
    • 07 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 29 giu 1988
    Consegnato il 13 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture.
    Creato il 11 feb 1987
    Consegnato il 19 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to barclay inust international limited as trustee for the lenders as defined under the terms of the facility letter of even dated and the guarantee & debenture
    Brevi particolari
    Floating charge over all the undertaking property, assets and rights whatsoever present and/or future of the company.
    Persone aventi diritto
    • Cin Industrial Investment Limited.
    • Barclay Trust International Limitedas Trustee for Schroder UK Venture Fund And
    Transazioni
    • 19 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 11 feb 1987
    Consegnato il 18 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Harwood road littlehampton aram west sussex t/n wsx 74999 and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 11 feb 1987
    Consegnato il 18 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Crowe arch lane ringwood new forest hampshire t/n hp 73054. and/or proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 11 feb 1987
    Consegnato il 18 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as all that land lying on the east side of crowe arch lane ringwood hampshire and/or proceeds of salethereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 11 feb 1987
    Consegnato il 18 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 1987Registrazione di un'ipoteca

    WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 set 2010Inizio della liquidazione
    21 mag 2011Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Peter Andrew Blair
    Regency House 21 The Ropewalk
    NG1 5DU Nottingham
    Nottinghamshire
    Praticante
    Regency House 21 The Ropewalk
    NG1 5DU Nottingham
    Nottinghamshire
    Andrew D Haslam
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0