SPX INTERNATIONAL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SPX INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00517486 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SPX INTERNATIONAL LIMITED?
- Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere
Dove si trova SPX INTERNATIONAL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Spx Flow Europe Limited Part Ground Floor Alexander House, 4 Station Road SK8 5AE Cheadle Hulme United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SPX INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| GENERAL SIGNAL UK LIMITED | 05 gen 1993 | 05 gen 1993 |
| LEEDS & NORTHRUP LIMITED | 21 mar 1953 | 21 mar 1953 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SPX INTERNATIONAL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per SPX INTERNATIONAL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 33 pagine | AA | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa | 1 pagine | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Spx Flow Europe Limited Part Ground Floor, Alexander House 4 Station Road Cheadle Hulme SK8 5AE United Kingdom a C/O Spx Flow Europe Limited Part Ground Floor Alexander House, 4 Station Road Cheadle Hulme SK8 5AE in data 22 dic 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mark Edward Shanahan il 14 apr 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 set 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Spx Uk Holding Limited come persona con controllo significativo il 24 mar 2021 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Eversheds Llp, Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5DR a C/O Spx Flow Europe Limited Part Ground Floor, Alexander House 4 Station Road Cheadle Hulme SK8 5AE in data 14 apr 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 39 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 set 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Martyn Greaves come amministratore in data 30 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Stato del capitale al 21 apr 2020
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 35 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jaime Manson Easley il 15 mar 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Tsoris come amministratore in data 31 lug 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Peter James Ryan come amministratore in data 31 lug 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Jaime Manson Easley come amministratore in data 17 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SPX INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASLEY, Jaime Manson | Amministratore | 13320 Ballantyne Corporate Place NC28277 Charlotte Spx Flow Inc. North Carolina United States | United States | American | 259841060001 | |||||
| RYAN, Peter James | Amministratore | Ballantyne Corporate Place 28277 Charlotte 13320 North Carolina United States | United States | American | 259841080001 | |||||
| SHANAHAN, Mark Edward | Amministratore | Part Ground Floor Alexander House, 4 Station Road SK8 5AE Cheadle Hulme C/O Spx Flow Europe Limited United Kingdom | England | British | 165707440001 | |||||
| BRICKER, Ross Benjamin | Segretario | 2401 Pioneer Road JI 60201 Evanston Illinios Ji 60201 Usa | Canadian | 105172080001 | ||||||
| CONNELL, John Gregory | Segretario | 2 Larch Rise Prestbury SK10 4UY Macclesfield Cheshire | British | 16795230001 | ||||||
| GRAY, Harold | Segretario | 6 Pownall Avenue Bramhall SK7 2HE Stockport Cheshire | British | 16795240001 | ||||||
| KEARNEY, Christopher James | Segretario | 14675 Rudolph Dadey Drive Charlotte Nc2827749456 Usa | American | 85114770001 | ||||||
| LILLY, Kevin Lucius | Segretario | Ballantyne Corporate Place Charlotte 13320 Nc 28277 Usa | American | 110636870001 | ||||||
| SEATON, John Charles | Segretario | 22 The Moorives Malahida Dublin Ireland | British | 32740720001 | ||||||
| ARTHUR, Raymond Lawrence | Amministratore | 64b Pelham Lane 06877 Ridgefield Connecticut Usa | British | 56821140001 | ||||||
| BOBER, Joanne Leslie | Amministratore | 300 East 75th Street New York City 10021 New York Usa | American | 50979870001 | ||||||
| BOUCHARD, William | Amministratore | Bray Cottage 30 Station Road RG17 9UR Kintbury Berkshire | American | 79426700001 | ||||||
| BRICKER, Ross Benjamin | Amministratore | 2401 Pioneer Road JI 60201 Evanston Illinios Ji 60201 Usa | Canadian | 105172080001 | ||||||
| CAHILL, Paul Andrew | Amministratore | Hambridge Road RG14 5TR Newbury Spx International Limited Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 202085370001 | |||||
| CONNELL, John Gregory | Amministratore | 2 Larch Rise Prestbury SK10 4UY Macclesfield Cheshire | Uk | British | 16795230001 | |||||
| COOK, Iain Wallace | Amministratore | 102 Poplar Road Dorridge B93 8DG Solihull West Midlands | England | British | 4924770001 | |||||
| CROSS, Arthur Robert | Amministratore | 1188 Harbour Point Drive Muskegon Michigan Mi 49441 Usa | American | 61807880001 | ||||||
| CULL, Jonathan Peter | Amministratore | 35 Elmwood M33 5RN Sale Cheshire | British | 42815760001 | ||||||
| CULLY, Ian Tyrell | Amministratore | 104 Rue Des Suresnes 92000 Nanterre France | British | 40875280001 | ||||||
| GERACI, Eugene Edward | Amministratore | 114 Brasail The Bailey Howth Dublin Ireland | Usa | 39590220001 | ||||||
| GRAY, Harold | Amministratore | 6 Pownall Avenue Bramhall SK7 2HE Stockport Cheshire | British | 16795240001 | ||||||
| GREAVES, John Martyn | Amministratore | Hambridge Road RG14 5TR Newbury Spxflow Berkshire United Kingdom | England | British | 246468860001 | |||||
| KEARNEY, Christopher James | Amministratore | 14675 Rudolph Dadey Drive Charlotte Nc2827749456 Usa | American | 85114770001 | ||||||
| LILLY, Kevin Lucius | Amministratore | Ballantyne Corporate Place Charlotte 13320 Nc 28277 Usa | United States | American | 110636870001 | |||||
| MORTIMER, Terry James | Amministratore | 20 Buttonball Lane Weston Connecticut 06883 America | American | 52291630001 | ||||||
| O'LEARY, Patrick Joseph | Amministratore | 6524 Chipstead Lane 28277 Charlotte North Carolina Nc 28277 Usa | United States | American | 61807850002 | |||||
| PARK, Samuel Edward | Amministratore | 662 Alexander Spring Road Carlisle Pennsylvania 17013 Usa | Irish | 35202230001 | ||||||
| REILLY, Michael Andrew | Amministratore | 2007 Channelstone Way NC 28104 Matthews Nc 28104 Usa | United States | American | 103500870001 | |||||
| SELLS, David William | Amministratore | The Old Vicarage Acklington Morpoth Northumberland | British | 68623080001 | ||||||
| SMELTSER, Jeremy Wade | Amministratore | Ballantyne Corporate Place 28277 Charlotte 13515 North Carolina United States | United States | American | 163313000001 | |||||
| SMITH, Edgar James | Amministratore | High Ridge Park 06904 Stamford Connecticut 06904 Usa | American | 16897690001 | ||||||
| SOHAL, Balkar | Amministratore | Hambridge Road RG14 5TR Newbury C/O Spx Flow Technology Limited Berkshire United Kingdom | England | English | 161546310001 | |||||
| TSORIS, Stephen | Amministratore | Ballantyne Corporate Place NC 28277 Charlotte 13320 North Carolina United States | United States | American | 197069810001 | |||||
| TWOMBLY, Julian Ballard | Amministratore | 1 Running Brook Lane New Canaan 06840 Connecticut United States Of America | American | 38022940001 | ||||||
| WINOWIECKI, Ronald Lee | Amministratore | 8707 Calumet Farms Drive Wexham Nc 28173 Usa | American | 95572300001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SPX INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spx Uk Holding Limited | 06 apr 2016 | Part Ground Floor, Alexander House 4 Station Road SK8 5AE Cheadle Hulme C/O Spx Flow Europe Limited United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SPX INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 09 feb 2005 Consegnato il 22 feb 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All that piece of parcel of f/h land k/a unit 5 buttington cross enterprise park, welshpool, powys together with the building or buildings erected thereon or on part thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge of deposit | Creato il 10 feb 2004 Consegnato il 17 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The deposit initially of £2,990,265.00 credited to account designation 63057972 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency, description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0