ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED

ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00521510
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    • (4521) /

    Dove si trova ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RYAN UTILITY SERVICES LIMITED20 nov 200020 nov 2000
    D.J. RYAN & SONS LIMITED07 lug 195307 lug 1953

    Quali sono gli ultimi bilanci di ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2009
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2010
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al17 ott 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma31 ott 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Lee James Mills come amministratore in data 28 set 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy Francis George come segretario in data 28 set 2018

    2 pagineTM02

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione della carica di Andrew Wilkins come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 17 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 ott 2009

    Stato del capitale al 22 ott 2009

    • Capitale: GBP 1,449,628
    SH01
    Note
    DataNota
    05 dic 2025Other Any information marked (#) was made unavailable on 05/12/2025 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2007

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a
    Note
    DataNota
    05 dic 2025Other Any information marked (#) was made unavailable on 05/12/2025 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    11 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a
    Note
    DataNota
    05 dic 2025Other Any information marked (#) was made unavailable on 05/12/2025 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2006

    5 pagineAA

    legacy

    15 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COFFEY, Stephanie Helen
    53 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LY Reading
    Berkshire
    Segretario
    53 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LY Reading
    Berkshire
    British81328280002
    FORSTER, Garry James
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    Segretario
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    British38750850004
    GEORGE, Timothy Francis
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    Segretario
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    British24075160004
    HIGGINS, Caroline Patricia
    Flat 10
    7 Aubert Park
    N5 1TL London
    Segretario
    Flat 10
    7 Aubert Park
    N5 1TL London
    British88102970001
    MEADOWS, John
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    Segretario
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    British101833160001
    STONES, Michael John
    23 Muirfield Close
    Fulwood
    PR2 7EA Preston
    Lancashire
    Segretario
    23 Muirfield Close
    Fulwood
    PR2 7EA Preston
    Lancashire
    British68468490001
    ARMSTRONG, Neil Patrick
    4 Euxton Hall Gardens
    Euxton
    PR7 6PB Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    4 Euxton Hall Gardens
    Euxton
    PR7 6PB Chorley
    Lancashire
    Irish104897110001
    BROOKES, Philip
    Tudor House
    Lime Tree Avenue
    LS23 6DP Boston Spa
    West Yorkshire
    Amministratore
    Tudor House
    Lime Tree Avenue
    LS23 6DP Boston Spa
    West Yorkshire
    United KingdomBritish89559990001
    BROWN, David Robertson
    11 Dorchester Road
    Fixby
    HD2 2JZ Huddersfield
    Amministratore
    11 Dorchester Road
    Fixby
    HD2 2JZ Huddersfield
    United KingdomBritish39067610002
    BROWN, John Ernest
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish11806560001
    CAROLAN, Peter Vincent
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Amministratore
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Irish62299930001
    COCKER, Neil David
    5 Rossett Close
    Kingsmead
    CW9 8WP Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    5 Rossett Close
    Kingsmead
    CW9 8WP Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish260158230001
    DARBYSHIRE, John Peter
    12 Salisbury Drive
    M25 0HU Prestwich
    Manchester
    Amministratore
    12 Salisbury Drive
    M25 0HU Prestwich
    Manchester
    British69930320002
    FOX, Kenneth
    5 Sandiacre
    Standish
    WN6 0TJ Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    5 Sandiacre
    Standish
    WN6 0TJ Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish15540580001
    FRASER, Richard
    4 Severn Hill
    Fulwood
    PR2 3RD Preston
    Lancashire
    Amministratore
    4 Severn Hill
    Fulwood
    PR2 3RD Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish79090001
    GREENHALGH, Donald
    The Hayricks
    Bolton Road
    PR6 9HN Anderton
    Lancashire
    Amministratore
    The Hayricks
    Bolton Road
    PR6 9HN Anderton
    Lancashire
    British47084170002
    GREENOUGH, Michael Robert
    Millstone Cottage
    Bolton Road
    PR6 9HJ Anderton
    Lancashire
    Amministratore
    Millstone Cottage
    Bolton Road
    PR6 9HJ Anderton
    Lancashire
    British53010640001
    GRICE, Ian Michael
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    Amministratore
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    United KingdomBritish44883010002
    JACKSON, Andrew Philip
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    Amministratore
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    EnglandBritish7921750002
    LANSOM, Stewart Paul
    23 Park Street
    FY8 5LU Lytham
    Lancashire
    Amministratore
    23 Park Street
    FY8 5LU Lytham
    Lancashire
    British79070008
    LAVELLE, Dominic Joseph
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    Amministratore
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    United KingdomBritish137285750001
    LAWLESS, Dennis Arthur
    14 Sevenoaks
    PR7 3NS Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    14 Sevenoaks
    PR7 3NS Chorley
    Lancashire
    British46658890003
    LEACH, William Anthony
    17 Claybank Drive
    Tottington
    BL8 4BU Bury
    Lancashire
    Amministratore
    17 Claybank Drive
    Tottington
    BL8 4BU Bury
    Lancashire
    British66732560001
    MEADOWS, John
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    Amministratore
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    EnglandBritish101833160001
    MEMMOTT, Robert William
    Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    British109306950001
    MILLS, Lee James
    4 Kings Court
    CM23 2AA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Kings Court
    CM23 2AA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish53951880001
    O'BRIEN, Neil Christopher
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    British58219210001
    ROWAN, Michael William
    Jinbabyne 1 Field Farm Drive
    Edingale
    B79 9LF Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Jinbabyne 1 Field Farm Drive
    Edingale
    B79 9LF Tamworth
    Staffordshire
    British72210350002
    RYAN, Daniel Joseph
    Button Mill
    Inglewhite
    PR3 2LE Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Button Mill
    Inglewhite
    PR3 2LE Preston
    Lancashire
    British1472220001
    RYAN, John Timothy Anthony
    Bank Hall
    Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    Bank Hall
    Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    British39428900001
    RYAN, Michael Bernard
    Stafford House 102 Victoria Road
    Fulwood
    PR2 4NN Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Stafford House 102 Victoria Road
    Fulwood
    PR2 4NN Preston
    Lancashire
    British779240001
    SIMCOCK, Barry
    24 Poplar Drive
    ST3 3AZ Blurton
    Staffordshire
    Amministratore
    24 Poplar Drive
    ST3 3AZ Blurton
    Staffordshire
    British74253700001
    WILKINS, Andrew Michael
    PR25
    Amministratore
    PR25
    United KingdomBritish125411390001
    AM NOMINEES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Amministratore
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    34427260007

    ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Chattels mortgage
    Creato il 05 set 2001
    Consegnato il 05 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattles plant machinery, 16 compressor & generator systems, 2 x computer servers (for further details please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 05 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 12 feb 1992
    Consegnato il 21 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises situate in station road pembroke dyfed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 gen 1992
    Consegnato il 05 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north west side of rough hey road preston lancashire t/n la 585346.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 gen 1992
    Consegnato il 05 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north east side of rough hey road, preston, lancashire. T/n la 525 287.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 gen 1992
    Consegnato il 05 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All those premises known as longridge foundry, inglewhite road, (formerly higher lane) longridge, lancashire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 gen 1992
    Consegnato il 05 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Please see doc form M395 reference M198C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 05 apr 1991
    Consegnato il 16 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 172590.30 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All right title & interest in & to all sums payable (including by way of refund) under the insurance whereof are set out on form 395 (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 16 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 10 feb 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 24 gen 1990
    Consegnato il 08 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future includin book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 10 feb 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 ago 1988
    Consegnato il 01 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises situated off rough hey road, preston.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 feb 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 apr 1988
    Consegnato il 14 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north east side of rough hey road preston.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 feb 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 14 dic 1971
    Consegnato il 22 dic 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and premises at longridge foundry, longridge in the county of lancaster with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 10 feb 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0