VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED

VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00525186
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DOEFLEX INDUSTRIES LIMITED30 ott 195330 ott 1953

    Quali sono gli ultimi bilanci di VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Memorandum e Statuto

    13 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Stato del capitale al 12 ott 2021

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 11 ott 2021

    • Capitale: GBP 1,173,110
    3 pagineSH01

    Stato del capitale al 08 ott 2021

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 07 ott 2021

    • Capitale: GBP 11,427,644
    3 pagineSH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2020 al 28 feb 2021

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian William Robb il 16 lug 2021

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Stato del capitale al 06 nov 2020

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    4 pagineSH20

    legacy

    4 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 03/11/2020
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VITA INDUSTRIAL (UK) LIMITED
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Segretario
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione1031815
    109599980003
    O'RIORDAN, Daniel Joseph, Mr.
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    EnglandBritish176979900001
    ROBB, Ian William
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    United KingdomBritish263073080001
    ROUND, Darren Lee
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    EnglandBritish100922110001
    SHAFI KHAN, Mohammed Omar
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    United KingdomBritish239506860001
    DENT, John
    Hazeldene Station Approach East
    Earlswood
    RH1 6JH Redhill
    Surrey
    Segretario
    Hazeldene Station Approach East
    Earlswood
    RH1 6JH Redhill
    Surrey
    British12774290001
    STIRZAKER, Mark Robert
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    Segretario
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    British78366970002
    TEAGUE, Alan Richard
    26 Orchard Street
    Stockton Heath
    WA4 6LH Warrington
    Segretario
    26 Orchard Street
    Stockton Heath
    WA4 6LH Warrington
    British290650004
    TRENDELL, William Anthony
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    Segretario
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    British12317760001
    BICKERTON, Richard Henry Cheetham
    Send Grove
    Church Lane, Send
    GU23 7JL Woking
    Surrey
    Amministratore
    Send Grove
    Church Lane, Send
    GU23 7JL Woking
    Surrey
    EnglandBritish12360020001
    BURLEY, Nicholas James
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Amministratore
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    United KingdomBritish122799590001
    CHEELE, Jonathan Mark
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    EnglandBritish127959950003
    DAVIES, Michael Gomer
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Amministratore
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    UkBritish154115450002
    DURKIN, Thomas Frederick
    An Cala
    5 Dover Road, Branksome Park
    BH13 6DZ Poole
    Amministratore
    An Cala
    5 Dover Road, Branksome Park
    BH13 6DZ Poole
    EnglandBritish83598360002
    ECCLES, Colin
    Fourwinds 23 Sandilands
    CR0 5DF Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Fourwinds 23 Sandilands
    CR0 5DF Croydon
    Surrey
    British12360030001
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Belvedere Lodge
    18 Highbury Road Wimbledon Village
    SW19 7PR London
    Amministratore
    Belvedere Lodge
    18 Highbury Road Wimbledon Village
    SW19 7PR London
    EnglandBritish105961550001
    HARRIS, Howard Elliott
    15 Queen's Gate Gardens
    SW7 5LY London
    Amministratore
    15 Queen's Gate Gardens
    SW7 5LY London
    British93378750001
    HAY, Nigel Bruce
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    United KingdomBritish124316170001
    JOHNSON, David John
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Amministratore
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    United KingdomBritish150755940001
    MAUNDRELL, Graham Lloyd
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    United KingdomBritish56093930002
    MELTHAM, John David
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    United KingdomBritish74570910001
    O'CONNOR, Calvin James John
    10 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6SZ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    10 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6SZ Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish16253240001
    STIRZAKER, Mark Robert
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    EnglandBritish78366970002
    TEAGUE, Alan Richard
    26 Orchard Street
    Stockton Heath
    WA4 6LH Warrington
    Amministratore
    26 Orchard Street
    Stockton Heath
    WA4 6LH Warrington
    British290650004
    TRENDELL, William Anthony
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    EnglandBritish12317760001
    WRIGHT, Paul Martin
    c/o Vita Cellular Foams (Uk) Limited
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    N/A
    England
    Amministratore
    c/o Vita Cellular Foams (Uk) Limited
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    N/A
    England
    UkBritish150691780001

    Chi sono le persone con controllo significativo di VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Vita (Group) Unlimited
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    06 apr 2016
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Unlimited Company
    Paese di registrazioneU.K.
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneUk Companies House
    Numero di registrazione871669
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    VITA DORMANT INDUSTRIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Chattel mortgage
    Creato il 01 mag 1995
    Consegnato il 09 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Mixer combination -papenmeier- TSHK750 mixer/KGU2500 cooler serial no 5277 two screw extruder - battenfield - serial no 89 -8172 -51. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 24 mar 1995
    Consegnato il 06 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Mixer combination - paper meir 5277 two screw extruder - battenfeld 89-8172-51. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of pledge of goods with third party pledgee
    Creato il 24 nov 1994
    Consegnato il 28 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter dated 14TH september 1994 for a term loan in the amount of bef 49,000,000
    Brevi particolari
    Line no.2 Specialised thin polypropylene line incorporating the pieces of machinery listed on the schedule to the form 395. all pieces of machinery are located at the premises of horizon industries N.V. at kruinegemstraat 92, 9200 schoten belguim. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kredietbank Nv
    Transazioni
    • 28 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 ott 1991
    Consegnato il 07 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or hereafter to become due from the company to the bank on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage all the f/h and l/h property of the company. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 nov 1987
    Consegnato il 07 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 28 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 dic 1985
    Consegnato il 30 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land on the north side of holmethorpe avenue, reigate, surrey t/n - sy 161638.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 28 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 lug 1984
    Consegnato il 30 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold 42/44 holmethorpe avenue redhill surrey title no sy 508628.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 28 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further guarantee debenture
    Creato il 02 feb 1981
    Consegnato il 11 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed & further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 mar 1980
    Consegnato il 09 apr 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or kensingear limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital, with all buildings, fixtures fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 dic 1967
    Consegnato il 09 gen 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 75000
    Brevi particolari
    Land factory & premises at holmethorpe redhill & land factory & premises 145 frenches rd, redhill.
    Persone aventi diritto
    • Phoenix Assurance Company LTD
    Transazioni
    • 09 gen 1968Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 13 giu 1960
    Consegnato il 02 giu 1960
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due etc
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and goodwill present and future including uncalled capital. See doc 25 for details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1960Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0