WORTHINGTON GROUP PLC

WORTHINGTON GROUP PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWORTHINGTON GROUP PLC
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 00527186
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di WORTHINGTON GROUP PLC?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova WORTHINGTON GROUP PLC?

    Indirizzo della sede legale
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WORTHINGTON GROUP PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    A J WORTHINGTON (HOLDINGS) P L C23 dic 195323 dic 1953

    Quali sono gli ultimi bilanci di WORTHINGTON GROUP PLC?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2014
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2015
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2013

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per WORTHINGTON GROUP PLC?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al25 ago 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma08 set 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WORTHINGTON GROUP PLC?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per WORTHINGTON GROUP PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    21 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    21 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    20 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    23 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    23 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    21 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    21 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    24 pagineWU07

    Cessazione della carica di Richard James Spurway come amministratore in data 19 apr 2018

    2 pagineTM01

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    26 pagineWU07

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 the Green Richmond Surrey TW9 1PL a 31st Floor 40 Bank Street London E14 5NR in data 20 gen 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Soddisfazione dell'onere 005271860028 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 25 ago 2015, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 set 2015

    Stato del capitale al 17 set 2015

    • Capitale: GBP 2,501,650.9
    SH01

    Ordinanza giudiziaria

    S1096 Court Order to Rectify
    1 pagineOC

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard James Sturway il 08 set 2015

    2 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Bilancio annuale redatto al 25 ago 2014, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 set 2014

    Stato del capitale al 23 set 2014

    • Capitale: GBP 1,449,878.3
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2013

    48 pagineAA

    legacy

    pagineANNOTATION

    Soddisfazione dell'onere 19 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 26 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 23 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 21 in pieno

    2 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di WORTHINGTON GROUP PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PD COSEC LIMITED
    The Green
    TW9 1PL Richmond
    1
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    The Green
    TW9 1PL Richmond
    1
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione05399859
    149562640001
    WARE, Douglas
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    Amministratore
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    EnglandBritish13603170002
    FLETCHER, Stephen George
    11 Methuen Drive
    Hoghton
    PR5 0JL Preston
    Lancashire
    Segretario
    11 Methuen Drive
    Hoghton
    PR5 0JL Preston
    Lancashire
    British13233990001
    HENDERSON, Susan Margaret
    14 Lyndhurst Avenue
    HA5 3XA Pinner
    Middlesex
    Segretario
    14 Lyndhurst Avenue
    HA5 3XA Pinner
    Middlesex
    British64890002
    KAYE, Gavin Mark
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    Segretario
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    British128648070001
    MARTIN, Ian
    2 Beechwood Drive
    BD23 1TY Skipton
    North Yorkshire
    Segretario
    2 Beechwood Drive
    BD23 1TY Skipton
    North Yorkshire
    British35379130001
    ROBERTS, Timothy Guy
    Honeycroft
    1 Gaddum Road
    WA14 3PD Bowdon
    Cheshire
    Segretario
    Honeycroft
    1 Gaddum Road
    WA14 3PD Bowdon
    Cheshire
    British127918950001
    SHALOM, David Michael
    9 Valley Road
    SK8 1HY Cheadle
    Cheshire
    Segretario
    9 Valley Road
    SK8 1HY Cheadle
    Cheshire
    British34345460001
    WORTHINGTON, Philip Michael
    The Knoll House
    Knossington
    LE15 8LT Oakham
    Leicestershire
    Segretario
    The Knoll House
    Knossington
    LE15 8LT Oakham
    Leicestershire
    British15236190001
    COOKE, Anthony Ralph
    Lebanon Park
    TW1 3DF Twickenham
    21
    United Kingdom
    Amministratore
    Lebanon Park
    TW1 3DF Twickenham
    21
    United Kingdom
    United KingdomBritish84639890001
    DWEK, Joseph Claude
    Hill Top
    Hale
    WA15 0NJ Altrincham
    The Coppins 16
    Cheshire
    Amministratore
    Hill Top
    Hale
    WA15 0NJ Altrincham
    The Coppins 16
    Cheshire
    United KingdomBritish140172170001
    DWEK, Joseph Claude
    Hill Top
    Hale
    WA15 0NJ Altrincham
    The Coppins 16
    Cheshire
    Amministratore
    Hill Top
    Hale
    WA15 0NJ Altrincham
    The Coppins 16
    Cheshire
    United KingdomBritish140172170001
    EDELSON, John Michael
    17 Carrwood
    WA15 0ED Hale Barns
    Cheshire
    Amministratore
    17 Carrwood
    WA15 0ED Hale Barns
    Cheshire
    EnglandBritish28353840001
    FLETCHER, Stephen George
    11 Methuen Drive
    Hoghton
    PR5 0JL Preston
    Lancashire
    Amministratore
    11 Methuen Drive
    Hoghton
    PR5 0JL Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish13233990001
    FOSTER, Peter William, Professor
    Lindisfarne 6 Aldford Place
    SK9 7RQ Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    Lindisfarne 6 Aldford Place
    SK9 7RQ Alderley Edge
    Cheshire
    United KingdomBritish45817840001
    FRIEDLAND, Sidney
    53 Broadway
    SK8 1LB Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    53 Broadway
    SK8 1LB Cheadle
    Cheshire
    British2107950001
    GORMAN, Seymour
    Compton House
    94 Winnington Road
    N2 0TU London
    Amministratore
    Compton House
    94 Winnington Road
    N2 0TU London
    EnglandBritish1424810001
    GRANT, Jack
    21 Clarence Terrace
    NW1 4RD London
    Amministratore
    21 Clarence Terrace
    NW1 4RD London
    EnglandBritish16265410001
    GREEN, Roger Michael
    16 Green Lane
    SK12 1TJ Poynton Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    16 Green Lane
    SK12 1TJ Poynton Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish904310002
    HULME, James Douglas
    Oaken Bank Farm
    Oakenbank Lane, Rainow
    SK10 5RP Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Oaken Bank Farm
    Oakenbank Lane, Rainow
    SK10 5RP Macclesfield
    Cheshire
    British65509800001
    KAYE, Gavin Mark
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    Amministratore
    Juniper Gardens
    Shenley
    WD7 9LA Radlett
    19
    Hertfordshire
    United KingdomBritish128648070001
    KNOBIL, Henry Eric
    Flat 3
    One Hyde Park Street
    W2 2JW London
    Amministratore
    Flat 3
    One Hyde Park Street
    W2 2JW London
    British21651570001
    ROBERTS, Timothy Guy
    Honeycroft
    1 Gaddum Road
    WA14 3PD Bowdon
    Cheshire
    Amministratore
    Honeycroft
    1 Gaddum Road
    WA14 3PD Bowdon
    Cheshire
    United KingdomBritish127918950001
    SCHULDENFREI, Henry
    7 Fairholme Close
    Finchley
    N3 3EE London
    Amministratore
    7 Fairholme Close
    Finchley
    N3 3EE London
    British37095850001
    SHALOM, David Michael
    9 Valley Road
    SK8 1HY Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    9 Valley Road
    SK8 1HY Cheadle
    Cheshire
    EnglandBritish34345460001
    SIMPSON, David Joseph
    Temple Chambers
    3-7 Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    196
    United Kingdom
    Amministratore
    Temple Chambers
    3-7 Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    196
    United Kingdom
    EnglandBritish168850460001
    SMITH, John Keith
    Longdale House
    Wincle
    SK11 0QJ Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Longdale House
    Wincle
    SK11 0QJ Macclesfield
    Cheshire
    British116274660001
    SPURWAY, Richard James
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    Amministratore
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    EnglandBritish92410650002
    TAYLOR, John Ramsden
    The Green
    TW9 1PL Richmond
    1
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    The Green
    TW9 1PL Richmond
    1
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandEnglish453400002
    TAYLOR, John Ramsden
    The Green
    TW9 1PL Richmond
    1
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    The Green
    TW9 1PL Richmond
    1
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandEnglish453400002
    TAYLOR, John Ramsden
    Woodville House
    Harry Lane, Oxenhope
    BD22 9JW Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodville House
    Harry Lane, Oxenhope
    BD22 9JW Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish453400002
    TOWNSEND, Peter
    Linden Gardens
    TN2 5QT Tunbridge Wells
    22
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Linden Gardens
    TN2 5QT Tunbridge Wells
    22
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish92881110002
    WORTHINGTON, Philip Michael
    The Knoll House
    Knossington
    LE15 8LT Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    The Knoll House
    Knossington
    LE15 8LT Oakham
    Leicestershire
    British15236190001

    WORTHINGTON GROUP PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 13 ago 2013
    Consegnato il 20 ago 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    F/H land and buildings to the south east of bradford road keighley west yorkshire t/no WYK398057. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Advanced Industrial Technology Corporation Limited
    Transazioni
    • 20 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 gen 2013
    Consegnato il 01 feb 2013
    In corso
    Importo garantito
    £475,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Renatus Capital LTD
    Transazioni
    • 01 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 20 ago 2002
    Consegnato il 28 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 11 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 06 ott 1999
    Consegnato il 15 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the finance documents
    Brevi particolari
    F/H land k/a 449 and 451 high road and land and buildings on the north side of glebe road willesden t/n NGL674251 for further details see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transazioni
    • 15 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over deposit
    Creato il 02 set 1999
    Consegnato il 17 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    £250,000 deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 02 set 1999
    Consegnato il 17 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 11 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 21 ago 1998
    Consegnato il 04 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    449 and 451 high road and land and buildings on the north side of glebe road willesden t/no: NGL674251 f/h land being britannia mill, manchester road mossley t/no: GM748285 f/h land and buildings on the west side of park lane macclesfield t/no: CH306446 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bny International Limited
    Transazioni
    • 04 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 21 ago 1998
    Consegnato il 03 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    449 and 451 high road and land and buildings on the north side of glebe road willesden, britannia mill manchester road mossley, davenport street works davenport street macclesfield, land on the west side of green street macclesfield (for further details of all property charged and title numbers please refer to form 395). and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 21 dic 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 11 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 21 ago 1998
    Consegnato il 03 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 26 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 lug 1997
    Consegnato il 05 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 108, 110, 116, 118, 124, 126 t/n-CH268353, CH132485, CH352734, CH365919 and part of unregistered lane k/a numbers 106, 112, 114 and 120 davenport street macclesfield, together with all fixtures and fittings, the benefits of all rights licences and the goodwill of the business.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 11 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 20 mar 1997
    Consegnato il 02 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property at low march long march industrial estate daventry northamptonshire (freehold) t/no.NN113508 with the benefit of all rights,licences,guarantees,any goodwill of any business,any rental and other money and all other payments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 mar 1997
    Consegnato il 02 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property at britannia works manchester road mossley greater manchester (freehold) with the benefit of all rights,licences,guarantees,any goodwill of any business,any rental and other money and all other payments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 09 apr 1996
    Consegnato il 11 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 449/451 high road willesden london benefit of all rights contracts deeds licences deeds undertakings assigns goodwill to the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 lug 1995
    Consegnato il 03 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/as hurdsfield mills fence avenue and hurdsfield road and land to the north west side of fence avenue maccesfield t/nos CH368053 & CH335105. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 lug 1995
    Consegnato il 03 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/as portland & queen mills queen street leek t/no SF800893. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 lug 1995
    Consegnato il 03 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/as park lane mills west side of park lane macclesfield t/no CH306446. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 lug 1995
    Consegnato il 03 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/as 15 park lane macclesfield t/no CH133532. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 lug 1995
    Consegnato il 03 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/as davenport street works davenport street macclesfield t/no CH172420. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 31 lug 1995
    Consegnato il 03 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 ott 1994
    Consegnato il 13 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land at hurdsfield mills fence avenue and hurdsfield road t/n CH368053 and east side of fence avenue t/n CH335105 benefit of any covenant agreement or undertaking rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 ott 1994
    Consegnato il 13 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 ott 1994
    Consegnato il 13 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a portland mills and queen mill street leek staffordshire t/n SF300893 benefit of any covenant agreement right or undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 ott 1994
    Consegnato il 13 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 15 park lane macclesfield t/n CH133532 benefit of any cocenants rights agreement undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 03 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land to north east of fence avenue macclesfield cheshire.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais Bank Nederland N.V.
    Transazioni
    • 03 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 03 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property part of hurdsfield mills macclesfield bounded on south west side by fence avenue and on north west by arbauhay street.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais Bank Nederland N.V.
    Transazioni
    • 03 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WORTHINGTON GROUP PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 ago 2016Data della petizione
    21 nov 2016Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor 31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    Begbies Traynor 31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Irvin Milton Cohen
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praticante
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0