PME TECHNICAL SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PME TECHNICAL SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Liquidazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00531085 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PME TECHNICAL SERVICES LIMITED?
- Installazione elettrica (43210) / Costruzioni
Dove si trova PME TECHNICAL SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PME TECHNICAL SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CARILLION TECHNICAL SERVICES LIMITED | 24 mag 2006 | 24 mag 2006 |
| MOWLEM TECHNICAL SERVICES LIMITED | 10 feb 2004 | 10 feb 2004 |
| DUDLEY BOWER SERVICES LIMITED | 15 ago 2000 | 15 ago 2000 |
| DUDLEY BOWER BUILDING SERVICES LTD | 31 ott 1995 | 31 ott 1995 |
| DUDLEY BOWER MIDLANDS (INC.R.H. MURCOTT) LTD. | 10 mar 1994 | 10 mar 1994 |
| R.H. MURCOTT LIMITED | 27 mar 1954 | 27 mar 1954 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PME TECHNICAL SERVICES LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2017 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2018 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per PME TECHNICAL SERVICES LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 31 mar 2018 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 14 apr 2018 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 31 mar 2017 |
| Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per PME TECHNICAL SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzo della sede legale modificato da Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 19 lug 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX in data 01 ott 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Dudley Bower Group Plc come persona con controllo significativo il 01 ott 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lee James Mills come amministratore in data 18 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Westley Maffei come segretario in data 04 giu 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Westley Maffei come amministratore in data 04 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Ordine del tribunale di liquidazione | 3 pagine | COCOMP | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard John Howson come amministratore in data 15 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Zafar Iqbal Khan come amministratore in data 11 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Westley Maffei come amministratore in data 01 lug 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Westley Maffei come segretario in data 01 lug 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Francis George come segretario in data 30 giu 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Francis George come amministratore in data 30 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Hayward come amministratore in data 06 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Zafar Iqbal Khan il 01 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard John Adam come amministratore in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Zafar Iqbal Khan il 31 mar 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Hayward il 02 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Zafar Iqbal Khan il 02 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PME TECHNICAL SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLSON, Hilary Myra | Segretario | 38 All Saints Close Glebe Park RG40 1WE Wokingham Berkshire | British | 42871570001 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 169302590001 | |||||||
| JONES, Trevor | Segretario | 40 Fairhaven Avenue Shirley CR0 7RX Croydon Surrey | British | 58233430001 | ||||||
| MAFFEI, Westley | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 235170780001 | |||||||
| RACKHAM, Annette | Segretario | 32 Denny Avenue EN9 1NS Waltham Abbey Essex | British | 20988170003 | ||||||
| CARILLION SECRETARIAT LIMITED | Segretario | 24 Birch Street WV1 4HY Wolverhampton West Midlands | 33743910002 | |||||||
| ADAM, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| BOOKER, Robin Hilary | Amministratore | Copperfield House Dickens Close TW10 7AU Petersham Surrey | England | British | 52790300001 | |||||
| DAY, Stephen John | Amministratore | Becca House Becca Lane Aberford LS25 3BD Leeds | England | British | 59028300002 | |||||
| GEORGE, Timothy Francis | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 24075160004 | |||||
| HAYWARD, Alan | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 154549030001 | |||||
| HOWSON, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 147650310001 | |||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| LEWIS, Richard Norman | Amministratore | Pari Westerham Road BR2 6HH Keston Kent | British | 2914640001 | ||||||
| MAFFEI, Westley Anthony | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 189962560002 | |||||
| MCGRORY, Jack | Amministratore | 12 Woodlands Park Scarcroft LS14 3JU Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 96596920001 | |||||
| MCMULLEN, Martin Alexander | Amministratore | The Gleddings Common Hill RH20 2NL West Chiltington West Sussex | England | British | 37470200001 | |||||
| MERCER, Emma Louise | Amministratore | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | British | 163383420001 | |||||
| MILLS, Lee James | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 53951880001 | |||||
| MOLONEY, Jeremiah Joseph | Amministratore | 75 Main Street LE12 5D Long Whatton Leicestershire | England | British | 250942820001 | |||||
| MOORE, Roger Patrick Jonas | Amministratore | 6 Cherwell Road Emmer Green RG4 8QH Reading Berkshire | England | British | 64732960001 | |||||
| MURCOTT, Robert James | Amministratore | 7a Main Street Long Whatton LE12 5DF Loughborough Leicestershire | British | 31335720001 | ||||||
| O'SULLIVAN, John Paul | Amministratore | 44 Oaklands Avenue WD19 4LW Oxhey Watford | England | British | 148987290001 | |||||
| SPANN, Neil | Amministratore | Regent Farm Road Gosforth NE3 3AF Newcastle Upon Tyne Partnership House United Kingdom | United Kingdom | British | 154870250001 | |||||
| WATSON, Alan | Amministratore | Bower Lodge Cottage Holtye Road Hammerwood RH19 3QE East Grinstead West Sussex | British | 76504780001 | ||||||
| WEBBER, Robert Denis | Amministratore | Little Willows Fairstead Road Terling CM3 2BU Chelmsford Essex | British | 44638250001 | ||||||
| WILTON, Steven William | Amministratore | 3 The Pointers Stag Leys KT21 2TH Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 33112080001 | |||||
| CARILLION MANAGEMENT LIMITED | Amministratore | 24 Birch Street WV1 4HY Wolverhampton West Midlands | 36778210004 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PME TECHNICAL SERVICES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudley Bower Group Plc | 06 apr 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
PME TECHNICAL SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 17 ott 1986 Consegnato il 24 ott 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental charge | Creato il 14 gen 1983 Consegnato il 26 gen 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 7.9.72 | |
Brevi particolari A specific charge over the benefit of all book debts and other debts now or on the future owing to the company but so that the company shall pay into the company account with the bank all monies which it may receive in respect of such debt. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
PME TECHNICAL SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione coatta |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0