MOTHERCARE UK LIMITED

MOTHERCARE UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMOTHERCARE UK LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00533087
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di MOTHERCARE UK LIMITED?

    • Altra vendita al dettaglio di nuovi beni in negozi specializzati (non gallerie d'arte commerciali e ottici) (47789) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Vendita al dettaglio tramite case d'ordine per corrispondenza o tramite Internet (47910) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova MOTHERCARE UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MOTHERCARE UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    M. KAPLAN & COMPANY LIMITED08 mag 195408 mag 1954

    Quali sono gli ultimi bilanci di MOTHERCARE UK LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al29 mar 2019
    Scadenza dei prossimi bilanci il29 dic 2019
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al24 mar 2018

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MOTHERCARE UK LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al26 nov 2019
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma10 dic 2019
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al26 nov 2018
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per MOTHERCARE UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2025

    29 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2024

    28 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2023

    30 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Kevin Jonathan Rusling come amministratore in data 17 apr 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew Cook come amministratore in data 17 apr 2023

    2 pagineAP01

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    pagineAM22

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    37 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    34 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    33 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    37 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    34 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Cessazione della carica di Mark Newton-Jones come amministratore in data 23 lug 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Kirsty Rowena Homer come amministratore in data 29 mag 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di William Glyn Lawrence Hughes come amministratore in data 30 giu 2020

    1 pagineTM01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Indirizzo della sede legale modificato da Cherry Tree Road Watford Hertfordshire WD24 6SH a C/O Pricewaterhousecoopers Llp Central Square 29 Wellington Street Leeds Ls1 in data 14 mag 2020

    2 pagineAD01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    4 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    56 pagineAM03

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    26 pagineAM02

    Nomina di un amministratore

    4 pagineAM01

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 005330870015

    5 pagineMR05

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 10

    5 pagineMR05

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 12

    5 pagineMR05

    Chi sono gli amministratori di MOTHERCARE UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MEDINI, Lynne Samantha
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    Segretario
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    199702430001
    COOK, Andrew
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    Amministratore
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    United KingdomBritish206420070001
    ASHBY, Timothy John
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    Segretario
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    British162876770001
    REVETT, Clive Edward
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    Segretario
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    British16023450001
    ADAMS, Peter
    10 Larchwood Glade
    GU15 3UW Camberley
    Surrey
    Amministratore
    10 Larchwood Glade
    GU15 3UW Camberley
    Surrey
    British15235270001
    ASHBY, Tim
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    EnglandBritish169516530001
    ASTBURY, Colin Roy
    The Old School
    Priors Hardwick
    CV47 7SL Southam
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old School
    Priors Hardwick
    CV47 7SL Southam
    Warwickshire
    British86834500001
    BERKMEN, Gillian
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    GbBritish92154270001
    BRIDGE, Jude Claire
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    UkBritish197887820001
    CALVER, Simon John
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    EnglandBritish187665800001
    CARR, Anthony John
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    EnglandBritish89979900002
    CLIFFORD KING, Alison Jane
    40 Kings Road
    HP8 4HS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    40 Kings Road
    HP8 4HS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British49588040001
    CULL, Christopher Jeremy
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    United KingdomBritish109895710001
    DAVIES, Elzbieta Krystyna
    Gravee Du Sud
    The Grange
    GY1 1RP St Peter Port
    Guernsey
    Amministratore
    Gravee Du Sud
    The Grange
    GY1 1RP St Peter Port
    Guernsey
    British115958830001
    DAVIES, Phillip John
    Flat 1 61 Redington Road
    Hampstead
    NW3 7RP London
    Amministratore
    Flat 1 61 Redington Road
    Hampstead
    NW3 7RP London
    British59591810001
    DAYRAUD, Philippe Jean Camille
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    FranceFrench176329390002
    DOYLE, Karl Andrew
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    EnglandBritish188719260001
    EVANS, Christine Helen
    23 Station Road
    Desford
    LE9 9FN Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    23 Station Road
    Desford
    LE9 9FN Leicester
    Leicestershire
    British106621860001
    GLANVILLE, Richard Spencer
    25 Roseberry Court
    WD1 3PQ Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    25 Roseberry Court
    WD1 3PQ Watford
    Hertfordshire
    British69669910001
    GLEW, Steven Peter
    22 Firs Walk
    Tewin Wood
    AL6 0NZ Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    22 Firs Walk
    Tewin Wood
    AL6 0NZ Welwyn
    Hertfordshire
    British88254510001
    GORDON, Joseph Benjamin
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    United KingdomBritish86319620002
    GREENHALGH, Adrian Timothy John
    Meadow House Chapel Lane
    Chilton
    HP18 9LP Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Meadow House Chapel Lane
    Chilton
    HP18 9LP Aylesbury
    Buckinghamshire
    British29572280001
    GUNN, Vincent Anthony
    5 Lady Place High Street
    Sutton Courtenay
    OX14 4FB Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    5 Lady Place High Street
    Sutton Courtenay
    OX14 4FB Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish74448910001
    HARRINGTON, Neil Simon
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    EnglandBritish110719850001
    HOMER, Kirsty Rowena
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    Amministratore
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    United KingdomBritish235620910001
    HUGHES, Simon Donnell
    Rosebank 36 Chelmsford Road
    Shenfield
    CM15 8RJ Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Rosebank 36 Chelmsford Road
    Shenfield
    CM15 8RJ Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish258735520001
    HUGHES, William Glyn Lawrence
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    Amministratore
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 Leeds
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp
    EnglandBritish240796440002
    IVERSON, Ann
    20 Abbey Road Flat 3
    St.Johns Wood
    NW8 London
    Amministratore
    20 Abbey Road Flat 3
    St.Johns Wood
    NW8 London
    American36255620001
    JAMES, Anna Katherine
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    United KingdomBritish155223320001
    JAMES, Anna Katherine
    1 Horbury Crescent
    W11 3NF London
    Greater London
    Amministratore
    1 Horbury Crescent
    W11 3NF London
    Greater London
    British106621810001
    KIBBLE, Gary
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    United KingdomBritish196289960002
    KING, Andrew James
    6 Courtneidge Close
    LU7 0EL Stewkley
    Bedfordshire
    Amministratore
    6 Courtneidge Close
    LU7 0EL Stewkley
    Bedfordshire
    British78266330001
    KITCHEN, Philip John
    3 Greenswood
    Bearley
    CV37 0SU Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    3 Greenswood
    Bearley
    CV37 0SU Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British49725200002
    LANGLEY, Michael Frederick
    7 Claremont Road
    TW11 8DH Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    7 Claremont Road
    TW11 8DH Teddington
    Middlesex
    British19151780001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    Watford
    WD24 6SH Hertfordshire
    United KingdomBritish137285750001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MOTHERCARE UK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mothercare (Holdings) Limited
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Cherry Tree Road
    England
    06 apr 2016
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Cherry Tree Road
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione1289339
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    MOTHERCARE UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 17 mag 2018
    Consegnato il 23 mag 2018
    In corso
    Breve descrizione
    UK trademark registration no 855429 and those assets listed in the instrument. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 23 mag 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 mag 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 17 mag 2018
    Consegnato il 23 mag 2018
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 23 mag 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 05 mag 2017
    Consegnato il 10 mag 2017
    In corso
    Breve descrizione
    UK trademark registration no 855429 and those assets listed in the instrument. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 10 mag 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 mag 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 05 mag 2017
    Consegnato il 10 mag 2017
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 10 mag 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A share mortgage
    Creato il 18 mag 2012
    Consegnato il 30 mag 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares, being- 10,000 ordinary shares of hk$1 each in the issued share capital of mihkl see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Security agreement
    Creato il 11 apr 2012
    Consegnato il 26 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 mag 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 apr 2012
    Consegnato il 20 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Brookshire Capital LLP
    Transazioni
    • 20 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Security assignment
    Creato il 16 mag 2011
    Consegnato il 02 giu 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H 28 and 29 high street doncaster t/n SYK68561. F/h part of 114 high road ilford t/n NGL199098. F/h 55-57 bridge street peterborough t/n CB92309, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future (for details of further properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 mag 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Security agreement
    Creato il 16 mag 2011
    Consegnato il 20 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All land, equipment, authorisations, insurances, contractual rights and other assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 20 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security deed
    Creato il 26 apr 2010
    Consegnato il 04 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The real property being- f/h propery k/a the commercial hotel, victoria square, bolton t/no LA309153. F/h property k/a 28 and 29 high street, doncaster t/no SYK68561. F/h property k/a part of 114 high road, ilford t/no NGL199098. (For further details of properties charged please refer to form MG01) and all buildings fixtures, fittings, fixed plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental security agreement supplemental to a debenture dated 12 may 2003 and
    Creato il 01 set 2003
    Consegnato il 18 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the obligors (as defined) to the chargee
    Brevi particolari
    In addition to the property charged under the original debenture l/h 5 and 7 staveleigh way ashton-under-lyme t/no LA232496, l/h 118 & 120 freeman street grimsby t/no HS147707, l/h 112A and part of 114 high road ilford t/no NGL199099 (for further details of property charged please see schedule to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 18 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security assignment
    Creato il 12 mag 2003
    Consegnato il 30 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the obligors (as defined) to the chargee
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in any freehold or leasehold land held by it together with floating charge all of it's assets not charge by way of fixed charge above. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 18 december 2001 and
    Creato il 12 nov 2001
    Consegnato il 29 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    122 union street aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 18 december 2001 and
    Creato il 12 nov 2001
    Consegnato il 29 dic 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    24 causeyside street paisley.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 18 december 2001 and
    Creato il 12 nov 2001
    Consegnato il 29 dic 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    149,151 and 153 high street ayr.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 11 ott 2000
    Consegnato il 14 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the guarantee of the obligations of mothercare PLC under the credit agreement dated 15TH august 2000
    Brevi particolari
    F/H 8/9 eastbank street southport.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ago 2000
    Consegnato il 24 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the credit agreement of even date
    Brevi particolari
    122 union street aberdeen for further properties - see schedule to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MOTHERCARE UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 giu 2018Data della riunione per approvare il CVA
    28 set 2018Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    James Robert Tucker
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    William James Wright
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    2
    DataTipo
    05 nov 2019Inizio dell'amministrazione
    08 nov 2022Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Robert Baxendale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Mark James Tobias Banfield
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    3
    DataTipo
    08 nov 2022Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    David Robert Baxendale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Mark James Tobias Banfield
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0