NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED

NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00533432
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15th Floor 6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione della carica di Lisa Susanne Gray come amministratore in data 15 lug 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Stato del capitale al 08 apr 2022

    • Capitale: GBP 3.131
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Sheraz Afzal come amministratore in data 06 apr 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Marie-Anne Bousaba come amministratore in data 29 mar 2022

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2021

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020

    8 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN England a 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA in data 12 nov 2020

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019

    8 pagineAA

    Nomina di Ms Lisa Gray come amministratore in data 06 set 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Sheraz Afzal come amministratore in data 06 set 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Justin Staadecker come amministratore in data 06 set 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Andrew James Smith come amministratore in data 08 mag 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Tony Deakin come amministratore in data 01 dic 2018

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ England a Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN in data 12 set 2018

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ASHLEY, Jonathan
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    Amministratore
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    EnglandAmerican243850150001
    BOUSABA, Marie-Anne
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    Amministratore
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    United KingdomAustralian293005440001
    BIONDI, Lorna
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    Segretario
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    196292540001
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Segretario
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    British61931900002
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Segretario
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    British61931900002
    GOLD, Nick
    126 Hamilton Terrace
    St John's Wood
    NW8 9UT London
    Segretario
    126 Hamilton Terrace
    St John's Wood
    NW8 9UT London
    British111562560001
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Segretario
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British64357220001
    HARRINGTON, Nicholas Joseph
    9 Kingsmead Avenue
    KT4 8XB Worcester Park
    Surrey
    Segretario
    9 Kingsmead Avenue
    KT4 8XB Worcester Park
    Surrey
    British1273670001
    MCKENZIE, Robbie
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Segretario
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    195400050001
    PAGE, Elizabeth
    Flat 3
    5 St Leonards Road, Ealing
    W13 8PN London
    Segretario
    Flat 3
    5 St Leonards Road, Ealing
    W13 8PN London
    British34006010001
    PRIOR, Mark Lee
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Segretario
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    178737250001
    REID, Michael John
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Segretario
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Irish950490001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Segretario
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    British62321110002
    WALTON, Caroline Debra
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Segretario
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    British151330230001
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish55757700003
    AFZAL, Sheraz
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    Amministratore
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    United KingdomBritish251073350001
    ATTALLAH, Naim Ibrahim
    Flat 15
    51 South Street
    W1Y 5PA London
    Amministratore
    Flat 15
    51 South Street
    W1Y 5PA London
    United KingdomBritish25646240001
    BERKMEN, Gillian
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    Amministratore
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    GbBritish92154270001
    BROWN, Andrew Saville
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    Amministratore
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    United KingdomBritish69874610002
    BRYAN, Robert Andrew
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Amministratore
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    EnglandBritish122733810001
    CLAYMAN, Paul Sidney
    18 Keepier Wharf
    12 Narrow Street
    E14 8DH London
    Amministratore
    18 Keepier Wharf
    12 Narrow Street
    E14 8DH London
    British14436120006
    COOPER, Caroline
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    Amministratore
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    British92733900001
    COREPAL, Sanjiv Kumar
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Amministratore
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    United KingdomBritish205239750001
    DAHL, Ian Xavier
    2 Heathfield Lodge
    Carron Lane
    GU29 9LD Midhurst
    West Sussex
    Amministratore
    2 Heathfield Lodge
    Carron Lane
    GU29 9LD Midhurst
    West Sussex
    British66486140001
    DEAKIN, Tony
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    Amministratore
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    United KingdomBritish210862440001
    ERICKSON, Eric George
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Amministratore
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    UsaUsa224104020001
    EVANS, Nicholas David
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    Amministratore
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    United KingdomBritish57490310002
    FILECCIA, Piero
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Amministratore
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    EnglandBritish116096800001
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    British61931900002
    GOLD, Nicholas Paul
    126 Hamilton Terrace
    St Johns Wood
    NW8 9UT London
    Amministratore
    126 Hamilton Terrace
    St Johns Wood
    NW8 9UT London
    EnglandBritish53606570002
    GRAY, Lisa Susanne
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    Amministratore
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    EnglandBritish262153810001
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British64357220001
    HIBBERD, Roy Wayne
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Amministratore
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    UsaUnited States158609380001
    HOWARD, Stuart John
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    Amministratore
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    EnglandBritish192909600002
    JOHNSON-POENSGEN, Douglas Howard
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Amministratore
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritish192481000001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Dmwsl 488 Limited
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    England
    06 apr 2016
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEnglish Law
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneRegister Of Uk Companies, Companies House
    Numero di registrazione05575201
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 nov 2005
    Consegnato il 06 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited as Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transazioni
    • 06 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of debenture made between the company and others as chargors and burdale financial limited as agent and trustee for itself and each of the finance parties
    Creato il 05 giu 2001
    Consegnato il 13 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the finance parties (or any of them) under the finance documents (all terms as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 13 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture under the tranche b loan agreement dated 24TH december 1998 between the company amnd the agent
    Creato il 24 dic 1998
    Consegnato il 02 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankboston N.A.(As Agent and Trustee for the Lenders)
    Transazioni
    • 02 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 24 dic 1998
    Consegnato il 02 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the loan documents (and each of them) which shall for the avoidance of doubt include the debenture and guarantee set out therein
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankboston N.A. (As Agent for the Lenders)
    Transazioni
    • 02 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 29 giu 1995
    Consegnato il 06 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All of each charging companys right title and interest in and to "the real property" as defined in 395 together with fixed charge all right title and interest in and to the "investments" (as defined in the security assignment) and all rights and assets belonging to the relevant charging company deriving from such investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank Plcas Trustee for the Secured Creditors
    Transazioni
    • 06 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0