VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED

VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00535340
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VIBROPLANT LIMITED03 lug 195403 lug 1954

    Quali sono gli ultimi bilanci di VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2023

    Quali sono le ultime deposizioni per VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Nomina di Mr Keith John Winstanley come amministratore in data 01 gen 2024

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Anna Catherine Bielby come amministratore in data 01 gen 2024

    2 pagineAP01

    Stato del capitale al 21 dic 2023

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Cessazione della carica di Neil Andrew Stothard come amministratore in data 30 set 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Sarah Elizabeth Jones come segretario in data 01 ott 2023

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Neil Andrew Stothard come segretario in data 30 set 2023

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2023

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 ago 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 ago 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, Sarah Elizabeth
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    314182540001
    BIELBY, Anna Catherine
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish309437440001
    PILKINGTON, Jeremy Frederic George
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish3408250002
    WINSTANLEY, Keith John
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish318037220001
    PARTRIDGE, Neil Russell
    Cranford
    Lands Lane
    HG5 8DH Knaresborough
    North Yorkshire
    Segretario
    Cranford
    Lands Lane
    HG5 8DH Knaresborough
    North Yorkshire
    British43666120001
    STOTHARD, Neil Andrew
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    British40008250003
    SWARBRICK, Rodney Victor
    7 Mulberry Avenue
    Penwortham
    PR1 0LL Preston
    Segretario
    7 Mulberry Avenue
    Penwortham
    PR1 0LL Preston
    British44604310001
    WOOLLEY, Eric Ryhs
    8 Hereford Road
    HG1 2NP Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    8 Hereford Road
    HG1 2NP Harrogate
    North Yorkshire
    British22806550002
    PARTRIDGE, Neil Russell
    Cranford
    Lands Lane
    HG5 8DH Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Cranford
    Lands Lane
    HG5 8DH Knaresborough
    North Yorkshire
    British43666120001
    STOTHARD, Neil Andrew
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    C/O Vp Plc Central House
    Beckwith Knowle Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40008250003
    WOOLLEY, Eric Ryhs
    8 Hereford Road
    HG1 2NP Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    8 Hereford Road
    HG1 2NP Harrogate
    North Yorkshire
    British22806550002

    Chi sono le persone con controllo significativo di VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Otley Road
    Beckwithshaw
    HG3 1UD Harrogate
    Central House
    England
    06 apr 2016
    Otley Road
    Beckwithshaw
    HG3 1UD Harrogate
    Central House
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione481833
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 30 mar 1998
    Consegnato il 03 apr 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 mar 1982
    Consegnato il 05 apr 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific eqitable charge over all f/h & l/h properties and or the proceeds of the sale thereof, fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 08 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security scottish form
    Creato il 15 mar 1972
    Consegnato il 29 mar 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    A standard security which was presented for registration of sasines on 17TH march 1972 for securing the monies due from fred pilkington and son limited to the chargee secured by a charge dated 13.5.69
    Brevi particolari
    A fixed charge a time floating charge onqueendykes industrial estate broxbourne etc (see doc 43 for details).
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance, Corporation LTD
    Transazioni
    • 29 mar 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 08 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge effecting substitution of security.
    Creato il 29 nov 1971
    Consegnato il 06 dic 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from fred pilkington and son limited to the charge secured by a charge dated 23/5/69
    Brevi particolari
    First fixed charge on freehold property at boblers mill, nottingham, t/n W123063 with landlords fixtures and a first floating charge on the space heating equipment. (See docs 41).
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance, Corporation LTD
    Transazioni
    • 06 dic 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 08 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Disposition
    Creato il 17 mar 1969
    Consegnato il 05 dic 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    17 march 69 disposition which was presened for registration of registered of sasines on 16 sept 69 for securing £39,298.
    Brevi particolari
    2.769 acres of leed property at greendykes industrial estate, broxbum west lothian. (37).
    Persone aventi diritto
    • County Council of West Lothian
    Transazioni
    • 05 dic 1969Registrazione di un'ipoteca
    Disposition
    Creato il 17 mar 1969
    Consegnato il 20 ott 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Disposition which was presented for registration at register of sasines on 16 sept. 69 for securing sterling pounds 39298
    Brevi particolari
    2.769 acres of lead property at greendykes industrial estate, broxbum west lothian.
    Persone aventi diritto
    • County Council of West Lothian
    Transazioni
    • 20 ott 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 08 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0