VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00535340 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| VIBROPLANT LIMITED | 03 lug 1954 | 03 lug 1954 |
Quali sono gli ultimi bilanci di VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2023 |
Quali sono le ultime deposizioni per VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Keith John Winstanley come amministratore in data 01 gen 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Ms Anna Catherine Bielby come amministratore in data 01 gen 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Stato del capitale al 21 dic 2023
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Andrew Stothard come amministratore in data 30 set 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Sarah Elizabeth Jones come segretario in data 01 ott 2023 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Andrew Stothard come segretario in data 30 set 2023 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2023 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 ago 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 ago 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 ago 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 ago 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 ago 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 ago 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Sarah Elizabeth | Segretario | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | 314182540001 | |||||||
| BIELBY, Anna Catherine | Amministratore | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | England | British | 309437440001 | |||||
| PILKINGTON, Jeremy Frederic George | Amministratore | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | England | British | 3408250002 | |||||
| WINSTANLEY, Keith John | Amministratore | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | England | British | 318037220001 | |||||
| PARTRIDGE, Neil Russell | Segretario | Cranford Lands Lane HG5 8DH Knaresborough North Yorkshire | British | 43666120001 | ||||||
| STOTHARD, Neil Andrew | Segretario | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | British | 40008250003 | ||||||
| SWARBRICK, Rodney Victor | Segretario | 7 Mulberry Avenue Penwortham PR1 0LL Preston | British | 44604310001 | ||||||
| WOOLLEY, Eric Ryhs | Segretario | 8 Hereford Road HG1 2NP Harrogate North Yorkshire | British | 22806550002 | ||||||
| PARTRIDGE, Neil Russell | Amministratore | Cranford Lands Lane HG5 8DH Knaresborough North Yorkshire | British | 43666120001 | ||||||
| STOTHARD, Neil Andrew | Amministratore | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | England | British | 40008250003 | |||||
| WOOLLEY, Eric Ryhs | Amministratore | 8 Hereford Road HG1 2NP Harrogate North Yorkshire | British | 22806550002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vp Plc | 06 apr 2016 | Otley Road Beckwithshaw HG3 1UD Harrogate Central House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creato il 30 mar 1998 Consegnato il 03 apr 1998 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 30 mar 1982 Consegnato il 05 apr 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific eqitable charge over all f/h & l/h properties and or the proceeds of the sale thereof, fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security scottish form | Creato il 15 mar 1972 Consegnato il 29 mar 1972 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito A standard security which was presented for registration of sasines on 17TH march 1972 for securing the monies due from fred pilkington and son limited to the chargee secured by a charge dated 13.5.69 | |
Brevi particolari A fixed charge a time floating charge onqueendykes industrial estate broxbourne etc (see doc 43 for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental charge effecting substitution of security. | Creato il 29 nov 1971 Consegnato il 06 dic 1971 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from fred pilkington and son limited to the charge secured by a charge dated 23/5/69 | |
Brevi particolari First fixed charge on freehold property at boblers mill, nottingham, t/n W123063 with landlords fixtures and a first floating charge on the space heating equipment. (See docs 41). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Disposition | Creato il 17 mar 1969 Consegnato il 05 dic 1969 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 17 march 69 disposition which was presened for registration of registered of sasines on 16 sept 69 for securing £39,298. | |
Brevi particolari 2.769 acres of leed property at greendykes industrial estate, broxbum west lothian. (37). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Disposition | Creato il 17 mar 1969 Consegnato il 20 ott 1969 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Disposition which was presented for registration at register of sasines on 16 sept. 69 for securing sterling pounds 39298 | |
Brevi particolari 2.769 acres of lead property at greendykes industrial estate, broxbum west lothian. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0