COLEMAN UK GROUP LIMITED

COLEMAN UK GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOLEMAN UK GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00535660
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COLEMAN UK GROUP LIMITED?

    • lavorazioni meccaniche (25620) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova COLEMAN UK GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Howard House Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COLEMAN UK GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COLEMAN MANUFACTURING LIMITED28 apr 200028 apr 2000
    T.S. COLEMAN & SON LIMITED12 lug 195412 lug 1954

    Quali sono gli ultimi bilanci di COLEMAN UK GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per COLEMAN UK GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 07 lug 2016

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    3 pagineSH20

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium account 27/06/2016
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    8 pagineAA

    legacy

    25 paginePARENT_ACC

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Bilancio annuale redatto al 28 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 set 2015

    Stato del capitale al 28 set 2015

    • Capitale: GBP 18,000
    SH01

    Nomina di Mr Michael James Isaac come amministratore in data 01 giu 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    9 pagineAA

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    29 paginePARENT_ACC

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 ott 2014

    Stato del capitale al 09 ott 2014

    • Capitale: GBP 18,000
    SH01

    legacy

    4 pagineGUARANTEE2

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 ott 2013

    Stato del capitale al 29 ott 2013

    • Capitale: GBP 18,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    14 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB* in data 17 apr 2013

    1 pagineAD01

    Nomina di David James Meyer come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Keith Hildum come amministratore

    3 pagineAP01

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di COLEMAN UK GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ISAAC, Michael James
    259 Morley Road
    Oakwood
    DE21 4TD Derby
    Derbyshire
    Segretario
    259 Morley Road
    Oakwood
    DE21 4TD Derby
    Derbyshire
    British106397180001
    HILDUM, Keith Patrick
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    United StatesAmericanVp Treasurer134557260001
    ISAAC, Michael James
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    Amministratore
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    EnglandBritishChartered Accountant106397180001
    MEYER, David James
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    United StatesAmericanGroup Executive176950830001
    WEATHERALL, Christopher John
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishManaging Director172779280001
    CALVER, Robert Edward
    55 Efflinch Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8EU Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    55 Efflinch Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8EU Burton On Trent
    Staffordshire
    British1477350001
    LEE, Dawn Angela
    99 Gillway Lane
    B79 8PJ Tamworth
    Staffordshire
    Segretario
    99 Gillway Lane
    B79 8PJ Tamworth
    Staffordshire
    British64130900002
    BROWN, Diane Elizabeth
    11a Comberford Road
    B79 8PB Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    11a Comberford Road
    B79 8PB Tamworth
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director47973730004
    BROWN, Diane Elizabeth
    127 Gillway Lane
    B79 8PJ Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    127 Gillway Lane
    B79 8PJ Tamworth
    Staffordshire
    BritishCompany Director47973730002
    EDWARDS, Roy
    59 Compton Avenue
    DE72 2AU Aston On Trent
    Derbys
    Amministratore
    59 Compton Avenue
    DE72 2AU Aston On Trent
    Derbys
    BritishManaging Director37811990001
    ISAAC, Michael James
    259 Morley Road
    Oakwood
    DE21 4TD Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    259 Morley Road
    Oakwood
    DE21 4TD Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishAccountant106397180001
    KEAL, David
    139 King Street
    DE55 7DE Alfreton
    Derbyshire
    Amministratore
    139 King Street
    DE55 7DE Alfreton
    Derbyshire
    United KingdomBritishManager31615070001
    LEE, Carol Ann
    Statfold Barn Farm
    Ashby Road
    B79 0BU Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Statfold Barn Farm
    Ashby Road
    B79 0BU Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector1477370001
    LEE, Christopher
    Church Farm
    School Lane, Shuttington
    B79 0DX Tamworth
    Amministratore
    Church Farm
    School Lane, Shuttington
    B79 0DX Tamworth
    BritishCompany Director87042860003
    LEE, David John
    Copnill Farm
    Ashby Road
    B79 0BT Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Copnill Farm
    Ashby Road
    B79 0BT Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Director47973650002
    LEE, Graham
    Graycar Business Park Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton On Trent
    Howard House
    Amministratore
    Graycar Business Park Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton On Trent
    Howard House
    EnglandBritishDirector1477360001
    LEE, Graham Ivan
    24 Browns Lane
    B79 8TE Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    24 Browns Lane
    B79 8TE Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector47973700001
    LEE, Graham Ivan
    24 Browns Lane
    B79 8TE Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    24 Browns Lane
    B79 8TE Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Director47973700001
    LEE, Graham
    Statfold Barn Farm Ashby Road
    B79 0BU Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Statfold Barn Farm Ashby Road
    B79 0BU Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector1477360001
    NOON, Julie Ann
    Sunnyside Main Road
    Wigginton
    B79 9DU Tamworth
    Staffs
    Amministratore
    Sunnyside Main Road
    Wigginton
    B79 9DU Tamworth
    Staffs
    EnglandBritishDirector29313920007

    COLEMAN UK GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 13 dic 2010
    Consegnato il 17 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as or being unit 318G, fauld industrial estate, fauld, tutbury, staffordshire, t/no: SF370154.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 ago 2010
    Consegnato il 19 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 10 ago 2010
    Consegnato il 13 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H properties k/a units 316A, 316B, 316G, 317A, 317B, 317G and 318G fauld industrial estate, tutbury, east staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 09 dic 2002
    Acquisito il 27 lug 2010
    Consegnato il 11 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H 316B fauld industrial estate tutbury staffordshire t/no SF288710.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2010Registrazione di un'acquisizione (MG06)
    • 12 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 06 dic 2002
    Acquisito il 27 lug 2010
    Consegnato il 11 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H 317A (which includes 317G) fauld industrial estate tutbury staffordshire t/no:SF465560.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2010Registrazione di un'acquisizione (MG06)
    • 12 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 05 dic 2002
    Acquisito il 27 lug 2010
    Consegnato il 11 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H 316A and 316G fauld industrial estate tutbury staffordshire t/n SF465557.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2010Registrazione di un'acquisizione (MG06)
    • 12 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 31 ott 1989
    Consegnato il 07 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1987
    Consegnato il 02 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property on the west side of moseley street, burton on trent, staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1987
    Consegnato il 02 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    79 moseley street, burton on trent, staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1987
    Consegnato il 02 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & premises k/a numbers 80, 81, 82, 83 & 84 moseley street, burton on trent, staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 29 nov 1985
    Consegnato il 17 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a moseley works, mosley steet, burton on trent staffordshire and or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0