KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED

KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00540556
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VENT MASTER (EUROPE) LIMITED21 giu 199621 giu 1996
    BERISFORD BAKER STREET LIMITED01 mar 199501 mar 1995
    BERISFORD TREASURY LIMITED10 feb 199510 feb 1995
    BERISFORD TREASURY LIMITED09 mag 198909 mag 1989
    S & W BERISFORD TREASURY LIMITED29 ott 198729 ott 1987
    ASTON METAL CO LIMITED12 nov 195412 nov 1954

    Quali sono gli ultimi bilanci di KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Stato del capitale al 09 ago 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    3 pagineSH20

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Michael James Kachmer come amministratore in data 03 apr 2013

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Nomina di Graham Philip Brisley Veal come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kevin Blades come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Thomas Doerr come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Adrian David Gray come amministratore

    3 pagineAP01

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Amministratore
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Amministratore
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    Segretario
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Segretario
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Amministratore
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    BUTLER, Peter Robert
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    British34707070001
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6996370001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Amministratore
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    British45532880003
    GORDON, Alastair Neil
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    Amministratore
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    EnglandBritish61620710001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    JONES, Eric Alan
    Stidolphs Old Farm House
    Eggpie Lane Sevenoaks
    TN4 6NP Weald
    Kent
    Amministratore
    Stidolphs Old Farm House
    Eggpie Lane Sevenoaks
    TN4 6NP Weald
    Kent
    British27290300001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Amministratore
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    O'CONNOR, Patrick Finbarr
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    Amministratore delegato nominato
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    British/Irish900010100001
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    British47433990002
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    Washington House
    40-41 Conduit Street
    W1S 2YQ London
    Amministratore
    Washington House
    40-41 Conduit Street
    W1S 2YQ London
    75310650002
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006
    S & W BERISFORD LIMITED
    1 Farnham Road
    GU2 4RG Guildford
    Surrey
    Amministratore
    1 Farnham Road
    GU2 4RG Guildford
    Surrey
    75310610001

    KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 25 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Creato il 20 feb 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Creato il 20 nov 2001
    Consegnato il 30 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge agreement
    Creato il 13 ago 1999
    Consegnato il 27 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations due or to become due from each credit party from time to time to the facility agent, each issuing bank, the lenders or any of them or their respective affiliates under any credit document or secured hedge agreement
    Brevi particolari
    All investment property: all right, title and interest of the company in all shares of capital stock owned by any us subsidiary ,the pledge agreement and the certificates, the collateral account together with all amounts on deposit from time to time in such deposit account. All books, records, ledger cards, files, computer programs, tapes, discs and related data processing software that at any time evidence or contain information relating to any of the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Facility Agent
    Transazioni
    • 27 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of amendment.
    Creato il 30 set 1991
    Consegnato il 16 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and for each bank (as defined) and barclays bank PLC (the replacement agent) under the terms of the debenture dated 26.9.90
    Brevi particolari
    All the company's rights in the book debts & other debts, licenses, coments, authorisations etc. (see form 395 for details).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 set 1990
    Consegnato il 09 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obliger (as therein defiend) to national westminster bank PLC (the second security agent) and the banks (as threin defined) or any at them under the indebtedness agreements and the coffee refinancing agreement and all monies due or to become due from berisford international PLC under the subcrdination guarantee
    Brevi particolari
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 gen 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 set 1990
    Consegnato il 09 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (the security agent) and the banks (aas therein defined) or any of them under each of the indebtedness agreements
    Brevi particolari
    Nsee from 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0