KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00540556 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | St Anns Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| VENT MASTER (EUROPE) LIMITED | 21 giu 1996 | 21 giu 1996 |
| BERISFORD BAKER STREET LIMITED | 01 mar 1995 | 01 mar 1995 |
| BERISFORD TREASURY LIMITED | 10 feb 1995 | 10 feb 1995 |
| BERISFORD TREASURY LIMITED | 09 mag 1989 | 09 mag 1989 |
| S & W BERISFORD TREASURY LIMITED | 29 ott 1987 | 29 ott 1987 |
| ASTON METAL CO LIMITED | 12 nov 1954 | 12 nov 1954 |
Quali sono gli ultimi bilanci di KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 09 ago 2013
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 apr 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael James Kachmer come amministratore in data 03 apr 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 apr 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 apr 2011 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Graham Philip Brisley Veal come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Blades come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 apr 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Doerr come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Adrian David Gray come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 353 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Segretario | St Ann's Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne | 94529700001 | |||||||
| GRAY, Adrian David | Amministratore | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 | United Kingdom | British | 146072380001 | |||||
| JONES, Maurice Delon | Amministratore | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | 134328700001 | |||||
| VEAL, Graham Philip Brisley | Amministratore | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Anns Wharf United Kingdom | England | British | 43215170003 | |||||
| BURROWES, Rosemary Anne | Segretario | 108c Bramley Road Oakwood N14 4HT London | British | 49687740001 | ||||||
| HOOPER, David Ross | Segretario | Long Mynd Burchetts Green Lane Burchetts Green SL6 3QW Maidenhead Berkshire | British | 17023730001 | ||||||
| SYMS, Rhonda Sneddon | Segretario | 2 Swallow Rise Knaphill GU21 2LG Woking Surrey | British | 16978550002 | ||||||
| BLADES, Kevin Nicholas | Amministratore | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | 79449700002 | |||||
| BUTLER, Peter Robert | Amministratore | Gifford House 22 Chalklands Howe Green CM2 7TH Chelmsford Essex | British | 34707070001 | ||||||
| CUTHBERTSON, George Brian | Amministratore | 39 The Gardens WD1 3DN Watford Hertfordshire | United Kingdom | British | 6996370001 | |||||
| DOERR, Thomas | Amministratore | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | 134081280001 | ||||||
| FINDLER, Jonathan Paul | Amministratore | Westwood House Heathfield Avenue SL5 0AL Ascot Berkshire | British | 45532880003 | ||||||
| GORDON, Alastair Neil | Amministratore | 64 Castelnau SW13 9EX London | England | British | 61620710001 | |||||
| HOOPER, David Ross | Amministratore | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||
| HOOPER, David Ross | Amministratore | Long Mynd Burchetts Green Lane Burchetts Green SL6 3QW Maidenhead Berkshire | British | 17023730001 | ||||||
| JONES, Eric Alan | Amministratore | Stidolphs Old Farm House Eggpie Lane Sevenoaks TN4 6NP Weald Kent | British | 27290300001 | ||||||
| KACHMER, Michael James | Amministratore | Marywood Trail 60187 Wheaton 14 Illinois United States | United States | American | 136570610001 | |||||
| O'CONNOR, Patrick Finbarr | Amministratore delegato nominato | 66 Cumberland Mills Square Saunders Ness Road E14 3BJ Isle Of Dogs London | British/Irish | 900010100001 | ||||||
| WILSON, Andrew George Richard | Amministratore | Cononley Hall Main Street Cononley BD20 8LJ Skipton West Yorkshire | British | 47433990002 | ||||||
| BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED | Amministratore | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310650003 | |||||||
| BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED | Amministratore | Washington House 40-41 Conduit Street W1S 2YQ London | 75310650002 | |||||||
| S & W BERISFORD LIMITED | Amministratore | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310610006 | |||||||
| S & W BERISFORD LIMITED | Amministratore | 1 Farnham Road GU2 4RG Guildford Surrey | 75310610001 |
KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002 | Creato il 11 apr 2002 Consegnato il 25 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent | Creato il 20 feb 2002 Consegnato il 08 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent) | Creato il 20 nov 2001 Consegnato il 30 nov 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Pledge agreement | Creato il 13 ago 1999 Consegnato il 27 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations due or to become due from each credit party from time to time to the facility agent, each issuing bank, the lenders or any of them or their respective affiliates under any credit document or secured hedge agreement | |
Brevi particolari All investment property: all right, title and interest of the company in all shares of capital stock owned by any us subsidiary ,the pledge agreement and the certificates, the collateral account together with all amounts on deposit from time to time in such deposit account. All books, records, ledger cards, files, computer programs, tapes, discs and related data processing software that at any time evidence or contain information relating to any of the collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of amendment. | Creato il 30 set 1991 Consegnato il 16 ott 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and for each bank (as defined) and barclays bank PLC (the replacement agent) under the terms of the debenture dated 26.9.90 | |
Brevi particolari All the company's rights in the book debts & other debts, licenses, coments, authorisations etc. (see form 395 for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 set 1990 Consegnato il 09 ott 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obliger (as therein defiend) to national westminster bank PLC (the second security agent) and the banks (as threin defined) or any at them under the indebtedness agreements and the coffee refinancing agreement and all monies due or to become due from berisford international PLC under the subcrdination guarantee | |
Brevi particolari (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 set 1990 Consegnato il 09 ott 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (the security agent) and the banks (aas therein defined) or any of them under each of the indebtedness agreements | |
Brevi particolari Nsee from 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0