CAVENDISH MUSIC COMPANY LIMITED
Panoramica
Nome della società | CAVENDISH MUSIC COMPANY LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00541392 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CAVENDISH MUSIC COMPANY LIMITED?
- Attività di registrazione del suono e di edizione musicale (59200) / Informazione e comunicazione
Dove si trova CAVENDISH MUSIC COMPANY LIMITED?
Indirizzo della sede legale | The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CAVENDISH MUSIC COMPANY LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
IMAGEM PRODUCTION MUSIC LIMITED | 10 ott 2011 | 10 ott 2011 |
CAVENDISH MUSIC COMPANY LIMITED | 02 dic 1954 | 02 dic 1954 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CAVENDISH MUSIC COMPANY LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per CAVENDISH MUSIC COMPANY LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Denis Dinsmore come amministratore in data 06 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert John Ott il 17 ott 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Denis Dinsmore il 17 ott 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ed Killin il 17 ott 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Andrew Giansante come amministratore in data 13 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lou Ragagnin come amministratore in data 13 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Dentons Secretaries Limited come segretario in data 01 feb 2016 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Nomina di Mr Robert John Ott come amministratore in data 05 feb 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 03 dic 2016 al 31 dic 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Boosey & Hawkes Music Publishers, Aldwych House, 71-91 Aldwych, London WC2B 4HN a The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE in data 11 gen 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Denis Dinsmore come amministratore in data 10 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Ed Killin come amministratore in data 10 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Lou Ragagnin come amministratore in data 10 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kent Michael Hoskins come amministratore in data 10 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Berchmans Minch come amministratore in data 10 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kent Michael Hoskins come segretario in data 10 dic 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 03 dic 2015 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2015 al 03 dic 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CAVENDISH MUSIC COMPANY LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENTONS SECRETARIES LIMITED | Segretario | Fleet Place EC4M 7WS London One United Kingdom |
| 98515470015 | ||||||||||
GIANSANTE, Christopher Andrew | Amministratore | 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes The Pinnacle England | Canada | Canadian | Businessman | 213347100001 | ||||||||
KILLIN, Ed | Amministratore | 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes The Pinnacle England | Canada | Canadian | Businessman | 204027740001 | ||||||||
OTT, Robert John | Amministratore | 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes The Pinnacle England | Canada | Canadian | Businessman | 204944050001 | ||||||||
CHRISTMAS, John Leslie | Segretario | Innerdown Langton Road Langton Green TN3 0BA Tunbridge Wells Kent | English | 15610000001 | ||||||||||
DEVIN, Mark | Segretario | 2 The Green CM23 3ER Bishops Stortford Hertfordshire | British | 13369860004 | ||||||||||
EARL, Jane | Segretario | 8 Parsonage Farm Townfield WD3 7FN Rickmanworth Hertfordshire | British | 82548680001 | ||||||||||
HOSKINS, Kent Michael | Segretario | Stonehill Close SW14 8RP London 6 England | British | Accountant | 127082930001 | |||||||||
KNIGHTON, Edward Myles | Segretario | 40 Southmoor Road OX2 6RD Oxford Oxfordshire | British | Group Finance Director | 17238020006 | |||||||||
SIZER, Anne Marie | Segretario | 11 Stanford Road N11 3HY London | British | 93512190001 | ||||||||||
SMITH, Gregory Anthony | Segretario | 12 Levignen Close GU52 0TW Church Crookham Hampshire | British | 94273120001 | ||||||||||
AUSTEN, Peter David | Amministratore | Pippins Popes Lane SL6 9NY Cookham Dean Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 40203460001 | ||||||||
CHRISTMAS, John Leslie | Amministratore | Innerdown Langton Road Langton Green TN3 0BA Tunbridge Wells Kent | England | English | Chartered Accountant | 15610000001 | ||||||||
DANSON, David Laurence George | Amministratore | Wargrave Chapel High Street Wargrave RG10 8BU Reading Berkshire | British | Company Director | 59367160001 | |||||||||
DINSMORE, Denis | Amministratore | 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes The Pinnacle England | Canada | Canadian | Businessman | 204023770001 | ||||||||
FELL, Robert Antony | Amministratore | 12 Ravenshaw Street NW6 1NP London | British | Music Publisher | 89645650001 | |||||||||
GLOVER, Trevor David | Amministratore | 15 Lebanon Gardens SW18 1RQ London | British | Managing Director | 8053550001 | |||||||||
HAZEL, Paul Malcolm | Amministratore | Roel Hill House Hawling GL54 5AP Cheltenham Gloucestershire | England | British | Chartered Accountant | 67474470001 | ||||||||
HOLLAND, Richard | Amministratore | Downacre Doggetts Wood Lane HP8 4TH Chalfont St Giles | United Kingdom | British | Accountant | 7926630002 | ||||||||
HOSKINS, Kent Michael | Amministratore | Stonehill Close SW14 8RP London 6 England | England | New Zealander | Accountant | 127082930002 | ||||||||
KNIGHTON, Edward Myles | Amministratore | 40 Southmoor Road OX2 6RD Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | Group Finance Director | 17238020006 | ||||||||
MINCH, John Berchmans | Amministratore | Barnes House TN22 3XN Piltdown East Sussex | England | Irish,British | Publisher | 155882620002 | ||||||||
POOL, Anthony Presgrave | Amministratore | 4 Ardwick Road Hampstead NW2 2BX London | British | Music Publisher | 2528070001 | |||||||||
RAGAGNIN, Lou | Amministratore | King Street West Suite 500 Toronto M5v 1h8 266 Ontario Canada | Canada | Canadian | Businessman | 204023600001 | ||||||||
SMITH, Gregory Anthony | Amministratore | 12 Levignen Close GU52 0TW Church Crookham Hampshire | British | Finance Director | 94273120001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CAVENDISH MUSIC COMPANY LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ole Uk Production Music Limited | 06 apr 2016 | 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes The Pinnacle England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CAVENDISH MUSIC COMPANY LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 26 mag 2006 Consegnato il 05 giu 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due of any group company to the chargee or to the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental deed to a debenture dated 3 october 2003 | Creato il 23 feb 2004 Consegnato il 10 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group company to the security agent (whether on its own account or on behalf of any of the security beneficiaries) or to the other security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 05 dic 2003 Consegnato il 18 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group company to the security agent (whether on its own or on behalf of any of the security beneficiaries) or to the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over intellectual property rights and related assets between the company and national westminster bank PLC | Creato il 29 giu 2001 Consegnato il 09 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities due or to become due from the company to any creditor under or in connection with any group financing document | |
Brevi particolari All right title and interest in the ip rights a floating charge over the ip rights, bank accounts and computer software (all as defined). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0