BGHP (REALISATIONS) LIMITED

BGHP (REALISATIONS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBGHP (REALISATIONS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00541611
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BGHP (REALISATIONS) LIMITED?

    • altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere
    • servizi di prestampa e pre-media (18130) / Industrie manifatturiere
    • rilegatura e servizi correlati (18140) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova BGHP (REALISATIONS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o KPMG LLP
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BGHP (REALISATIONS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BENHAMGOODHEADPRINT LIMITED01 nov 200101 nov 2001
    GOODHEAD PRINT LIMITED12 ago 199912 ago 1999
    GOODHEAD PRINT GROUP LIMITED04 mag 199404 mag 1994
    GOODHEAD HEATSET LIMITED30 apr 199130 apr 1991
    WILTSHIRE (BRISTOL) LIMITED07 dic 195407 dic 1954

    Quali sono gli ultimi bilanci di BGHP (REALISATIONS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per BGHP (REALISATIONS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:copy of court order to confirm that reasons for deferral have been reached and company can be dissolved.
    1 pagineLIQ MISC OC
    Note
    DataNota
    12 giu 2017Clarification REGISTRAR NOTIFIED BY LETTER DATED 28 APRIL 2017 AND COPY COURT ORDER RECEIVED ON 02 MAY 2017 OF THE CONLCUSION OF THE CLAIM REFERRED TO IN ORDER REGISTERED ON 22 MARCH 2016.

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:2.36B and Order of Court Deferring Dissolution until conclusion of claim
    2 pagineLIQ MISC OC

    Avviso al Registro relativo alla data di scioglimento

    2 pagine2.36B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 06 mag 2014

    21 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    21 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 gen 2014

    30 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 27 ago 2013

    29 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 27 mag 2013

    30 pagine2.24B

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 33 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 26 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 23 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 21 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 20 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 22 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 30 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 27 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 29 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 32 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 25 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 24 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di BGHP (REALISATIONS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOLLAND, David Alan
    The Chestnuts
    Long Green, Wortham
    IP22 1RD Diss
    Norfolk
    Segretario
    The Chestnuts
    Long Green, Wortham
    IP22 1RD Diss
    Norfolk
    BritishChief Executive97792830001
    ATKINSON, Lindsay Graham
    c/o Kpmg Llp
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Amministratore
    c/o Kpmg Llp
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    EnglandBritishNone125643770001
    BORTON, Ross Antony
    c/o Kpmg Llp
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Amministratore
    c/o Kpmg Llp
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    EnglandBritishNone164633070001
    EDWARDS, Michael Ian
    c/o Kpmg Llp
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Amministratore
    c/o Kpmg Llp
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    EnglandBritishNone151050100001
    HOLLAND, David Alan
    The Chestnuts
    Long Green, Wortham
    IP22 1RD Diss
    Norfolk
    Amministratore
    The Chestnuts
    Long Green, Wortham
    IP22 1RD Diss
    Norfolk
    EnglandBritishDirector97792830001
    MADEJSKI, Robert John, Sir
    Hook End Lane
    Lower Basildon
    RG8 9TA Reading
    Adshead Park
    Amministratore
    Hook End Lane
    Lower Basildon
    RG8 9TA Reading
    Adshead Park
    EnglandBritishCompany Director42866240001
    MELLON, James
    c/o Kpmg Llp
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Amministratore
    c/o Kpmg Llp
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    U.K.BritishNone160492830001
    PALMER, Stephen Robert
    7 Town Well End
    OX27 7QD Fritwell
    Oxfordshire
    Amministratore
    7 Town Well End
    OX27 7QD Fritwell
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector125284840001
    SMITH, Ian
    Douglas Grange
    Hurst
    RG10 0TT Reading
    3
    Berkshire
    Amministratore
    Douglas Grange
    Hurst
    RG10 0TT Reading
    3
    Berkshire
    EnglandBritishDirector60865650002
    ATKINS, Howard Timothy
    49 The Drive
    WD3 4EA Rickmansworth
    Hertfordshire
    Segretario
    49 The Drive
    WD3 4EA Rickmansworth
    Hertfordshire
    British44662530001
    CROSSLEY, Peter Graham
    62 Church Hill
    IG10 1LB Loughton
    Essex
    Segretario
    62 Church Hill
    IG10 1LB Loughton
    Essex
    BritishDirector51437100001
    HILLMAN, David
    St. Margarets
    Station Road, Thorrington
    CO7 8JA Colchester
    Essex
    Segretario
    St. Margarets
    Station Road, Thorrington
    CO7 8JA Colchester
    Essex
    BritishFinance Director56527380002
    O'DRISCOLL, Nicholle Debra
    17 Chestnut End
    OX26 3XP Bicester
    Oxfordshire
    Segretario
    17 Chestnut End
    OX26 3XP Bicester
    Oxfordshire
    British24654150003
    ATKINS, Howard Timothy
    49 The Drive
    WD3 4EA Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    49 The Drive
    WD3 4EA Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance Director44662530001
    CALEY, Robert James
    Wild Thyme
    Creeting Road
    IP14 5BT Stowmarket
    Suffolk
    Amministratore
    Wild Thyme
    Creeting Road
    IP14 5BT Stowmarket
    Suffolk
    BritishSales Director113829210001
    CLARK, Peter Richard
    The Beeches
    Malvern Wells
    WR14 4HN Worcester
    Amministratore
    The Beeches
    Malvern Wells
    WR14 4HN Worcester
    EnglandBritishDirector157553520001
    CONBOY, Anthony Leonard
    30 Fairford Way
    OX26 4YG Bicester
    Oxfordshire
    Amministratore
    30 Fairford Way
    OX26 4YG Bicester
    Oxfordshire
    BritishCommercial Director64730220001
    COOLING, John Alfred
    14 Bisham Gardens
    Highgate
    N6 6DD London
    Amministratore
    14 Bisham Gardens
    Highgate
    N6 6DD London
    EnglandBritishDirector224465730001
    CORNELIUS, Terence Reginald
    2 Fairways Saltford
    BS31 3HX Bristol
    Amministratore
    2 Fairways Saltford
    BS31 3HX Bristol
    BritishWorks Director82562400001
    CROSSLEY, Peter Graham
    62 Church Hill
    IG10 1LB Loughton
    Essex
    Amministratore
    62 Church Hill
    IG10 1LB Loughton
    Essex
    EnglandBritishDirector51437100001
    CROWE, David Thomas
    68 Windsor Road
    S81 9BZ Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    68 Windsor Road
    S81 9BZ Worksop
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector119297820001
    DOBBS, Marcus Leonard
    Bryn Cottage Oxford Street
    Lee Common
    HP16 9JT Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Bryn Cottage Oxford Street
    Lee Common
    HP16 9JT Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishSales & Marketing2631020001
    ENGLAND, Ron
    Regency Court
    147 Alan Road
    IP3 8DP Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Regency Court
    147 Alan Road
    IP3 8DP Ipswich
    Suffolk
    BritishManaging Director76922580005
    HARWOOD, Graham Paul Edwin
    2 The Laurels
    Fringford
    OX27 8EW Bicester
    Oxfordshire
    Amministratore
    2 The Laurels
    Fringford
    OX27 8EW Bicester
    Oxfordshire
    BritishSales Director6478280001
    HILLMAN, David
    St. Margarets
    Station Road, Thorrington
    CO7 8JA Colchester
    Essex
    Amministratore
    St. Margarets
    Station Road, Thorrington
    CO7 8JA Colchester
    Essex
    EnglandBritishFinance Director56527380002
    HOMAN, Adry Diane
    3 Ventfield Close
    Horton Cum Studley
    OX33 1AN Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    3 Ventfield Close
    Horton Cum Studley
    OX33 1AN Oxford
    Oxfordshire
    BritishBusiness Development Director78811860001
    HUGHES, Geoffrey Alan
    5 Mulberry Drive
    OX26 3FZ Bicester
    Oxfordshire
    Amministratore
    5 Mulberry Drive
    OX26 3FZ Bicester
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector39799080004
    HUGHES, Geoffrey Alan
    5 Mulberry Drive
    OX26 3FZ Bicester
    Oxfordshire
    Amministratore
    5 Mulberry Drive
    OX26 3FZ Bicester
    Oxfordshire
    EnglandBritishManaging Director39799080002
    HUNT, Simon Philip Guy
    12 Rectory Lane
    Lower Brailes
    OX15 5HY Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    12 Rectory Lane
    Lower Brailes
    OX15 5HY Banbury
    Oxfordshire
    BritishJoint Managing Director66653270003
    LANGSTON, Colin Richard
    Nethercote Drive
    Rissington Road
    GL54 2DT Bourton On The Water
    Nethercot
    Gloucs
    Amministratore
    Nethercote Drive
    Rissington Road
    GL54 2DT Bourton On The Water
    Nethercot
    Gloucs
    BritishDirector127988870001
    MCQUILLAN, Paul John
    17a Yorkersgate
    YO17 7AA Malton
    North Yorkshire
    Amministratore
    17a Yorkersgate
    YO17 7AA Malton
    North Yorkshire
    BritishDirector78958070005
    MELLON, James
    3 Neilsland Drive
    ML1 3DZ Motherwell Strathclyde
    Lanarkshire
    Amministratore
    3 Neilsland Drive
    ML1 3DZ Motherwell Strathclyde
    Lanarkshire
    U.K.BritishDirector160492830001
    MILLS, Michael William
    Burton Farm House
    Church Lane Claxton
    NR14 7HY Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Burton Farm House
    Church Lane Claxton
    NR14 7HY Norwich
    Norfolk
    BritishDirector93380280001
    NEWLAND, Nicholas John
    Manor Farm
    OX29 7NT Curbridge
    Oxfordshire
    Amministratore
    Manor Farm
    OX29 7NT Curbridge
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector31070880001
    NIVISON, Robert George
    7 Wroxton House Church Street
    Wroxton
    OX15 6QF Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    7 Wroxton House Church Street
    Wroxton
    OX15 6QF Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritishChief Executive24654180003

    BGHP (REALISATIONS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal assignment of contract monies
    Creato il 23 ago 2011
    Consegnato il 24 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under the agreement for the purchase of debts, interests costs & discounting allowances, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) LTD, Hsbc Equipment Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 24 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 22 ago 2011
    Consegnato il 25 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Cq 11 clarios hs 90.32.890.0900. cq host computer hs:84.71.500.0900. Cq op computer hs: 84.71.500.0900 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Liberty Leasing PLC
    Transazioni
    • 25 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 lug 2011
    Consegnato il 21 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sir Robert John Madejski Obe Dl
    Transazioni
    • 21 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 mag 2013Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Chattel mortgage
    Creato il 03 ott 2008
    Consegnato il 07 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    4 signode stapping machines s/no's PT4113 PT4114 PT4115 PT4116 3 epsom stylus pro 11880 printers s/no's JWP0000174 JWP0000117 & JWP0000171 2 alwan amyk ink optimisers eco v 3.2, s/no's 40108355 & 40108459 for further details of the chattels charges please refer to form 395 all and singular the chattels plant machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 07 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 12 mag 2008
    Consegnato il 16 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge over one man roland offset rotation printing system w/no. 4 080 562 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • John Madejski Obe Dl
    Transazioni
    • 16 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 12 mag 2008
    Consegnato il 16 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge over one man roland offset rotation printing system w/no. 4 080 601 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • John Madejski Obe Dl
    Transazioni
    • 16 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge (all assets)
    Creato il 03 ott 2007
    Consegnato il 23 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transazioni
    • 23 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 10 set 2007
    Consegnato il 13 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,725,000 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Ethos conveyor system ub in caxton fields- serial no- 2421, gantry/crane system for ub in caxton fields- serial no- SPB142, 143, 144, 146, 148, 149, 150 and 151 and muller cb-16 stackers X2 in caxton fields- serial no- 367171 and 445895 for details of further goods charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC C/O Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 13 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal assignment
    Creato il 16 ago 2007
    Consegnato il 24 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattels mortgage
    Creato il 30 lug 2007
    Consegnato il 03 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof, schedule muller martini corona perfect binding line: s/no's: SAP324076/SAP324078/SAP324077.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 03 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattels mortgage
    Creato il 20 lug 2007
    Consegnato il 23 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery being komori S38 web press K4 s/no 101, komori S38 web press K3 s/no 101, heidelberg web press M4000 s/n mc-JH015 (for further details of chattels charge please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 23 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 03 ago 2006
    Consegnato il 08 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,000,000 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    The items as listed on the schedule being, ethos conveyor system ub s/no:2421, gantry/crane system for ub s/no:SPB142, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 151, muller cb-16 stackers x 2 s/no:367171 and 445895, for details of further goods charged please refer to form 395, together with all accessories and component parts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 30 set 2003
    Consegnato il 01 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 01 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 21 gen 2003
    Consegnato il 29 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a units 2,4 and 5 chaucer industrial estate launton road bicester cherwell oxon t/n's ON143051, ON112429, ON117310. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    All assets debenture deed
    Creato il 27 nov 2001
    Consegnato il 01 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 01 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 ago 2000
    Consegnato il 14 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a goodhead 4 (previously k/a unit 5) chaucer business park launton road bicester oxon t/no ON117310. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 18 giu 1997
    Consegnato il 24 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 4 chaucer international estate launton road bicester oxon t/no;-ON112429. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 apr 1997
    Consegnato il 21 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 2 chaucer international estate launton road bicester oxfordshire t/no ON143051 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 apr 1997
    Consegnato il 16 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 27 dic 1995
    Consegnato il 28 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Rockwell gross tribune press no GF020 including 578 mm cut off 9XMEG autopasters 8X blanket to blanket mono units 2X4 clour satellite units 1X UB50 folder one new universal with 1/4 fold and solna colour corking heatset cooler press and other chattels see form 395 for full details). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 27 dic 1995
    Consegnato il 28 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Heidelberg speedmaster 102 vp no. 523719 together with all parts motors engines componenets additional equipment and other parts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 01 dic 1995
    Consegnato il 02 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or goodhead group PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land adjoining unit 2 chaucer international estate launton road bicester oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 mar 1993
    Consegnato il 30 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First fixed charge
    Creato il 11 feb 1993
    Consegnato il 16 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    First fixed charge on book debts and other debts present and future and the proceeds thereof (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Alex.Lawrie Receivables Financing Limited
    Transazioni
    • 16 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 25 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capitial.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BGHP (REALISATIONS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 nov 2012Inizio dell'amministrazione
    19 mag 2014Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David John Standish
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0