DURA AUTOMOTIVE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | DURA AUTOMOTIVE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00542101 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DURA AUTOMOTIVE LIMITED?
- fabbricazione di altre parti e accessori per veicoli a motore (29320) / Industrie manifatturiere
Dove si trova DURA AUTOMOTIVE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Dac Beachcroft Llp Portwall Place Portwall Lane BS1 9HS Bristol United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DURA AUTOMOTIVE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ADWEST WESTERN THOMSON LIMITED | 25 set 1996 | 25 set 1996 |
| WESTERN THOMSON CONTROLS LIMITED | 17 dic 1954 | 17 dic 1954 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DURA AUTOMOTIVE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per DURA AUTOMOTIVE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 10 pagine | AA | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Jay Norman Brown come amministratore in data 10 mar 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Michael Denis Putz come amministratore in data 10 mar 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Jose Carlos Infante Henriques come amministratore in data 10 mar 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2020 | 23 pagine | AA | ||||||||||||||
Seconda presentazione per la nomina di José Carlos Infante Henriques come amministratore | 3 pagine | RP04AP01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 set 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Eric Johnston come amministratore in data 29 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Jay Norman Brown come amministratore in data 29 mar 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2019 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Dura Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 set 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Stephen Eric Johnston come amministratore in data 24 set 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Lillian Dorina Etzkorn come amministratore in data 24 set 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Eric Johnston come amministratore in data 16 ago 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Michael Beckett come amministratore in data 16 ago 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Lillian Dorina Etzkorn come amministratore in data 16 ago 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Jose Carlos Infante Henriques come amministratore in data 16 ago 2021 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 24 dic 2020
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Stephen Eric Johnston come amministratore in data 06 ago 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di DURA AUTOMOTIVE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUTZ, Michael Denis | Amministratore | Pond Run MI 48326 Auburn Hills 1780 United States | United States | American | 306802940001 | |||||
| ALLINSON, Bernadette | Segretario | Aughton Cottage Monkey Island Lane Bray SL6 2GD Maidenhead Berkshire | British | 42217850001 | ||||||
| BROOKS, David George | Segretario | Llwyn Y Felin Llanddowror SA33 4JE St Clears Carmarthen | British | 77498070001 | ||||||
| COLLINS, Paul Nicholas | Segretario | 23 Tinwell Close Lower Earley RG6 3BJ Reading Berkshire | British | 31314280001 | ||||||
| CONFAVREUX, Andre George | Segretario | 18 Water Tower Close UB8 1XS Uxbridge Middlesex | British | 17552570001 | ||||||
| DAVIS, Brian | Segretario | 5 The Pightle Grazeley Green RG7 1NF Reading Berkshire | British | 39134400001 | ||||||
| LOWEN, Kevin Geoffrey | Segretario | 8 Phillips Close Woodley RG5 4XD Reading Berkshire | British | 48625230001 | ||||||
| PAUL, Adrian | Segretario | 28 Shepherds Mount Compton RG20 6QZ Newbury Berkshire | British | 63363910001 | ||||||
| ROCKETT, Jennifer | Segretario | 56 Crockhamwell Road Woodley RG5 3LB Reading Berkshire | British | 81948550001 | ||||||
| SKOTAK, Theresa Lynn | Segretario | Research Drive 48309 Rochester Hills 2791 Mi Usa | United States | 121512090001 | ||||||
| PHILSEC LIMITED | Segretario | No 1 Colmore Square B4 6AA Birmingham West Midlands | 100887680001 | |||||||
| PITSEC LIMITED | Segretario | 47 Castle Street RG1 7SR Reading Berkshire | 38734010001 | |||||||
| ADAMS, Geoffrey | Amministratore | Portwall Place Portwall Lane BS1 9HS Bristol C/O Dac Beachcroft Llp United Kingdom | United Kingdom | British | 177798000001 | |||||
| BECKETT, Michael | Amministratore | Portwall Place Portwall Lane BS1 9HS Bristol C/O Dac Beachcroft Llp United Kingdom | United Kingdom | British | 265344320001 | |||||
| BLACK, Hugh | Amministratore | 5 Twycross Road Keephatch Park RG40 5PE Wokingham Berkshire | British | 17774840002 | ||||||
| BOULANGER, Francois Jean | Amministratore | 59 Avenue Des Lacs F-94100 St Maur France | France | French | 85663900001 | |||||
| BROOKS, David George | Amministratore | Llwyn Y Felin Llanddowror SA33 4JE St Clears Carmarthen | United Kingdom | British | 77498070001 | |||||
| BROWN, Jay Norman | Amministratore | Pond Run 48326 Auburn Hills 1780 Michigan United States | United States | American | 294550220001 | |||||
| COLBY, Malcolm | Amministratore | 5 Heather Close Finchampstead RG40 4PX Wokingham Berkshire | British | 51889040001 | ||||||
| COLLINS, Paul Nicholas | Amministratore | 23 Tinwell Close Lower Earley RG6 3BJ Reading Berkshire | British | 31314280001 | ||||||
| DAVIS, Brian | Amministratore | 5 The Pightle Grazeley Green RG7 1NF Reading Berkshire | England | British | 39134400001 | |||||
| DONG, Glenn | Amministratore | 1518 Linwood Avenue 48103 Ann Arbor Michigan 48103 Usa | Us Citizen | 113389420001 | ||||||
| EDWARDS, Martin Howard | Amministratore | 36 Twatling Road Barnt Green B45 8HU Birmingham | England | British | 243806010001 | |||||
| ETZKORN, Lillian Dorina | Amministratore | Pond Run MI 48326 Auburn Hills 1780 United States | United States | American | 286442620001 | |||||
| GREGORY, James | Amministratore | Research Drive Rochester Hills 2791 Michigan 48309 Usa | Usa | American | 163470390001 | |||||
| HENRIQUES, Jose Carlos Infante | Amministratore | Portwall Place Portwall Lane BS1 9HS Bristol C/O Dac Beachcroft Llp United Kingdom | Portugal | Portuguese | 286441470001 | |||||
| JOHNSTON, Stephen Eric | Amministratore | Pond Run Auburn Hills Oakland Country 1780 Mi, 48326 United States | United States | British,American | 272855500001 | |||||
| JOHNSTON, Stephen Eric | Amministratore | Portwall Place Portwall Lane BS1 9HS Bristol C/O Dac Beachcroft Llp United Kingdom | United States | British,American | 272855500001 | |||||
| LAVINE, Jerrold Isaac | Amministratore | 100 New Bridge Street London EC4V 6JA | Usa | American | 198390240001 | |||||
| LIDDELL, Alfred | Amministratore | 2617 Sabin Way 37174 Spring Hill Tennessee Usa | American | 85072280001 | ||||||
| LOWEN, Kevin Geoffrey | Amministratore | 8 Phillips Close Woodley RG5 4XD Reading Berkshire | England | British | 48625230001 | |||||
| MAGAL, Gamil | Amministratore | The Bank House High Street, Napton CV23 8LP Rugby Warwickshire | British | 64792780001 | ||||||
| MARCHIANDO, Keith | Amministratore | 3996 Lincoln Drive 48301 Bloomfield Hills Oakland 48301 Usa | Us Citizen | 104731620001 | ||||||
| MCINTYRE, Pamela Lynn | Amministratore | Portwall Place Portwall Lane BS1 9HS Bristol C/O Dac Beachcroft Llp United Kingdom | United States | American | 250808080001 | |||||
| MENZIES, Graham Reid | Amministratore | Harcombe House 4 Lambridge Wood Road RG9 3BS Henley On Thames Oxfordshire | British | 68409800001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DURA AUTOMOTIVE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dura Holdings Limited | 06 apr 2016 | Portwall Place Portwall Lane BS1 9HS Bristol C/O Dac Beachcroft Llp United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
DURA AUTOMOTIVE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 07 dic 2001 Acquisito il 20 giu 2002 Consegnato il 27 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The f/h land and buildings lying to the north east of yspitty road llanelli and land at bynea llanelli lying to the east of yspitty road t/n's CYM30881 and CYM44559. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A supplemental deed to a debenture | Creato il 19 mar 1999 Acquisito il 11 gen 2000 Consegnato il 01 feb 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due from the company (formerly known as adwest western thomson limited) | |
Brevi particolari By way of legal mortgage all right title estate and other interests in the properties k/a worcester road stourport-on-severn DY13 9LA and baldwinn road stourport-on-severn DY13 9BB,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 mag 1998 Acquisito il 11 gen 2000 Consegnato il 01 feb 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due from the company (formerly known as adwest western thomson limited) | |
Brevi particolari By way of legal mortgage all right title estate and other interests in the properties k/a worcester road stourport-on-severn DY13 9LA and baldwinn road stourport-on-severn DY13 9BB,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0