PAYLESS PROPERTIES LIMITED

PAYLESS PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPAYLESS PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00543407
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PAYLESS PROPERTIES LIMITED?

    • (7012) /

    Dove si trova PAYLESS PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Greater Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PAYLESS PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PAYLESS D.I.Y. LIMITED10 dic 198510 dic 1985
    TUBBS BUILDING SUPPLIES LIMITED 01 lug 198501 lug 1985
    PAYLESS D.I.Y. LIMITED01 gen 198301 gen 1983
    MARLEY HOMECARE LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    MARLEY RETAIL LIMITED17 gen 195517 gen 1955

    Quali sono gli ultimi bilanci di PAYLESS PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al21 feb 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per PAYLESS PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 01 mag 2012

    27 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 nov 2011

    36 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    97 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    95 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    9 pagine2.16B

    Dettagli del direttore cambiati per Mr William Grimsey il 13 mag 2011

    3 pagineCH01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Indirizzo della sede legale modificato da Gawsworth House Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6XB in data 11 mag 2011

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Brian Robbins come amministratore

    2 pagineTM01

    Dettagli del segretario cambiati per Dawn Michelle Wilkinson il 11 ott 2010

    3 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Thomas Christopher Morgan il 11 ott 2010

    3 pagineCH01

    Cessazione della carica di Richard Bird come amministratore

    2 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Patrick Gladwin il 11 ott 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Brian Keith Robbins il 11 ott 2010

    3 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 21 feb 2010

    7 pagineAA

    Nomina di Brian Keith Robbins come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 ago 2010

    Stato del capitale al 10 ago 2010

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Nomina di Thomas Christopher Morgan come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Unitt come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Penelope Teale come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 22 feb 2009

    7 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di PAYLESS PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILKINSON, Dawn Michelle
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United Kingdom
    British105435010001
    GLADWIN, Robert Patrick
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    Amministratore
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United KingdomBritish130288970001
    GRIMSEY, William
    9 The Avenue
    WD7 7DG Radlett
    Tall Timbers
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 The Avenue
    WD7 7DG Radlett
    Tall Timbers
    Hertfordshire
    United KingdomBritish50647840004
    MORGAN, Thomas Christopher
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    Amministratore
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United KingdomBritish152428250002
    BANKS, David
    Ground Floor Flat Redland Green Road
    BS6 7HE Bristol
    Avon
    Segretario
    Ground Floor Flat Redland Green Road
    BS6 7HE Bristol
    Avon
    British87235970001
    FENNELL, Sonia
    Gilliver Cottage Gilliver Lane
    Clipston On The Wolds
    NG12 5PD Nottingham
    Segretario
    Gilliver Cottage Gilliver Lane
    Clipston On The Wolds
    NG12 5PD Nottingham
    British9591230004
    HOSKINS, William
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    British121893830001
    HUGHES, Gerard Maxwell
    53 Chesilton Road
    Fulham
    SW6 5AA London
    Segretario
    53 Chesilton Road
    Fulham
    SW6 5AA London
    British70698270002
    RIMMER, Barbara
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British76973560002
    STEVENS, Philip Alan
    31 Summit Drive
    IG8 8QW Woodford Green
    Essex
    Segretario
    31 Summit Drive
    IG8 8QW Woodford Green
    Essex
    British9581300001
    WILLIAMS, David Robert
    15 St Stephens Road
    CH42 8PP Prenton
    Merseyside
    Segretario
    15 St Stephens Road
    CH42 8PP Prenton
    Merseyside
    British157062220001
    WILSON, Geoffrey Charles
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Segretario
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British72996700001
    ARCHER, William Ernest
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    British15170380004
    BANKS, David
    Ground Floor Flat Redland Green Road
    BS6 7HE Bristol
    Avon
    Amministratore
    Ground Floor Flat Redland Green Road
    BS6 7HE Bristol
    Avon
    British87235970001
    BIRD, Richard Sidney
    80 Wolsey Road
    HA6 2EH Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    80 Wolsey Road
    HA6 2EH Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish111500210002
    BOWE, Alan Laurence
    Church View Farmhouse
    Church Lane, Osgathorpe
    LE12 9SY Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Church View Farmhouse
    Church Lane, Osgathorpe
    LE12 9SY Loughborough
    Leicestershire
    British64241650002
    COHEN, John Alexander
    7 Rectory Gardens
    Wollaton
    NG8 2AR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    7 Rectory Gardens
    Wollaton
    NG8 2AR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish25406220001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    3 Cottage Farm Close
    Osgathorpe
    LE12 9UE Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    3 Cottage Farm Close
    Osgathorpe
    LE12 9UE Loughborough
    Leicestershire
    British52040210002
    GILES, Alan James
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    Amministratore
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    EnglandBritish156046020001
    HOOD, John
    Briarwood
    15 Twatling Road Barnt Green
    B45 8HX Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Briarwood
    15 Twatling Road Barnt Green
    B45 8HX Birmingham
    West Midlands
    British39644740001
    HOSKINS, William
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    British121893830001
    JOHNSON, Stephen Richard
    The Old Vicarage
    Lower Dunsforth
    YO26 9SA York
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Lower Dunsforth
    YO26 9SA York
    EnglandBritish87398750001
    MCDOUGAL, Robert Hugh
    41 Tensing Close Great Sankey
    WA5 5AN Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    41 Tensing Close Great Sankey
    WA5 5AN Warrington
    Cheshire
    British15170390002
    MORTON, Ivor Malcolm
    Lysander
    8 Pine Close Shottery
    CV37 9FB Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Lysander
    8 Pine Close Shottery
    CV37 9FB Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    British30725390003
    MURRAY, Stephan Peter
    Red Brick Barn
    Caythorpe
    NG14 7EB Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Red Brick Barn
    Caythorpe
    NG14 7EB Nottingham
    Nottinghamshire
    British53490630001
    PIGGOTT, Kenneth Stanton
    172 Loughborough Road
    NG11 6LF Ruddington
    Nottingham
    Amministratore
    172 Loughborough Road
    NG11 6LF Ruddington
    Nottingham
    United KingdomBritish144061950001
    RADFORD, Kenneth Thomas
    21 Melton Road
    Tollerton
    NG12 4EL Nottingham
    Amministratore
    21 Melton Road
    Tollerton
    NG12 4EL Nottingham
    British47191400001
    ROBBINS, Brian Keith
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    Amministratore
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United KingdomAmerican153559370002
    RUSSELL, Stephen George
    The Manor Barn
    19b Far Street Wymeswold
    LE12 6TZ Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    The Manor Barn
    19b Far Street Wymeswold
    LE12 6TZ Loughborough
    Leicestershire
    British145267530001
    SCRIBBINS, Rodney Martin
    The Hemploe
    Hemploe Road
    NN6 6HF Welford
    Northampton
    Amministratore
    The Hemploe
    Hemploe Road
    NN6 6HF Welford
    Northampton
    EnglandBritish98160250001
    SINCLAIR, Jonathan Stuart
    57 Hallfields
    Edwalton
    NG12 4AA Nottingham
    Amministratore
    57 Hallfields
    Edwalton
    NG12 4AA Nottingham
    British45080280003
    TEALE, Penelope Jane
    1 Weldon Rise
    Off Pitcher Lane
    MK5 8BW Loughton
    Milton Keynes
    Amministratore
    1 Weldon Rise
    Off Pitcher Lane
    MK5 8BW Loughton
    Milton Keynes
    United KingdomBritish126053080001
    THOMAS, Shelley Frances
    Everest Road
    SK14 4DX Hyde
    Woodside Farm
    Cheshire
    Amministratore
    Everest Road
    SK14 4DX Hyde
    Woodside Farm
    Cheshire
    United KingdomBritish133244600001
    UNITT, Andrew Vaughan
    64 Main Street
    LE74 4UU Cossington
    Hollycroft
    Leicester
    Amministratore
    64 Main Street
    LE74 4UU Cossington
    Hollycroft
    Leicester
    EnglandBritish182500750001
    UNITT, Andrew Vaughan
    64 Main Street
    LE74 4UU Cossington
    Hollycroft
    Leicester
    Amministratore
    64 Main Street
    LE74 4UU Cossington
    Hollycroft
    Leicester
    EnglandBritish182500750001

    PAYLESS PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security accession deed
    Creato il 22 feb 2007
    Consegnato il 06 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. London Branch (The Security Agent)
    Transazioni
    • 06 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 19 ago 1998
    Consegnato il 03 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any group company (as therein defined) to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries, as therein defined) under the banking documents and the mezzanine loan agreement (both as therein defined) whether pursuant to the guarantee (as therein defined) or otherwise and in each case under the working capital facility letter
    Brevi particolari
    F/H property known as bonehill road tamworth t/n SF319160, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 13 nov 1968
    Consegnato il 02 dic 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Trust deed for further securing £5,000,000 debenture stock of the marley tile (holding) company LTD. Secured by two trust deeds dated 14/2/58 & 8/5/63 respectively.
    Brevi particolari
    Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Pearl Assurance Company LTD.
    Transazioni
    • 02 dic 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PAYLESS PROPERTIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 mag 2012Fine dell'amministrazione
    05 mag 2011Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Allport
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praticante
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praticante
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Alan Michael Hudson
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0