SRP NEW THAMES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SRP NEW THAMES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00543506 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SRP NEW THAMES LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SRP NEW THAMES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 350 Euston Road NW1 3AX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SRP NEW THAMES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| M-REAL NEW THAMES LIMITED | 18 mag 2001 | 18 mag 2001 |
| NEW THAMES PAPER COMPANY LIMITED | 10 dic 1991 | 10 dic 1991 |
| UK PAPER (SOUTHERN) LIMITED | 18 feb 1988 | 18 feb 1988 |
| U.K. PAPER (SOUTHERN) LIMITED | 11 gen 1988 | 11 gen 1988 |
| BOWATERS UNITED KINGDOM PAPER COMPANY LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
| BOWATER STEAMSHIP COMPANY LIMITED (THE) | 19 gen 1955 | 19 gen 1955 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SRP NEW THAMES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per SRP NEW THAMES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 24 gen 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2019 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anne Steele come amministratore in data 31 ott 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anne Steele come segretario in data 31 ott 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Zillah Wendy Stone come segretario in data 31 ott 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Ms Zillah Wendy Stone come amministratore in data 31 ott 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2018 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr William Beverley Hicks il 25 lug 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Paul Jowett come amministratore in data 21 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr William Beverley Hicks come amministratore in data 21 gen 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SRP NEW THAMES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STONE, Zillah Wendy | Segretario | Euston Road NW1 3AX London 350 | 252489370001 | |||||||
| HICKS, William Beverley | Amministratore | Euston Road NW1 3AX London 350 | United Kingdom | British | 132456870003 | |||||
| STONE, Zillah Wendy | Amministratore | Euston Road NW1 3AX London 350 | United Kingdom | British | 55643660001 | |||||
| COLLINGS, Bryan Reginald Emerson | Segretario | 3 Bowyer Road Seasalter CT5 4AE Whitstable Kent | British | 7525760001 | ||||||
| SCUDDER, David | Segretario | 2 Recreation Way Kemsley ME10 2RD Sittingbourne Kent | British | 7525770003 | ||||||
| STEELE, Anne | Segretario | Whitebrook Park 68 Lower Cookham Road SL6 8XY Maidenhead Beech House Berkshire | British | 77624110001 | ||||||
| AUGUST, Montgomery Sydney | Amministratore | The Old Vicarage Patrixbourne CT4 5BP Canterbury Kent | United Kingdom | British | 310570001 | |||||
| BOORMAN, Malcolm Albert | Amministratore | 12 Gore Court Road ME10 1QN Sittingbourne Kent | British | 12468400001 | ||||||
| BRISTOW, James Terence | Amministratore | Challock House Canterbury Road Challock TN25 4DL Ashford Kent | England | British | 25211850002 | |||||
| CATTERMOLE, Carolyn Tracy | Amministratore | Whitebrook Park 68 Lower Cookham Road SL6 8XY Maidenhead Beech House Berkshire | United Kingdom | British | 53026290002 | |||||
| CLINTON, John Anthony | Amministratore | 57 Second Avenue Mortlake SW14 8QF London | Irish | 55664490002 | ||||||
| DRYDEN, Stephen William | Amministratore | Whitebrook Park 68 Lower Cookham Road SL6 8XY Maidenhead Beech House Berkshire | England | British | 47821400004 | |||||
| ECLAIR-HEATH, Geoffrey | Amministratore | Pelham Lodge Pines Road BR1 2AA Bickley Kent | British | 22140720001 | ||||||
| HAMILTON, David Charles | Amministratore | 1 Grove Court Farm Boughton Under Blean ME13 9SH Faversham Kent | British | 22775470001 | ||||||
| HARVEY, Andrew | Amministratore | 24 Kidbrooke Park Road Blackheath SE3 0LW London | British | 42444340001 | ||||||
| HARVEY, St John Martin | Amministratore | 17 Millbrook Close Tovil ME15 6FZ Maidstone Kent | British | 52129780001 | ||||||
| JENNER, Mark Andrew | Amministratore | The Vine House Bekesbourne Hill Bekesbourne CT4 5ED Canterbury Kent | British | 32178860001 | ||||||
| JOWETT, Matthew Paul | Amministratore | Euston Road NW1 3AX London 350 United Kingdom | England | British | 205867540001 | |||||
| KELLY, Michael Stewart | Amministratore | Court House Rectory Lane Sutton Valence ME17 3BS Maidstone Kent | New Zealand | 19673840001 | ||||||
| LANGFIELD, Douglas Martin | Amministratore | Erriotwood House Erriotwood Lynstead Sittingbourne Kent | British | 22775440001 | ||||||
| MATTHEWS, David John | Amministratore | Euston Road NW1 3AX London 350 United Kingdom | England | British | 101577480001 | |||||
| METSAVIRTA, Aarre | Amministratore | Harjutie 28b 02730 Espoo Finland | Finnish | 46901220001 | ||||||
| NEWMAN, Geoffrey Alan | Amministratore | Jackie Clovelly Drive Minster ME12 2SF Sheerness Kent | British | 39394490001 | ||||||
| NOPONEN, Jussi Matti | Amministratore | Kruununtie 21f FOREIGN F1 02750 1 Espoo Finland | Finnish | 120921390001 | ||||||
| OLLARD, John Deacon | Amministratore | 69 Pine Walk SM5 4HA Carshalton Beeches Surrey | United Kingdom | British | 34333830001 | |||||
| PAMPHILON, Paul | Amministratore | 11 Bachcroft Chestfield CT5 3QF Whitstable Kent | British | 22775450001 | ||||||
| PARVI, Seppo Matti | Amministratore | Kylanraitti 4a FOREIGN F1-00700 Helkinki Finland | Finland | Finnish | 150765210001 | |||||
| PLUMMER, Carrol Annette | Amministratore | 16a Love Lane ME1 1TN Rochester Kent | British | 32178880002 | ||||||
| ROBERTS, Miles William | Amministratore | Whitebrook Park 68 Lower Cookham Road SL6 8XY Maidenhead Beech House Berkshire | England | British | 57880630003 | |||||
| ROSSER, Christopher Robert | Amministratore | Whitebrook Park 68 Lower Cookham Road SL6 8XY Maidenhead Beech House Berkshire | United Kingdom | Australian British | 191538850001 | |||||
| SAARINEN, Ilkka | Amministratore | 45 Sandling Way St Mary's Island ME4 3AZ Chatham Kent | British | 74915150001 | ||||||
| SALONEN, Jarmo | Amministratore | Purotie 9b FOREIGN Fin-02300 Espoo Finlanf | Finnish | 93233360001 | ||||||
| SALONEN, Jarmo | Amministratore | Charlotte House Charlotte Drive ME8 0DA Gillingham Kent | Finnish | 62529380002 | ||||||
| STEELE, Anne | Amministratore | Euston Road NW1 3AX London 350 United Kingdom | United Kingdom | British | 77624110001 | |||||
| STREET, Graham | Amministratore | The Grange Kenfield Petham CT4 5RN Canterbury Kent | British | 32178870001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SRP NEW THAMES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ds Smith Paper Limited | 06 apr 2016 | Euston Road NW1 3AX London 350 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SRP NEW THAMES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Creato il 31 dic 1969 Consegnato il 02 gen 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Mortgage for further securing debenture stock of the company amounting to sterling pounds 5,000.000 secured by a trust deed dated 22 may 1959 and a deed supplemental thereto dated 17 dec. 1969. | |
Brevi particolari All those 64/64THS of the steamship nina bowater official no: 30281. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 08 set 1960 Consegnato il 19 set 1960 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For further securing £5,000,000 debenture stock secured by a trust deed dated 22/5/59. | |
Brevi particolari 64/64THS shares in "phyllis bowater" official no 301121. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Seven mortgages | Creato il 22 mag 1959 Consegnato il 26 mag 1959 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Seven mortgages each dated 22ND may 1959 for further securing sterling pounds 5,000,000 debenture stock secured by a trust deed dated 22ND may, 1959 | |
Brevi particolari 64/64 ths in each of the seven day cargo vessels, namely:- margaret bowa ter no. 186187 sarah bowater no. 186287 alice bowater no. 300810 gladys bowater no. 300820 elizabeth bowater no. 187784 constance bowater no. 300756 nicholas bowater no. 187806. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture stock | Creato il 22 mag 1959 Consegnato il 25 mag 1959 | Soddisfatta integralmente | ||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0