HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED

HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00544265
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hazlehead
    Crowedge
    S36 4HG Sheffield
    South Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STONEWARE LIMITED05 feb 195505 feb 1955

    Quali sono gli ultimi bilanci di HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 18 ott 2012

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    2 pagineAA

    Nomina di Mr John Sage come amministratore in data 31 lug 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Calum James Forsyth come amministratore in data 31 lug 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 16 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 ott 2011

    Stato del capitale al 26 ott 2011

    • Capitale: GBP 350,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    2 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Taylor come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Keith Barker come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 16 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    2 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    14 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    14 pagineAA

    legacy

    1 pagine403b

    Chi sono gli amministratori di HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Paul William
    13 St Peters Grove
    YO30 6AQ York
    Segretario
    13 St Peters Grove
    YO30 6AQ York
    British62180340002
    SAGE, John
    Latimer Road
    Cropston
    LE7 7GP Leicester
    19
    United Kingdom
    Amministratore
    Latimer Road
    Cropston
    LE7 7GP Leicester
    19
    United Kingdom
    EnglandBritish171410140001
    TAYLOR, Paul William
    13 St Peters Grove
    YO30 6AQ York
    Amministratore
    13 St Peters Grove
    YO30 6AQ York
    United KingdomBritish62180340002
    PHILLIPS, Robert Glyn
    23 Mead Way
    Kirkburton
    HD8 0TG Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    23 Mead Way
    Kirkburton
    HD8 0TG Huddersfield
    West Yorkshire
    British842980001
    BARKER, Keith Stuart
    12 Tan House Lane
    Parbold
    WN8 7HG Wigan
    Greater Manchester
    Amministratore
    12 Tan House Lane
    Parbold
    WN8 7HG Wigan
    Greater Manchester
    EnglandBritish110773520001
    BARNETT, Michael David
    26 Brough Road
    South Cave
    HU15 2BX Brough
    North Humberside
    Amministratore
    26 Brough Road
    South Cave
    HU15 2BX Brough
    North Humberside
    United KingdomBritish102557780001
    BEEVER, Robert Neville
    Dalveen Woodhead Road
    Holmfirth
    HD7 1PX Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Dalveen Woodhead Road
    Holmfirth
    HD7 1PX Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish1646430001
    BIRD, Stephen Clive
    South End Cottage Orleans Road
    TW1 3BL Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    South End Cottage Orleans Road
    TW1 3BL Twickenham
    Middlesex
    British47512480003
    BROSSET, Michel, Dr
    Am Sportplatz 6
    Monheim/Rhein
    D-40789
    Germany
    Amministratore
    Am Sportplatz 6
    Monheim/Rhein
    D-40789
    Germany
    French75143240001
    DOE, Brian
    Whiterails Kington Langley
    SN15 5NS Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    Whiterails Kington Langley
    SN15 5NS Chippenham
    Wiltshire
    British30733690001
    FORSYTH, Calum James
    Galloping Lane
    Paddlebrook Barns Ditchford On Fosse
    GL56 9QT Moreton In Marsh
    The Stables
    Gloucestershire
    Amministratore
    Galloping Lane
    Paddlebrook Barns Ditchford On Fosse
    GL56 9QT Moreton In Marsh
    The Stables
    Gloucestershire
    EnglandUk172355700002
    GALE, Paul Nicolas
    Ash Cottage
    Upper Wilshaw
    HD7 3EA Holmfirth
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ash Cottage
    Upper Wilshaw
    HD7 3EA Holmfirth
    West Yorkshire
    British72881120001
    GORANSSON, Rolf Claes Erik
    Unter Den Ulmen 1
    50968 Koln
    Germany
    Amministratore
    Unter Den Ulmen 1
    50968 Koln
    Germany
    Sweden73403360003
    HASKELL, Peter
    1 Clarel Street
    Penistone
    S30 6AU Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    1 Clarel Street
    Penistone
    S30 6AU Sheffield
    South Yorkshire
    British1646450001
    HOUBEN, Philippus Petrus Franciscus Clemens
    Zuider Stationsweg 2d
    2061 He Bloemendaal
    The Netherlands
    Amministratore
    Zuider Stationsweg 2d
    2061 He Bloemendaal
    The Netherlands
    NetherlandsDutch71084460001
    LEMON, David Edward Leonard
    6 Hillcrest Avenue
    South Normanton
    DE55 3NR Alfreton
    Derbyshire
    Amministratore
    6 Hillcrest Avenue
    South Normanton
    DE55 3NR Alfreton
    Derbyshire
    British2649630001
    PHILLIPS, Robert Glyn
    23 Mead Way
    Kirkburton
    HD8 0TG Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    23 Mead Way
    Kirkburton
    HD8 0TG Huddersfield
    West Yorkshire
    British842980001
    REDDICK, Terence William
    Shires Rest
    Gainsborough Road
    DN10 5DF Drakeholes
    Amministratore
    Shires Rest
    Gainsborough Road
    DN10 5DF Drakeholes
    British92835860001
    SPRATT, Quentin Rodney
    Orchard Farm
    Brow Lane Antrobus
    CW9 6JY Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Orchard Farm
    Brow Lane Antrobus
    CW9 6JY Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritish60606400001
    TAYLOR, Andrew Rankine
    Highfield Hall
    306 Barnsley Road
    WF2 6AX Sandal
    Amministratore
    Highfield Hall
    306 Barnsley Road
    WF2 6AX Sandal
    EnglandBritish158807800001
    THOMPSON, Kenneth
    105 Castle Rock Drive
    LE67 4SE Coalville
    Leicestershire
    Amministratore
    105 Castle Rock Drive
    LE67 4SE Coalville
    Leicestershire
    British1680650001

    HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 13 set 2005
    Consegnato il 23 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) under the terms of the afforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge,any real property,the charged deposits and all investments,shares and related rights.assignment,the insurances and the assigned deposits.floating charge,undertaking and assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V.(As Security Agent)
    Transazioni
    • 23 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ott 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 23 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 apr 2002
    Consegnato il 30 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and obligations due or to become due from the company (the "chargor") to each beneficiary and all other money and obligations due or to become due by each other company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including (I) vaillant house,medway city estate,trident close,rochester; K602936; (ii) land on the east side of dunster road,chelmsley wood,birmingham,west midlands; WM24946; (iii) unit D1,lowfields business park,elland,west yorkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Commerzbank Aktiengesellschaft,London (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 30 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pik debenture
    Creato il 18 apr 2002
    Consegnato il 30 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and obligations due or to become due from the company (the "chargor") to each beneficiary and all other money and obligations due or to become due by each other company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including (I) vaillant house,medway city estate,trident close,rochester; K602936; (ii) land on the east side of dunster road,chelmsley wood,birmingham,west midlands; WM24946; (iii) unit D1,lowfields business park,elland,west yorkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Commerzbank Aktiengesellschaft,London (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 30 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 dic 1980
    Consegnato il 13 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,901.18 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the chargeing subsitionery.
    Persone aventi diritto
    • Sachroder Ececutor & Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 13 gen 1989Registrazione di un'ipoteca

    HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 ott 2013Data di scioglimento
    18 ott 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0