GENTRA LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GENTRA LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00544337 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GENTRA LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova GENTRA LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Joanna Scott, Level 15, Citypoint 1 Ropemaker Street EC2Y 9AW London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GENTRA LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ROYAL TRUST BANK | 03 nov 1986 | 03 nov 1986 |
| ROYAL TRUST COMPANY OF CANADA (THE) | 08 feb 1955 | 08 feb 1955 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GENTRA LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per GENTRA LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 feb 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 feb 2019 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per P Keith Hyde il 05 dic 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ricky Tang il 05 dic 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Gentra Holdings Company come persona con controllo significativo il 03 ago 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Joanna Scott 99 Bishopsgate Level 2 London EC2M 3XD England a Joanna Scott, Level 15, Citypoint 1 Ropemaker Street London EC2Y 9AW in data 03 ago 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 feb 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Secondo deposito di AR01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio aggiornato al 24 feb 2016 | 22 pagine | RP04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Allen Yi il 11 mar 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Nomina di Ricky Tang come amministratore in data 08 feb 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Bryan Kenneth Davis come amministratore in data 08 feb 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 18 lug 2014
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , C/O Berwin Leighton Paisner Llp, D Hughes Adelaide House, London Bridge, London, EC4R 9HA a C/O Joanna Scott 99 Bishopsgate Level 2 London EC2M 3XD in data 25 set 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GENTRA LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YI, Allen | Segretario | Bay Street, Suite 330 Toronto 181 Ontario M5j 2t3 Canada | British | 187547370001 | ||||||
| HYDE, P Keith | Amministratore | 1 Ropemaker Street EC2Y 9AW London Joanna Scott, Level 15, Citypoint England | Canada | Canadian | 105505500001 | |||||
| TANG, Ricky | Amministratore | 1 Ropemaker Street EC2Y 9AW London Joanna Scott, Level 15, Citypoint England | United States | Canadian | 206973950002 | |||||
| GREGORY, Philip Charles | Segretario | Mulberry House 26 North Grove Highgate N6 4SL London | British | 33287640001 | ||||||
| HYDE, P Keith | Segretario | 26 Hambly Avenue Toronto Ontario M4e 2r6 Canada | Canadian | 105505500001 | ||||||
| IRONSIDE, Simon Anthony | Segretario | 2 Orchard Mews Southgate Grove Islington N1 5BS London | British | 31215710001 | ||||||
| MOODY, Patricia Joan | Segretario | 8 Riverdene HA8 9TD Edgware Middlesex | British | 5286990001 | ||||||
| MULROY, Kieran Finbarr | Segretario | 31 White Lodge Crescent L4C 9A1 Richmond Hill Ontario Canada | Canadian | 48720010001 | ||||||
| WICKS, Martin Theodore | Segretario | 206 Britannia Drive 431 Grand Cayman Box 30616 Smb Cayman Islands | British | 62800470003 | ||||||
| BARR, Brian Ernest | Amministratore | C/O Falconbridge Limited 181 Bay Street Suite 200 Bce Place Toronto Ontario M5j2t3 Canada | British Canadian | 7708890001 | ||||||
| BRIERLEY, Michael Charles | Amministratore | 45 Carisbrooke Gardens LE2 3PR Leicester Leicestershire | British | 5287010001 | ||||||
| CAPE, Edmund Andrew | Amministratore | 75 Rosedale Heights Drive Toronto Ontario FOREIGN Canada | Canadian | 36523210001 | ||||||
| CORNELISSEN, Michael Adriaan | Amministratore | 2061 Lakeshore Road East FOREIGN Oakville Ontario L6j 1x4 Canada | Canadian | 7708900001 | ||||||
| DAVENPORT, Maurice Hopwood | Amministratore | Pines Dormans Park RH19 2LX East Grinstead West Sussex | United Kingdom | British | 6765160001 | |||||
| DAVIS, Bryan Kenneth | Amministratore | 75 Buckingham Avenue Toronto Ontario M4n 1r3 Canada | Canada | Canadian | 111671370001 | |||||
| DONNE, David Lucas | Amministratore | 8 Montague Mews North W1H 1AH London | United Kingdom | British | 36527200001 | |||||
| FAIRCHILD, Robert William | Amministratore | 26 Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | Britain | British | 16613760002 | |||||
| FELL, Fraser Matthews | Amministratore | 34 Glenorchy Road M3C 2P9 Don Mills Ontario Canada | Canadian | 36469670001 | ||||||
| FREUND, Michael Walter | Amministratore | 272 Belsize Drive M4S 1M6 Toronto Ontario Canada | Canadian | 36469710001 | ||||||
| GAMBLE, Horace Roy | Amministratore | River Lodge 1 Ravensbury Drive TQ6 9BZ Dartmouth Devon | British | 4379420001 | ||||||
| HARKER, William Clinton | Amministratore | 88 Hermitage Court Knighten Street E1 9PW London | Canadian | 22380340003 | ||||||
| HOLBECHE, Philip Leslie | Amministratore | 7 Milburn Walk KT18 5JN Epsom Surrey | United Kingdom | British | 7708940001 | |||||
| JOLY, Laurent Maurice | Amministratore | 4 Berkeley Gardens Kensington W8 4AP London | Canadian | 48827400001 | ||||||
| KELLER-HOBSON, Donald Stephen Douglas | Amministratore | 48-50 Cannon Street EC4N 6LD London | Canadian | 36228770001 | ||||||
| KIMBALL, Marcus Richard, Lord | Amministratore | Great Easton Manor LE16 8TB Market Harborough Leicestershire | British | 7708960001 | ||||||
| LAMBERT, Allen Thomas | Amministratore | 483 Russell Hill Road FOREIGN Toronto Ontario M5p 2s8 Canada | Canadian | 7708970001 | ||||||
| LAURIE, Craig J | Amministratore | The World Financial Center 200 Vesey Street 11th Floor New York Ny 10281-1021 Usa | Canadian | 105152590003 | ||||||
| LOVEGROVE, Philip Albert | Amministratore | 50 Thorley Lane Bishops Stortford CM23 4AD Hertfordshire | British | 35568310001 | ||||||
| MACDOUGALL, Hartland Molson | Amministratore | Belfountain FOREIGN Ontario L0n 1bo Canada | Canadian | 7708980001 | ||||||
| MILLER, James William | Amministratore | 670 Fairmile Road V75 IR2 West Vancouver Bc Canada | Canadian | 34028940001 | ||||||
| PORTER, Michael Andrew | Amministratore | Pitt Cottage Church Street Great Baddow CM2 7AA Chelmsford Essex | British | 32404350001 | ||||||
| STROYAN, Colin Strathearn Ropner | Amministratore | Bridgend Of Teith FK16 6AD Doune Perthshire | United Kingdom | British | 1866210001 | |||||
| WALKER, James Barrett | Amministratore | 53 Hillhurst Boulevard M5N 1N5 Toronto Ontario Canada | Canadian | 36469780001 | ||||||
| ONTARIO LIMITED | Amministratore | Suite 1400 70 York Street Toronto Ontario M5j 1sj Canada | 48719890001 | |||||||
| SURREY INVESTMENTS INCORPORATED | Amministratore | Box 30616 Smb Genesis Building Genesis Close Grand Cayman Cayman Islands | 68083360002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GENTRA LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentra Holdings Company | 19 apr 2016 | 1 Ropemaker Street EC2Y 9AW London Joanna Scott, Level 15, Citypoint England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
GENTRA LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment | Creato il 11 nov 1994 Consegnato il 21 nov 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of the contract. The sum of £24,000 deposited with barclays finance company (isle of man) limited in the name of gentra limited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment | Creato il 21 lug 1994 Consegnato il 29 lug 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The obligations of the company to the chargee (as defined in the deed) | |
Brevi particolari The sum of £952,500 in account no 31538268. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over cash | Creato il 13 apr 1994 Consegnato il 14 apr 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in connection with the hutton guarantee and/or this charge | |
Brevi particolari Any sum or sums deposited in account no. 548-785-5 and any debts represented thereby. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 09 mar 1994 Consegnato il 24 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the counter-indemnity of even date and/or this agreement | |
Brevi particolari All of the company's right title benefit and interest in and to the obligations of the mortgagee to make payment of all amounts standing to the credit to the company's deutschmark call deposit account maintained with the mortgagee and designated "royal bank of canada europe limited re: gentra - cash collateral a/c" and in and to all interest arising in connection therewith and all other amounts credited to the account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage sale agreement | Creato il 29 lug 1993 Consegnato il 05 ago 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement (as defined) | |
Brevi particolari The sum of £7,918,194.00 credited to the midland bank PLC of poultry & princes street,london EC2P 2BX, account number 21381679 together with all sums in the future credited to that account and including interest accrued or accruing in the future on the account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security document | Creato il 18 giu 1993 Consegnato il 05 lug 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage the charged assets and by way of floating charge the charged assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental security document | Creato il 04 giu 1993 Consegnato il 22 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the sub-participation agreement (as defined therein) | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage all the additional charged assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security document | Creato il 17 mag 1993 Consegnato il 07 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sub-participation agreement dated 17 may 1993. | |
Brevi particolari The chargor charges as beneficial owner in favour of the bank by way of first legal mortgage the charged assets as defined.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security document | Creato il 07 mag 1993 Consegnato il 26 mag 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the sub-participation agreement dated 7 may 1993. | |
Brevi particolari The chargor as beneficial owner charges in favour of the bank by way of first legal mortgage the charged assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security document | Creato il 23 apr 1993 Consegnato il 10 mag 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the charged assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security document | Creato il 22 apr 1993 Consegnato il 29 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement (as defined) | |
Brevi particolari All rights under any additional documents and charged assets...................see form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of amendment | Creato il 14 apr 1993 Consegnato il 29 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For amending the sub-participation agreement dated 7.4.93 (as defined) | |
Brevi particolari All present and future rights......see form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security document | Creato il 07 apr 1993 Consegnato il 22 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the "charged assets" being the loan portfolio and all rights of the company under any additional documents connected with the loan portfolio. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security document | Creato il 12 mar 1993 Consegnato il 26 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the "charged assets". See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 27 mar 1986 Consegnato il 04 apr 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land at eccleshall road, south, sheffield district of s yorks known as blenham nursing home t/n yew 41499. f/h land adjoining the above known as the blenheim lifestyle developments, t/nos. Stk 154003, ywe 41499. f/h land at old whittington chesterfield, derbyshire. F/h land off melbourne ave sheffield district of s yorks, (see doc M151 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0