GENTRA LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGENTRA LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00544337
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GENTRA LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova GENTRA LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GENTRA LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ROYAL TRUST BANK03 nov 198603 nov 1986
    ROYAL TRUST COMPANY OF CANADA (THE)08 feb 195508 feb 1955

    Quali sono gli ultimi bilanci di GENTRA LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per GENTRA LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 feb 2019 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per P Keith Hyde il 05 dic 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ricky Tang il 05 dic 2018

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    10 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Gentra Holdings Company come persona con controllo significativo il 03 ago 2018

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Joanna Scott 99 Bishopsgate Level 2 London EC2M 3XD England a Joanna Scott, Level 15, Citypoint 1 Ropemaker Street London EC2Y 9AW in data 03 ago 2018

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    12 pagineAA

    Secondo deposito di AR01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio aggiornato al 24 feb 2016

    22 pagineRP04

    Bilancio annuale redatto al 24 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 apr 2016

    Stato del capitale al 13 apr 2016

    • Capitale: GBP 123,714,259
    SH01
    Note
    DataNota
    27 apr 2016Clarification A second filed AR01 was registered on 27/04/2016

    Dettagli del segretario cambiati per Allen Yi il 11 mar 2014

    1 pagineCH03

    Nomina di Ricky Tang come amministratore in data 08 feb 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Bryan Kenneth Davis come amministratore in data 08 feb 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    11 pagineAA

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 18 lug 2014

    • Capitale: GBP 123,714,259
    3 pagineSH01

    Indirizzo della sede legale modificato da , C/O Berwin Leighton Paisner Llp, D Hughes Adelaide House, London Bridge, London, EC4R 9HA a C/O Joanna Scott 99 Bishopsgate Level 2 London EC2M 3XD in data 25 set 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 24 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 mar 2015

    Stato del capitale al 20 mar 2015

    • Capitale: GBP 108,866,959
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di GENTRA LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    YI, Allen
    Bay Street, Suite 330
    Toronto
    181
    Ontario M5j 2t3
    Canada
    Segretario
    Bay Street, Suite 330
    Toronto
    181
    Ontario M5j 2t3
    Canada
    British187547370001
    HYDE, P Keith
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    Amministratore
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    CanadaCanadian105505500001
    TANG, Ricky
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    Amministratore
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    United StatesCanadian206973950002
    GREGORY, Philip Charles
    Mulberry House
    26 North Grove Highgate
    N6 4SL London
    Segretario
    Mulberry House
    26 North Grove Highgate
    N6 4SL London
    British33287640001
    HYDE, P Keith
    26 Hambly Avenue
    Toronto
    Ontario M4e 2r6
    Canada
    Segretario
    26 Hambly Avenue
    Toronto
    Ontario M4e 2r6
    Canada
    Canadian105505500001
    IRONSIDE, Simon Anthony
    2 Orchard Mews
    Southgate Grove Islington
    N1 5BS London
    Segretario
    2 Orchard Mews
    Southgate Grove Islington
    N1 5BS London
    British31215710001
    MOODY, Patricia Joan
    8 Riverdene
    HA8 9TD Edgware
    Middlesex
    Segretario
    8 Riverdene
    HA8 9TD Edgware
    Middlesex
    British5286990001
    MULROY, Kieran Finbarr
    31 White Lodge Crescent
    L4C 9A1 Richmond Hill
    Ontario
    Canada
    Segretario
    31 White Lodge Crescent
    L4C 9A1 Richmond Hill
    Ontario
    Canada
    Canadian48720010001
    WICKS, Martin Theodore
    206 Britannia Drive 431
    Grand Cayman Box 30616 Smb
    Cayman Islands
    Segretario
    206 Britannia Drive 431
    Grand Cayman Box 30616 Smb
    Cayman Islands
    British62800470003
    BARR, Brian Ernest
    C/O Falconbridge Limited
    181 Bay Street Suite 200 Bce Place
    Toronto
    Ontario M5j2t3
    Canada
    Amministratore
    C/O Falconbridge Limited
    181 Bay Street Suite 200 Bce Place
    Toronto
    Ontario M5j2t3
    Canada
    British Canadian7708890001
    BRIERLEY, Michael Charles
    45 Carisbrooke Gardens
    LE2 3PR Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    45 Carisbrooke Gardens
    LE2 3PR Leicester
    Leicestershire
    British5287010001
    CAPE, Edmund Andrew
    75 Rosedale Heights Drive
    Toronto Ontario
    FOREIGN Canada
    Amministratore
    75 Rosedale Heights Drive
    Toronto Ontario
    FOREIGN Canada
    Canadian36523210001
    CORNELISSEN, Michael Adriaan
    2061 Lakeshore Road East
    FOREIGN Oakville
    Ontario L6j 1x4
    Canada
    Amministratore
    2061 Lakeshore Road East
    FOREIGN Oakville
    Ontario L6j 1x4
    Canada
    Canadian7708900001
    DAVENPORT, Maurice Hopwood
    Pines
    Dormans Park
    RH19 2LX East Grinstead
    West Sussex
    Amministratore
    Pines
    Dormans Park
    RH19 2LX East Grinstead
    West Sussex
    United KingdomBritish6765160001
    DAVIS, Bryan Kenneth
    75 Buckingham Avenue
    Toronto
    Ontario M4n 1r3
    Canada
    Amministratore
    75 Buckingham Avenue
    Toronto
    Ontario M4n 1r3
    Canada
    CanadaCanadian111671370001
    DONNE, David Lucas
    8 Montague Mews North
    W1H 1AH London
    Amministratore
    8 Montague Mews North
    W1H 1AH London
    United KingdomBritish36527200001
    FAIRCHILD, Robert William
    26 Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Amministratore
    26 Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    BritainBritish16613760002
    FELL, Fraser Matthews
    34 Glenorchy Road
    M3C 2P9 Don Mills
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    34 Glenorchy Road
    M3C 2P9 Don Mills
    Ontario
    Canada
    Canadian36469670001
    FREUND, Michael Walter
    272 Belsize Drive
    M4S 1M6 Toronto
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    272 Belsize Drive
    M4S 1M6 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian36469710001
    GAMBLE, Horace Roy
    River Lodge 1 Ravensbury Drive
    TQ6 9BZ Dartmouth
    Devon
    Amministratore
    River Lodge 1 Ravensbury Drive
    TQ6 9BZ Dartmouth
    Devon
    British4379420001
    HARKER, William Clinton
    88 Hermitage Court
    Knighten Street
    E1 9PW London
    Amministratore
    88 Hermitage Court
    Knighten Street
    E1 9PW London
    Canadian22380340003
    HOLBECHE, Philip Leslie
    7 Milburn Walk
    KT18 5JN Epsom
    Surrey
    Amministratore
    7 Milburn Walk
    KT18 5JN Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish7708940001
    JOLY, Laurent Maurice
    4 Berkeley Gardens
    Kensington
    W8 4AP London
    Amministratore
    4 Berkeley Gardens
    Kensington
    W8 4AP London
    Canadian48827400001
    KELLER-HOBSON, Donald Stephen Douglas
    48-50 Cannon Street
    EC4N 6LD London
    Amministratore
    48-50 Cannon Street
    EC4N 6LD London
    Canadian36228770001
    KIMBALL, Marcus Richard, Lord
    Great Easton Manor
    LE16 8TB Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Great Easton Manor
    LE16 8TB Market Harborough
    Leicestershire
    British7708960001
    LAMBERT, Allen Thomas
    483 Russell Hill Road
    FOREIGN Toronto
    Ontario M5p 2s8
    Canada
    Amministratore
    483 Russell Hill Road
    FOREIGN Toronto
    Ontario M5p 2s8
    Canada
    Canadian7708970001
    LAURIE, Craig J
    The World Financial Center
    200 Vesey Street 11th Floor
    New York
    Ny 10281-1021
    Usa
    Amministratore
    The World Financial Center
    200 Vesey Street 11th Floor
    New York
    Ny 10281-1021
    Usa
    Canadian105152590003
    LOVEGROVE, Philip Albert
    50 Thorley Lane
    Bishops Stortford
    CM23 4AD Hertfordshire
    Amministratore
    50 Thorley Lane
    Bishops Stortford
    CM23 4AD Hertfordshire
    British35568310001
    MACDOUGALL, Hartland Molson
    Belfountain
    FOREIGN Ontario L0n 1bo
    Canada
    Amministratore
    Belfountain
    FOREIGN Ontario L0n 1bo
    Canada
    Canadian7708980001
    MILLER, James William
    670 Fairmile Road
    V75 IR2 West Vancouver
    Bc
    Canada
    Amministratore
    670 Fairmile Road
    V75 IR2 West Vancouver
    Bc
    Canada
    Canadian34028940001
    PORTER, Michael Andrew
    Pitt Cottage
    Church Street Great Baddow
    CM2 7AA Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Pitt Cottage
    Church Street Great Baddow
    CM2 7AA Chelmsford
    Essex
    British32404350001
    STROYAN, Colin Strathearn Ropner
    Bridgend Of Teith
    FK16 6AD Doune
    Perthshire
    Amministratore
    Bridgend Of Teith
    FK16 6AD Doune
    Perthshire
    United KingdomBritish1866210001
    WALKER, James Barrett
    53 Hillhurst Boulevard
    M5N 1N5 Toronto
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    53 Hillhurst Boulevard
    M5N 1N5 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian36469780001
    ONTARIO LIMITED
    Suite 1400
    70 York Street
    Toronto
    Ontario M5j 1sj
    Canada
    Amministratore
    Suite 1400
    70 York Street
    Toronto
    Ontario M5j 1sj
    Canada
    48719890001
    SURREY INVESTMENTS INCORPORATED
    Box 30616 Smb
    Genesis Building Genesis Close
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    Amministratore
    Box 30616 Smb
    Genesis Building Genesis Close
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    68083360002

    Chi sono le persone con controllo significativo di GENTRA LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Gentra Holdings Company
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    19 apr 2016
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Unlimited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies (England And Wales
    Numero di registrazione02022747
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    GENTRA LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignment
    Creato il 11 nov 1994
    Consegnato il 21 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of the contract. The sum of £24,000 deposited with barclays finance company (isle of man) limited in the name of gentra limited.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 21 lug 1994
    Consegnato il 29 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligations of the company to the chargee (as defined in the deed)
    Brevi particolari
    The sum of £952,500 in account no 31538268.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Assurance PLC
    Transazioni
    • 29 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over cash
    Creato il 13 apr 1994
    Consegnato il 14 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in connection with the hutton guarantee and/or this charge
    Brevi particolari
    Any sum or sums deposited in account no. 548-785-5 and any debts represented thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada (Iom) Limited
    Transazioni
    • 14 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 09 mar 1994
    Consegnato il 24 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the counter-indemnity of even date and/or this agreement
    Brevi particolari
    All of the company's right title benefit and interest in and to the obligations of the mortgagee to make payment of all amounts standing to the credit to the company's deutschmark call deposit account maintained with the mortgagee and designated "royal bank of canada europe limited re: gentra - cash collateral a/c" and in and to all interest arising in connection therewith and all other amounts credited to the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada Europe Limited
    Transazioni
    • 24 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage sale agreement
    Creato il 29 lug 1993
    Consegnato il 05 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement (as defined)
    Brevi particolari
    The sum of £7,918,194.00 credited to the midland bank PLC of poultry & princes street,london EC2P 2BX, account number 21381679 together with all sums in the future credited to that account and including interest accrued or accruing in the future on the account.
    Persone aventi diritto
    • Birmingham Midshires Mortgage Asset No.1 Limited
    Transazioni
    • 05 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security document
    Creato il 18 giu 1993
    Consegnato il 05 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the charged assets and by way of floating charge the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transazioni
    • 05 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security document
    Creato il 04 giu 1993
    Consegnato il 22 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the sub-participation agreement (as defined therein)
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all the additional charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transazioni
    • 22 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security document
    Creato il 17 mag 1993
    Consegnato il 07 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sub-participation agreement dated 17 may 1993.
    Brevi particolari
    The chargor charges as beneficial owner in favour of the bank by way of first legal mortgage the charged assets as defined.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Trust Bank (Caribbean) Corporation
    Transazioni
    • 07 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security document
    Creato il 07 mag 1993
    Consegnato il 26 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the sub-participation agreement dated 7 may 1993.
    Brevi particolari
    The chargor as beneficial owner charges in favour of the bank by way of first legal mortgage the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Trustco Limited.
    Transazioni
    • 26 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security document
    Creato il 23 apr 1993
    Consegnato il 10 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Trustco Limited
    Transazioni
    • 10 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security document
    Creato il 22 apr 1993
    Consegnato il 29 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement (as defined)
    Brevi particolari
    All rights under any additional documents and charged assets...................see form 395.
    Persone aventi diritto
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transazioni
    • 29 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of amendment
    Creato il 14 apr 1993
    Consegnato il 29 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For amending the sub-participation agreement dated 7.4.93 (as defined)
    Brevi particolari
    All present and future rights......see form 395.
    Persone aventi diritto
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transazioni
    • 29 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security document
    Creato il 07 apr 1993
    Consegnato il 22 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the "charged assets" being the loan portfolio and all rights of the company under any additional documents connected with the loan portfolio. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transazioni
    • 22 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security document
    Creato il 12 mar 1993
    Consegnato il 26 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the "charged assets". See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Trust Bank (Caribbean) Corporation
    Transazioni
    • 26 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 27 mar 1986
    Consegnato il 04 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at eccleshall road, south, sheffield district of s yorks known as blenham nursing home t/n yew 41499. f/h land adjoining the above known as the blenheim lifestyle developments, t/nos. Stk 154003, ywe 41499. f/h land at old whittington chesterfield, derbyshire. F/h land off melbourne ave sheffield district of s yorks, (see doc M151 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Royal Trust Bank (Jersey) Limited
    Transazioni
    • 04 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 31 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0