SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED

SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00549109
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Long Marston
    Nr Stratford Upon Avon
    CV37 8AQ Warwickshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SIMS BIRD METALS LIMITED31 lug 199531 lug 1995
    BIRDS COMMERCIAL METALS LIMITED 12 mag 195512 mag 1955

    Quali sono gli ultimi bilanci di SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Certificato di riduzione del capitale emesso

    1 pagineCERT15

    legacy

    4 pagineOC138

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Final dividend 27/11/07
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    legacy

    1 pagine652a

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 giu 2006

    7 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 giu 2005

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 30 giu 2004

    7 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 30 giu 2003

    7 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Deliberazione elettiva

    ELRES

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILLIAMS, David Michael
    Woodgate 1 The Brickall
    Long Marston
    CV37 8QL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Segretario
    Woodgate 1 The Brickall
    Long Marston
    CV37 8QL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British63200960003
    BIRD, William Thomas
    Tre Evan House
    Llangarron
    HR9 6PR Ross On Wye
    Herefordshire
    Amministratore
    Tre Evan House
    Llangarron
    HR9 6PR Ross On Wye
    Herefordshire
    EnglandBritish69794010007
    ELLIOTT, John Henry
    Oak Priors
    Matthews Close
    CV37 6FR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Segretario
    Oak Priors
    Matthews Close
    CV37 6FR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British19153440001
    WHITTAKER, John Royston
    5 Chasely Crescent
    Up Hatherley
    GL51 3RY Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    5 Chasely Crescent
    Up Hatherley
    GL51 3RY Cheltenham
    Gloucestershire
    British93437660001
    BIRD, Anthony Patrick Michael
    Upper Billesley
    CV37 9RH Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Upper Billesley
    CV37 9RH Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish3264880001
    BIRD, Brian Francis
    Bertholey
    Llantrisant
    NP15 1LR Usk
    Monmouthshire
    Amministratore
    Bertholey
    Llantrisant
    NP15 1LR Usk
    Monmouthshire
    EnglandBritish107684500001
    BIRD, Janet Eleanor
    Upper Billesley
    CV37 9RH Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Upper Billesley
    CV37 9RH Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish6116520001
    BIRD, Terence John
    51 Evesham Street
    B49 5DS Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    51 Evesham Street
    B49 5DS Alcester
    Warwickshire
    British42447750001
    BIRD, Walter Thomas
    Tidenham Chase Court
    Tidenham Chase
    NP6 7JN Chepstow
    Gwent
    Amministratore
    Tidenham Chase Court
    Tidenham Chase
    NP6 7JN Chepstow
    Gwent
    British3264890002
    CRABB, John
    36 Cowdroy Avenue
    Cammeray
    New South Wales 2062
    Australia
    Amministratore
    36 Cowdroy Avenue
    Cammeray
    New South Wales 2062
    Australia
    Australian69623970001
    CUNNINGHAM, Ross Brodie
    22a Upper Avenue Road
    NSW 2088 Mosman
    New South Wales
    Australia
    Amministratore
    22a Upper Avenue Road
    NSW 2088 Mosman
    New South Wales
    Australia
    Australian47252680001
    ELLIOTT, John Henry
    Oak Priors
    Matthews Close
    CV37 6FR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Oak Priors
    Matthews Close
    CV37 6FR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish19153440001
    GULLIVER, Russell Keith John
    19 Lock Close
    CV37 6GF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    19 Lock Close
    CV37 6GF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Australian44620650002
    LAWLEY, Keith David
    Meadow Views
    Llantrissant
    NP15 1LG Usk
    Gwent
    Amministratore
    Meadow Views
    Llantrissant
    NP15 1LG Usk
    Gwent
    British91413240001
    MARSHALL, Michael George
    Abbotts Ground Cottage
    Broad Marston Lane
    GL55 6SJ Mickleton
    Glos
    Amministratore
    Abbotts Ground Cottage
    Broad Marston Lane
    GL55 6SJ Mickleton
    Glos
    British16614830001
    SUTCLIFFE, Jeremy Leigh
    26 Prince Albert Road
    NSW 2088 Mosman
    New South Wales
    Australia
    Amministratore
    26 Prince Albert Road
    NSW 2088 Mosman
    New South Wales
    Australia
    British50262610002
    WHEELER, David Kenneth Anthony
    13 Clinton Road
    CF64 3JD Penarth
    South Glamorgan
    Amministratore
    13 Clinton Road
    CF64 3JD Penarth
    South Glamorgan
    British70375130001

    SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 giu 1995
    Consegnato il 15 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Commonwealth Bank of Australia
    Transazioni
    • 15 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 19 lug 1993
    Consegnato il 23 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £37,253.10
    Brevi particolari
    All sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 23 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit application
    Creato il 21 mag 1992
    Consegnato il 29 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £44,755-80 under the terms of the credit ap@lication
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 29 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 21 mag 1991
    Consegnato il 29 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £106,643 pursuant to the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All of the company's right title and interest in and to all sums payable under the insurance (as defined in the form 395).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 29 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 07 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 set 1989
    Consegnato il 22 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 09 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 feb 1987
    Consegnato il 23 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Warehouse/factory fronting to birmingham road, stratford-upon-avon, warwickshire known as "ex post office stores".
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 05 lug 1985
    Consegnato il 11 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Former british telecom depot adjoining birmingham road stratford-upon-avon. (See doc M80 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Hambros Bank Limited.
    Transazioni
    • 11 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee debenture
    Creato il 11 gen 1985
    Consegnato il 29 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee & debenture
    Creato il 21 mar 1983
    Consegnato il 25 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee and debenture dated 23.2.82
    Creato il 23 feb 1982
    Consegnato il 03 mar 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property, undertaking and assets chrged by the principal deed and further deeds.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1982Registrazione di un'ipoteca
    Chattels mortgage
    Creato il 20 set 1978
    Consegnato il 21 set 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels, plant machinery and items following 3 american model 597C crawler mounted duty cycle magnet cranes serial nos cs 19083, cs 19085, cs 19087 1 american model 5720 pedestal mounted duty cycle magnet crane serial no. Cs 19081.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 21 set 1978Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee & debenture
    Creato il 23 gen 1978
    Consegnato il 07 feb 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property undertaking & assets charged by the principal deed & further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1978Registrazione di un'ipoteca
    A registered charge
    Creato il 08 giu 1977
    Consegnato il 17 giu 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of this other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assetscharge by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1977Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 22 apr 1976
    Consegnato il 29 apr 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Warehouse premises, land and bungalow, banbury road, stratford-upon-avon, warwickshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 apr 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 09 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further guarantee & debenture
    Creato il 09 mar 1976
    Consegnato il 17 mar 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany to and/or all or any of the other companies named therein the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deeds.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 1976Registrazione di un'ipoteca
    Assignment
    Creato il 04 feb 1976
    Consegnato il 24 feb 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the sum or sums of money now or to become due/owing payable to the company from birds processors LTD under the terms of an agreement dated 31/10/75 for the hiring of a harris 1335A shear serial no 401 (for details see doc M70).
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust LTD
    Transazioni
    • 24 feb 1976Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 26 set 1975
    Consegnato il 30 set 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company all or any of the other companies named in doc 64 to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital by way of fixed & floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 set 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 09 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0