VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00549181
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRITISH VITA INVESTMENTS LIMITED13 mag 195513 mag 1955

    Quali sono gli ultimi bilanci di VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    20 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian William Robb il 16 lug 2021

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Stato del capitale al 06 nov 2020

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    4 pagineSH20

    legacy

    4 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Mohammed Omar Shafi Khan come amministratore in data 12 apr 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Ian William Robb come amministratore in data 07 gen 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jonathan Mark Cheele come amministratore in data 31 dic 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Oldham Road Middleton Manchester M24 2DB

    1 pagineAD04

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VITA INDUSTRIAL (UK) LIMITED
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Segretario
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione01031815
    110906090002
    O'RIORDAN, Daniel Joseph, Mr.
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    EnglandBritish176979900001
    ROBB, Ian William
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    United KingdomBritish263073080001
    ROUND, Darren Lee
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    EnglandBritish100922110001
    SHAFI KHAN, Mohammed Omar
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    United KingdomBritish239506860001
    HODGES, John
    1a Ashlea Grove
    Grotton
    OL4 4LE Oldham
    Segretario
    1a Ashlea Grove
    Grotton
    OL4 4LE Oldham
    British350570001
    STIRZAKER, Mark Robert
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    Segretario
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    British78366970002
    TEAGUE, Alan Richard
    26 Orchard Street
    Stockton Heath
    WA4 6LH Warrington
    Segretario
    26 Orchard Street
    Stockton Heath
    WA4 6LH Warrington
    British290650004
    BHATT, Kanakrai Ramanlal
    Whiteoaks
    Chester Road Mere
    WA16 6LG Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Whiteoaks
    Chester Road Mere
    WA16 6LG Knutsford
    Cheshire
    British33879920001
    BURLEY, Nicholas James
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Amministratore
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    United KingdomBritish122799590001
    CHEELE, Jonathan Mark
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    EnglandBritish127959950003
    DOBSON, Roy
    248 Compstall Road
    Romiley
    SK6 4JG Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    248 Compstall Road
    Romiley
    SK6 4JG Stockport
    Cheshire
    British6930380002
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Belvedere Lodge
    18 Highbury Road Wimbledon Village
    SW19 7PR London
    Amministratore
    Belvedere Lodge
    18 Highbury Road Wimbledon Village
    SW19 7PR London
    EnglandBritish105961550001
    HARRIS, Howard Elliott
    15 Queen's Gate Gardens
    SW7 5LY London
    Amministratore
    15 Queen's Gate Gardens
    SW7 5LY London
    British93378750001
    HAY, Nigel Bruce
    6 Carr Holme Gardens
    Green Lane East Cabus
    PR6 7QH Garstang
    Lancashire
    Amministratore
    6 Carr Holme Gardens
    Green Lane East Cabus
    PR6 7QH Garstang
    Lancashire
    British79273660002
    MAIDEN, Jeremy Kim
    Beech Lawn
    Heath
    WF1 5SL Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Beech Lawn
    Heath
    WF1 5SL Wakefield
    West Yorkshire
    British71913700002
    MAUNDRELL, Graham Lloyd
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    United KingdomBritish56093930002
    MCGEE, Robert
    Dale Brow Farm
    61 Macclesfield Road Prestbury
    SK10 4BH Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Dale Brow Farm
    61 Macclesfield Road Prestbury
    SK10 4BH Macclesfield
    Cheshire
    British87945430001
    MELTHAM, John David
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    United KingdomBritish74570910001
    MENENDEZ, Joseph Henry
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Amministratore
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    UsaAmerican127225800003
    O'CONNOR, Calvin James John
    10 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6SZ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    10 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6SZ Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish16253240001
    OLIVER, John Lancaster
    The Croft House
    4 Hawkshill Close
    KT10 8JY Esher
    Surrey
    Amministratore
    The Croft House
    4 Hawkshill Close
    KT10 8JY Esher
    Surrey
    United KingdomUnited Kingdom116941050001
    SELLERS, Rodney Horrocks
    Stonecroft
    3 Lostock Junction Lane Lostock
    BL6 4JR Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Stonecroft
    3 Lostock Junction Lane Lostock
    BL6 4JR Bolton
    Lancashire
    EnglandEnglish53752390002
    STIRZAKER, Mark Robert
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    EnglandBritish78366970002

    Chi sono le persone con controllo significativo di VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Vita (Group) Unlimited
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    06 apr 2016
    Oldham Road
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Unlimited Company
    Paese di registrazioneU.K.
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneUk Companies House
    Numero di registrazione871669
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 apr 2009
    Consegnato il 01 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 01 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 07 dic 2007
    Consegnato il 21 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from or by a principal to each of the secured parties, all monies due or to become due from the principals and/or british vita unlimited to the secured parties and all monies due or to become due to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited (As Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 21 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 ago 2005
    Consegnato il 12 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor and each other company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all right title and interest in the tangible moveable property any account that is a mandatory prepayment account the intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital. Assigned the proceeds of any insurance policy and all related rights and the specific contracts. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited
    Transazioni
    • 12 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of deposit
    Creato il 31 dic 1993
    Consegnato il 19 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or hereafter standing to the credit of account no.301-018-5548-68-001 With the bank.
    Persone aventi diritto
    • Bank Brussels Lambert
    Transazioni
    • 19 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0