PAIG OVERSEAS LIMITED

PAIG OVERSEAS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPAIG OVERSEAS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00549628
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PAIG OVERSEAS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PAIG OVERSEAS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kpmg One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PAIG OVERSEAS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SETON HOUSE OVERSEAS LIMITED17 nov 200517 nov 2005
    BRITAX OVERSEAS LIMITED01 giu 199701 giu 1997
    B.S.G. OVERSEAS LIMITED11 lug 199411 lug 1994
    BRISTOL STREET GROUP LIMITED21 mag 195521 mag 1955

    Quali sono gli ultimi bilanci di PAIG OVERSEAS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per PAIG OVERSEAS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 3000 Hillswood Drive Hillswood Business Park Chertsey Surrey KT16 0RS in data 08 ott 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 set 2012

    LRESSP

    Cessazione della carica di Maureen Hodgkinson come segretario in data 31 lug 2012

    1 pagineTM02

    Nomina di Ian Mcgillivray come amministratore in data 30 giu 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di William Gerard Devanney come amministratore in data 30 giu 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Alistair Duncan Stewart come amministratore in data 30 giu 2012

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 dic 2012 al 30 giu 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 giu 2012

    Stato del capitale al 26 giu 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Indirizzo della sede legale modificato da Watchmoor Point Watchmoor Road Camberley Surrey GU15 3EX in data 03 feb 2012

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Dividends paig acquisition LTD 18/01/2012
    RES13

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 20 gen 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Consolidamento delle azioni al 18 gen 2012

    5 pagineSH02

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Consolidation 18/01/2012
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Stuart David Mccaslin come amministratore in data 31 ago 2011

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    12 pagineAA

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    27 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di PAIG OVERSEAS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCGILLIVRAY, Ian
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg
    West Midlands
    Amministratore
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg
    West Midlands
    United KingdomBritishBank Official170383130001
    STEWART, Alistair Duncan
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg
    West Midlands
    Amministratore
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg
    West Midlands
    ScotlandBritishBank Official128116940001
    HODGKINSON, Maureen
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    Segretario
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    British161783480001
    PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    Segretario
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3929802
    154770020001
    SETON HOUSE INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
    Watchmoor Point
    Watchmor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Segretario
    Watchmoor Point
    Watchmor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    109290008
    BROGAN, Bernard Desmond
    Blakeley Lodge
    Egginton Road Etwall
    DE65 6NQ Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    Blakeley Lodge
    Egginton Road Etwall
    DE65 6NQ Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishChartered Engineer70252730001
    CANNON, Thomas Charles
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Secretary2756000001
    CARTER, Paul Dennis
    24 Allington Avenue
    WS13 6PF Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    24 Allington Avenue
    WS13 6PF Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Director123148720001
    DAWSON, Anthony David
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    Amministratore
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant89317200001
    DEVANNEY, William Gerard
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    Amministratore
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    United KingdomBritish,IrishFinance Director87628900001
    DUFFIELD, Stephen Leslie
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director24487000002
    ELLSMORE, Mark Anthony
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    Amministratore
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    BritishFinance Director58979090001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director45532880003
    JONES, Evan Taylor
    Ash Lea
    Barbon
    LA6 2LW Kirby Lonsdale
    Cumbria
    Amministratore
    Ash Lea
    Barbon
    LA6 2LW Kirby Lonsdale
    Cumbria
    BritishDirector40267750001
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director141893610001
    MADELEY, Sydney John, Dr
    46b Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    46b Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    UkBritishChartered Engineer51063290002
    MARTON, Richard Egerton Christopher
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    BritishDirector34653220001
    MCCASLIN, Stuart David, Mr
    Victoria House 27 Victoria Road
    B50 4AS Bidford On Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Victoria House 27 Victoria Road
    B50 4AS Bidford On Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritishChartered Secretary1824650002
    MCCOMASKY, James Anthony
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishChartered Accountant148271070001
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Amministratore
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritishChartered Accountant123487130001
    RODGERS, Neil Anthony
    Latchmere Green
    Little London
    RG26 5EJ Tadley
    Abbots Dwell
    Hampshire
    Uk
    Amministratore
    Latchmere Green
    Little London
    RG26 5EJ Tadley
    Abbots Dwell
    Hampshire
    Uk
    EnglandBritishGroup Finance Director136538310002
    SELWAY, Mark Wayne
    Flat 5-4
    5 South Frederick Street
    G1 1JG Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    Flat 5-4
    5 South Frederick Street
    G1 1JG Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomAustralianDirector105098120001
    THORNE, Raymond
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountants2756010001
    TURNBULL, Peter
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant41591930001

    PAIG OVERSEAS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 31 ott 2008
    Consegnato il 07 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 07 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 22 dic 2005
    Consegnato il 06 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Legal mortgage all f/h and l/h property,first fixed charge all the subsidiary shares and investments,all other interests in any f/h or l/h property,the buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property,all proceeds of sale derived therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 06 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed between the company,seton house group limited (the "parent") and lehman commercial paper inc (the "security agent") supplemental to a debenture dated 4 july 2001
    Creato il 23 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money or liabilities due or to become due from any charging company (as defined) or any other obligor (as defined) to any secured party (as defined) under any finance document (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lehman Commercial Paper Inc.
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share pledge agreement
    Creato il 21 ago 2001
    Consegnato il 10 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities of the chargor and/or any obligor owing to the chargee (the security agent) incurred under or pursuant to the finance documents, in particular incurred under or pursuant to the provisions of clause 17.11 of the senior credit agreement and clause 15.11 of the mezzanine loan agreement
    Brevi particolari
    A first priority pledge over the pledged assets (as defined) for the payment and discharge of the secured obligations (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lehman Commercial Peper Inc.
    Transazioni
    • 10 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PAIG OVERSEAS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 mag 2013Data di scioglimento
    19 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0