PAIG OVERSEAS LIMITED
Panoramica
Nome della società | PAIG OVERSEAS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00549628 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PAIG OVERSEAS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova PAIG OVERSEAS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Kpmg One Snowhill Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham West Midlands |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PAIG OVERSEAS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
SETON HOUSE OVERSEAS LIMITED | 17 nov 2005 | 17 nov 2005 |
BRITAX OVERSEAS LIMITED | 01 giu 1997 | 01 giu 1997 |
B.S.G. OVERSEAS LIMITED | 11 lug 1994 | 11 lug 1994 |
BRISTOL STREET GROUP LIMITED | 21 mag 1955 | 21 mag 1955 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PAIG OVERSEAS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per PAIG OVERSEAS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 5 pagine | 4.71 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 3000 Hillswood Drive Hillswood Business Park Chertsey Surrey KT16 0RS in data 08 ott 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Maureen Hodgkinson come segretario in data 31 lug 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di Ian Mcgillivray come amministratore in data 30 giu 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di William Gerard Devanney come amministratore in data 30 giu 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Alistair Duncan Stewart come amministratore in data 30 giu 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 dic 2012 al 30 giu 2012 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Watchmoor Point Watchmoor Road Camberley Surrey GU15 3EX in data 03 feb 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 20 gen 2012
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
Consolidamento delle azioni al 18 gen 2012 | 5 pagine | SH02 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Stuart David Mccaslin come amministratore in data 31 ago 2011 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 12 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 27 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 14 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di PAIG OVERSEAS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGILLIVRAY, Ian | Amministratore | One Snowhill Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham Kpmg West Midlands | United Kingdom | British | Bank Official | 170383130001 | ||||||||
STEWART, Alistair Duncan | Amministratore | One Snowhill Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham Kpmg West Midlands | Scotland | British | Bank Official | 128116940001 | ||||||||
HODGKINSON, Maureen | Segretario | Hillswood Drive Hillswood Business Park KT16 0RS Chertsey 3000 Surrey | British | 161783480001 | ||||||||||
PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED | Segretario | Watchmoor Road GU15 3EX Camberley Watchmoor Point Surrey |
| 154770020001 | ||||||||||
SETON HOUSE INTERNATIONAL SERVICES LIMITED | Segretario | Watchmoor Point Watchmor Road GU15 3EX Camberley Surrey | 109290008 | |||||||||||
BROGAN, Bernard Desmond | Amministratore | Blakeley Lodge Egginton Road Etwall DE65 6NQ Derby Derbyshire | England | British | Chartered Engineer | 70252730001 | ||||||||
CANNON, Thomas Charles | Amministratore | 90 Knowle Wood Road Dorridge B93 8JP Solihull West Midlands | British | Chartered Secretary | 2756000001 | |||||||||
CARTER, Paul Dennis | Amministratore | 24 Allington Avenue WS13 6PF Lichfield Staffordshire | England | British | Company Director | 123148720001 | ||||||||
DAWSON, Anthony David | Amministratore | Flat 21 Hillbrow Richmond Hill TW10 6BH Richmond Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 89317200001 | ||||||||
DEVANNEY, William Gerard | Amministratore | Hillswood Drive Hillswood Business Park KT16 0RS Chertsey 3000 Surrey | United Kingdom | British,Irish | Finance Director | 87628900001 | ||||||||
DUFFIELD, Stephen Leslie | Amministratore | Jacknett Barn 1820 Warwick Road Knowle B93 0DX Solihull West Midlands | England | British | Company Director | 24487000002 | ||||||||
ELLSMORE, Mark Anthony | Amministratore | Moor Cottage Eversley Centre RG27 0NB Hook | British | Finance Director | 58979090001 | |||||||||
FINDLER, Jonathan Paul | Amministratore | Westwood House Heathfield Avenue SL5 0AL Ascot Berkshire | British | Company Director | 45532880003 | |||||||||
JONES, Evan Taylor | Amministratore | Ash Lea Barbon LA6 2LW Kirby Lonsdale Cumbria | British | Director | 40267750001 | |||||||||
KAYSER, Michael Arthur | Amministratore | 17 Hartsbourne Avenue WD23 1JP Bushey Heath Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 141893610001 | ||||||||
MADELEY, Sydney John, Dr | Amministratore | 46b Hampton Lane B91 2PZ Solihull West Midlands | Uk | British | Chartered Engineer | 51063290002 | ||||||||
MARTON, Richard Egerton Christopher | Amministratore | Capernwray 6 Kier Park SL5 7DS Ascot Berkshire | British | Director | 34653220001 | |||||||||
MCCASLIN, Stuart David, Mr | Amministratore | Victoria House 27 Victoria Road B50 4AS Bidford On Avon Warwickshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 1824650002 | ||||||||
MCCOMASKY, James Anthony | Amministratore | 123 Old Bath Road GL53 7DH Cheltenham Gloucestershire | England | British | Chartered Accountant | 148271070001 | ||||||||
ROBERTSON, Douglas Grant | Amministratore | Blackmore Grange Blackmore End WR8 0EE Hanley Swan Worcestershire | England | British | Chartered Accountant | 123487130001 | ||||||||
RODGERS, Neil Anthony | Amministratore | Latchmere Green Little London RG26 5EJ Tadley Abbots Dwell Hampshire Uk | England | British | Group Finance Director | 136538310002 | ||||||||
SELWAY, Mark Wayne | Amministratore | Flat 5-4 5 South Frederick Street G1 1JG Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | Australian | Director | 105098120001 | ||||||||
THORNE, Raymond | Amministratore | 60 Silhill Hall Road B91 1JS Solihull West Midlands | British | Chartered Accountants | 2756010001 | |||||||||
TURNBULL, Peter | Amministratore | Much Binding Marsh HP17 8SS Aylesbury Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 41591930001 |
PAIG OVERSEAS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 31 ott 2008 Consegnato il 07 nov 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 22 dic 2005 Consegnato il 06 gen 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Legal mortgage all f/h and l/h property,first fixed charge all the subsidiary shares and investments,all other interests in any f/h or l/h property,the buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property,all proceeds of sale derived therefrom. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security accession deed between the company,seton house group limited (the "parent") and lehman commercial paper inc (the "security agent") supplemental to a debenture dated 4 july 2001 | Creato il 23 ago 2001 Consegnato il 31 ago 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All money or liabilities due or to become due from any charging company (as defined) or any other obligor (as defined) to any secured party (as defined) under any finance document (as defined) on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Share pledge agreement | Creato il 21 ago 2001 Consegnato il 10 set 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and liabilities of the chargor and/or any obligor owing to the chargee (the security agent) incurred under or pursuant to the finance documents, in particular incurred under or pursuant to the provisions of clause 17.11 of the senior credit agreement and clause 15.11 of the mezzanine loan agreement | |
Brevi particolari A first priority pledge over the pledged assets (as defined) for the payment and discharge of the secured obligations (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
PAIG OVERSEAS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0