HGG (1999) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHGG (1999) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00551223
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HGG (1999) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HGG (1999) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Osprey House
    63 Station Road
    KT15 2AR Addlestone
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HGG (1999) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HOWDEN GODFREY GROUP LIMITED27 giu 195527 giu 1955

    Quali sono gli ultimi bilanci di HGG (1999) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per HGG (1999) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    8 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 apr 2013

    • Capitale: GBP 0.20
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Reducing the share premium account os 267,000 29/04/2013
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 22 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di John Beal Preston come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 22 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O C/O Mr. J.B. Stone Osprey House 63 Station Road Addlestone Surrey KT15 2AR

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Dettagli del direttore cambiati per John Beal Preston il 23 dic 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    11 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    auditors

    Risoluzione di esenzione dalla nomina degli auditor

    RES03
    capital

    Risoluzioni

    Apt chairman 23/12/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    auditors

    Risoluzione di esenzione dalla nomina degli auditor

    RES03

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    Chi sono gli amministratori di HGG (1999) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STONE, Jeffrey Brian
    Keepers
    Portesbery Road
    GU15 3TD Camberley
    Surrey
    Segretario
    Keepers
    Portesbery Road
    GU15 3TD Camberley
    Surrey
    British35733600002
    MCELLIGOTT, Thomas Gary
    Chepstow
    Portesbery Road
    GU15 3TF Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Chepstow
    Portesbery Road
    GU15 3TF Camberley
    Surrey
    EnglandBritish51922930003
    STONE, Jeffrey Brian
    Keepers
    Portesbery Road
    GU15 3TD Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Keepers
    Portesbery Road
    GU15 3TD Camberley
    Surrey
    EnglandBritish35733600002
    MACLACHLAN, Alan George
    Park Cottage 1 Church Street
    Limekilns
    KY11 3HT Dunfermline
    Fife
    Scotland
    Segretario
    Park Cottage 1 Church Street
    Limekilns
    KY11 3HT Dunfermline
    Fife
    Scotland
    British161950001
    BEAL PRESTON, John
    10 Peatmoor Close
    Church Road
    GU13 8LE Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    10 Peatmoor Close
    Church Road
    GU13 8LE Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish14184950001
    BROWN, James
    35 Dunglass Avenue
    G14 9EJ Glasgow
    Amministratore
    35 Dunglass Avenue
    G14 9EJ Glasgow
    British36378360001
    COOPER, Michael John
    24 Marrowells
    KT13 9RN Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    24 Marrowells
    KT13 9RN Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish67011240001
    DIBBLE, Thomas
    30 Pinewood Avenue
    Lenzie
    G66 4EQ Glasgow
    Lanarkshire
    Scotland
    Amministratore
    30 Pinewood Avenue
    Lenzie
    G66 4EQ Glasgow
    Lanarkshire
    Scotland
    British161970001
    LODGE, Geoffrey Malcolm
    The Manor House
    HP22 4HW Oving
    Aylesbury
    Amministratore
    The Manor House
    HP22 4HW Oving
    Aylesbury
    United KingdomBritish14184980004
    MACLACHLAN, Alan George
    Park Cottage 1 Church Street
    Limekilns
    KY11 3HT Dunfermline
    Fife
    Scotland
    Amministratore
    Park Cottage 1 Church Street
    Limekilns
    KY11 3HT Dunfermline
    Fife
    Scotland
    British161950001
    WATSON, Ronald Norman Stewart
    Dalarne
    Pier Road
    G84 8LJ Rhu
    Dunbartonshire
    Amministratore
    Dalarne
    Pier Road
    G84 8LJ Rhu
    Dunbartonshire
    British161980001

    HGG (1999) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture between the company (formerly known as howden godfrey group limited), the chargors (as defined) and barclays bank PLC (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the lenders
    Creato il 03 dic 1999
    Consegnato il 17 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) and the mezzanine finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Shares pledge between the company (formerly known as howden godfrey group limited) and barclays bank PLC for itself and as trustee for an on behalf of the lenders
    Creato il 03 dic 1999
    Consegnato il 17 dic 1999
    In corso
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) and the mezzanine finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Ten thousand fully paid ordinary shares of £1 each in the capital of james howden group limited and all other securities of every kind which may at any time be derived from the said shares whether by way of bonus rights exchange option. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental trust deed
    Creato il 10 mar 1976
    Consegnato il 22 mar 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For the supplemental purpose trust deed of securing an increase in the rates of interest payable on debenture stock of howden group LTD amounting to £1,980,674 outstanding and secured by a trust deed dated 9/3/66 and deeds supplemental thereto was registered pursuant to section 95 of the companies act 1948 on 22/3/76
    Brevi particolari
    Floating cahrge on the (see doc M103). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Prudential, Assurance Company
    Transazioni
    • 22 mar 1976Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 13 mag 1975
    Consegnato il 13 mag 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £500,000
    Brevi particolari
    Leasehold land and premises at feltham in the greater london borough of hounslow.
    Persone aventi diritto
    • Brandts LTD
    Transazioni
    • 13 mag 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 07 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 30 apr 1970
    Consegnato il 11 mag 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Trust deed of securing debenture stock of james hawden & godfrey LTD amounting to £2,250,000 inclusing of £1,600,000 secured by a trust deed dated 9TH march 66 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    By way of floating charge (see doc 80 for further details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Co LTD
    Transazioni
    • 11 mag 1970Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0