TED BATES HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TED BATES HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00553986 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TED BATES HOLDINGS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova TED BATES HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Sea Containers House 18 Upper Ground SE1 9GL London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TED BATES HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TED BATES LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
| HOBSON,BATES & PARTNERS LIMITED | 30 ago 1955 | 30 ago 1955 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TED BATES HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per TED BATES HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Cessazione della carica di Andrew Robertson Payne come amministratore in data 30 giu 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Daniel Patrick Conaghan come amministratore in data 30 giu 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Cessazione della carica di Steve Richard Winters come amministratore in data 06 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Andrew Robertson Payne come amministratore in data 21 nov 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Daniel Patrick Conaghan come amministratore in data 21 nov 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 9 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 27 Farm Street London W1J 5RJ a Sea Containers House 18 Upper Ground London SE1 9GL in data 22 nov 2018 | 1 pagine | AD01 | ||
Cessazione della carica di Andrew Grant Balfour Scott come amministratore in data 12 nov 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 8 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 4 pagine | AA | ||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Nomina di Mr Steve Winters come amministratore in data 06 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Christopher Paul Sweetland come amministratore in data 01 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 2 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di TED BATES HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED | Segretario | 27 Farm Street W1J 5RJ London |
| 80143770001 | ||||||||||
| VAN DER WELLE, Charles Ward | Amministratore | 18 Upper Ground SE1 9GL London Sea Containers House United Kingdom | England | British | 183827730001 | |||||||||
| CALOW, David Ferguson | Segretario | 27 Farm Street W1J 5RJ London | British | 91285750001 | ||||||||||
| EVANS, Fiona Maria | Segretario | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||||||
| HOWELL, Peter Graham | Segretario | 76 Kings Road SW19 8QW London | British | 62634010001 | ||||||||||
| JANS, Annamaria | Segretario | 20 Underhill Road East Dulwich SE22 0AH London | British | 1085040008 | ||||||||||
| WILLIAMS, Denise | Segretario | Marie Cottage Holmbury Lane RH5 6ND Holmbury St Mary Surrey | British | 24311940004 | ||||||||||
| BINDING, David Wyn | Amministratore | 48 Midhurst Avenue Muswell Hill N10 3EN London | British | 5994480001 | ||||||||||
| BOLAND, Andrew Kenneth | Amministratore | 25 Chessfield Park Little Chalfont HP6 6RU Amersham Buckinghamshire | British | 71264540005 | ||||||||||
| BUNGEY, Michael | Amministratore | 31 Camp Road SW19 4UW London | British | 91056570001 | ||||||||||
| BUSS, Jeremy David | Amministratore | 34 Goddington Road SL8 5TZ Bourne End Buckinghamshire | United Kingdom | British | 26720550002 | |||||||||
| CHAPMAN, Aidan Gerard | Amministratore | 74 Marshalswick Lane AL1 4XE St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 51799970001 | |||||||||
| CONAGHAN, Daniel Patrick | Amministratore | 18 Upper Ground SE1 9GL London Sea Containers House United Kingdom | England | British | 260161530001 | |||||||||
| DELANEY, Paul | Amministratore | 27 Farm Street W1J 5RJ London | United Kingdom | British | 69254240002 | |||||||||
| HAM, David Fenton | Amministratore | 25 Chestnut Avenue TN4 0BT Tunbridge Wells Kent | England | British | 103819950001 | |||||||||
| HOWARD, Stuart Michael | Amministratore | 2 Enbrook Park CT20 3SE Folkestone Kent | United Kingdom | British | 160271430001 | |||||||||
| HOWELL, Peter Graham | Amministratore | 76 Kings Road SW19 8QW London | Uk | British | 62634010001 | |||||||||
| JANS, Annamaria | Amministratore | 20 Underhill Road East Dulwich SE22 0AH London | British | 1085040008 | ||||||||||
| PAYNE, Andrew Robertson | Amministratore | 18 Upper Ground SE1 9GL London Sea Containers House United Kingdom | England | British | 202208380001 | |||||||||
| RICHARDSON, Paul Winston George | Amministratore | 125 Park Avenue New York Ny 10017-5529 Usa | British | 45700660003 | ||||||||||
| SCOTT, Andrew Grant Balfour | Amministratore | 27 Farm Street W1J 5RJ London | United Kingdom | British | 67078370001 | |||||||||
| SWEETLAND, Christopher Paul | Amministratore | 27 Farm Street W1J 5RJ London | England | British | 56529540005 | |||||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Amministratore | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Denise | Amministratore | Marie Cottage Holmbury Lane RH5 6ND Holmbury St Mary Surrey | British | 24311940004 | ||||||||||
| WILSON, Stephen Michael | Amministratore | 9 Boulters Lock Giffard Park MK14 5QR Milton Keynes | British | 81144620001 | ||||||||||
| WINTERS, Steve Richard | Amministratore | 18 Upper Ground SE1 9GL London Sea Containers House United Kingdom | England | British | 210160610001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TED BATES HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordiant Communications Group Limited | 06 apr 2016 | Farm Street W1J 5RJ London 27 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
TED BATES HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Creato il 19 apr 2002 Consegnato il 26 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 04 apr 2002 Consegnato il 12 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 15 dic 1997 Consegnato il 24 dic 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the agreement dated 30TH september 1997 (as defined) and/or the security documents (as defined) when the same become due for payment or discharge | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage the property (if any); by way of first fixed charge all present and future f/h and l/h property wheresoever situate; all plant machinery and other equipment; all book and other debts; the goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0