TED BATES HOLDINGS LIMITED

TED BATES HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTED BATES HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00553986
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TED BATES HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TED BATES HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sea Containers House
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TED BATES HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TED BATES LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    HOBSON,BATES & PARTNERS LIMITED 30 ago 195530 ago 1955

    Quali sono gli ultimi bilanci di TED BATES HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per TED BATES HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione della carica di Andrew Robertson Payne come amministratore in data 30 giu 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Daniel Patrick Conaghan come amministratore in data 30 giu 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Steve Richard Winters come amministratore in data 06 dic 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew Robertson Payne come amministratore in data 21 nov 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Daniel Patrick Conaghan come amministratore in data 21 nov 2019

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 27 Farm Street London W1J 5RJ a Sea Containers House 18 Upper Ground London SE1 9GL in data 22 nov 2018

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Andrew Grant Balfour Scott come amministratore in data 12 nov 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    4 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Nomina di Mr Steve Winters come amministratore in data 06 lug 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christopher Paul Sweetland come amministratore in data 01 lug 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    2 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TED BATES HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Segretario
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2757919
    80143770001
    VAN DER WELLE, Charles Ward
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    United Kingdom
    Amministratore
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    United Kingdom
    EnglandBritish183827730001
    CALOW, David Ferguson
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Segretario
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    British91285750001
    EVANS, Fiona Maria
    85 Ravensmede Way
    Chiswick
    W4 1TQ London
    Segretario
    85 Ravensmede Way
    Chiswick
    W4 1TQ London
    British49259690002
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Segretario
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    British62634010001
    JANS, Annamaria
    20 Underhill Road
    East Dulwich
    SE22 0AH London
    Segretario
    20 Underhill Road
    East Dulwich
    SE22 0AH London
    British1085040008
    WILLIAMS, Denise
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    Segretario
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    British24311940004
    BINDING, David Wyn
    48 Midhurst Avenue
    Muswell Hill
    N10 3EN London
    Amministratore
    48 Midhurst Avenue
    Muswell Hill
    N10 3EN London
    British5994480001
    BOLAND, Andrew Kenneth
    25 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    25 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British71264540005
    BUNGEY, Michael
    31 Camp Road
    SW19 4UW London
    Amministratore
    31 Camp Road
    SW19 4UW London
    British91056570001
    BUSS, Jeremy David
    34 Goddington Road
    SL8 5TZ Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    34 Goddington Road
    SL8 5TZ Bourne End
    Buckinghamshire
    United Kingdom British 26720550002
    CHAPMAN, Aidan Gerard
    74 Marshalswick Lane
    AL1 4XE St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    74 Marshalswick Lane
    AL1 4XE St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish51799970001
    CONAGHAN, Daniel Patrick
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    United Kingdom
    Amministratore
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    United Kingdom
    EnglandBritish260161530001
    DELANEY, Paul
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Amministratore
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    United KingdomBritish69254240002
    HAM, David Fenton
    25 Chestnut Avenue
    TN4 0BT Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    25 Chestnut Avenue
    TN4 0BT Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish103819950001
    HOWARD, Stuart Michael
    2 Enbrook Park
    CT20 3SE Folkestone
    Kent
    Amministratore
    2 Enbrook Park
    CT20 3SE Folkestone
    Kent
    United KingdomBritish160271430001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Amministratore
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    UkBritish62634010001
    JANS, Annamaria
    20 Underhill Road
    East Dulwich
    SE22 0AH London
    Amministratore
    20 Underhill Road
    East Dulwich
    SE22 0AH London
    British1085040008
    PAYNE, Andrew Robertson
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    United Kingdom
    Amministratore
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    United Kingdom
    EnglandBritish202208380001
    RICHARDSON, Paul Winston George
    125 Park Avenue
    New York
    Ny 10017-5529
    Usa
    Amministratore
    125 Park Avenue
    New York
    Ny 10017-5529
    Usa
    British45700660003
    SCOTT, Andrew Grant Balfour
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Amministratore
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    United KingdomBritish67078370001
    SWEETLAND, Christopher Paul
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Amministratore
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    EnglandBritish56529540005
    WEATHERSEED, David Ian Cameron
    The Larches
    22 Claremont Road
    KT10 0PL Claygate
    Surrey
    Amministratore
    The Larches
    22 Claremont Road
    KT10 0PL Claygate
    Surrey
    British37857730001
    WILLIAMS, Denise
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    Amministratore
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    British24311940004
    WILSON, Stephen Michael
    9 Boulters Lock
    Giffard Park
    MK14 5QR Milton Keynes
    Amministratore
    9 Boulters Lock
    Giffard Park
    MK14 5QR Milton Keynes
    British81144620001
    WINTERS, Steve Richard
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    United Kingdom
    Amministratore
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    United Kingdom
    EnglandBritish210160610001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TED BATES HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Farm Street
    W1J 5RJ London
    27
    England
    06 apr 2016
    Farm Street
    W1J 5RJ London
    27
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 1948 To 1989
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01320869
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TED BATES HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 19 apr 2002
    Consegnato il 26 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC (And Its Successors in Title) for and on Behalf of Itself Thenoteholders and the Banks and Financial Institutions from Time to Time Parties to the Finance Documents
    Transazioni
    • 26 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 04 apr 2002
    Consegnato il 12 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC for and on Behalf of Itself and the Banks Andfinancial Institutions from Time to Time Parties to the Bridge Facility Agreement
    Transazioni
    • 12 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 dic 1997
    Consegnato il 24 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the agreement dated 30TH september 1997 (as defined) and/or the security documents (as defined) when the same become due for payment or discharge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the property (if any); by way of first fixed charge all present and future f/h and l/h property wheresoever situate; all plant machinery and other equipment; all book and other debts; the goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0