MALTON MOTORS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MALTON MOTORS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00554231 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MALTON MOTORS LIMITED?
- Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- Manutenzione e riparazione di autoveicoli (45200) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- Commercio all'ingrosso di parti e accessori per autoveicoli (45310) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova MALTON MOTORS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | First Floor, Unit 3140 Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di MALTON MOTORS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per MALTON MOTORS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Thomas Andrew Dale come amministratore in data 29 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 5 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Elizabeth Louise Hancox come amministratore in data 20 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Thomas Andrew Dale come amministratore in data 04 lug 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Anton Clive Jeary come amministratore in data 04 lug 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Dr Elizabeth Louise Hancox come amministratore in data 01 nov 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Claire Louise Catlin come amministratore in data 21 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Claire Louise Catlin il 01 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di European Motor Holdings Limited come persona con controllo significativo il 01 apr 2018 | 5 pagine | PSC05 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Inchcape Uk Corporate Management Limited il 01 apr 2018 | 3 pagine | CH04 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Inchcape House Langford Lane Kidlington Oxford OX5 1HT a First Floor, Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7YN in data 06 apr 2018 | 2 pagine | AD01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||
Nomina di Mrs Claire Louise Catlin come amministratore in data 23 set 2016 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di MALTON MOTORS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHCAPE UK CORPORATE MANAGEMENT LIMITED | Segretario | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham United Kingdom |
| 100307260072 | ||||||||||
| WHEATLEY, Martin Peter | Amministratore | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | England | British | 55180460002 | |||||||||
| BEACHAM, Mark Derrick | Segretario | Austwick Lane Emerson Valley MK4 2DR Milton Keynes 11 Buckinghamshire United Kingdom | British | 135313320001 | ||||||||||
| CATLIN, Claire Louise | Amministratore | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | England | British | 270101940001 | |||||||||
| CAYGILL, Christopher Charles | Amministratore | 8 Westpark Drive Westlands Faverdale DL3 0TB Darlington County Durham | British | 56689810001 | ||||||||||
| DALE, Thomas Andrew | Amministratore | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | United Kingdom | British | 260286850001 | |||||||||
| HANCOX, Elizabeth Louise, Dr | Amministratore | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | United Kingdom | British | 210216760001 | |||||||||
| JEARY, Anton Clive | Amministratore | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | England | British | 169892630001 | |||||||||
| KAYE, Keith Melvin | Amministratore | Gold House 58 Easton Road YO16 4DB Bridlington East Yorkshire | England | British | 162406960001 | |||||||||
| LOCK, Spencer | Amministratore | The Dower House Itchen Abbas SO21 1BQ Winchester Hampshire | England | British | 92493930001 | |||||||||
| MCCLUSKEY, Ross | Amministratore | Langford Lane Kidlington OX5 1HT Oxford Inchcape House | United Kingdom | British | 165677350002 | |||||||||
| MCCORMACK, Connor | Amministratore | New College House Alchester Road OX26 1UN Chesterton Oxfordshire | United Kingdom | British | 108832810002 | |||||||||
| PALMER, Richard Terence | Amministratore | Littlethorpe Cleeve Road RG8 9BJ Goring | England | British | 16571890002 | |||||||||
| RONCHETTI, Marc Arthur | Amministratore | New Road Croxley Green WD3 3EP Rickmansworth 22 Hertfordshire | England | British | 123180830001 | |||||||||
| WILSON, Ann Chrisette | Amministratore | The Kingswood Ridgemount Road SL5 9RW Sunningdale Berkshire | England | British | 14811650002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MALTON MOTORS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Motor Holdings Limited | 06 apr 2016 | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor, Unit 3140, Park Square United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MALTON MOTORS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 15 dic 2003 Consegnato il 16 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from european motor holdings PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All that f/h property being land lying to the north of preston lane preston farm industrial estate stockton-on-tees t/n CE101585. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 26 gen 1993 Consegnato il 28 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the companys present and future stock of new and used motore vehicles and all the companys right title and interest therein and all moneys due and all goods given in exchange for the motor vehicles. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 nov 1991 Consegnato il 18 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 28/10/91 | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 27 mag 1988 Consegnato il 02 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 10 feb 1988 Consegnato il 19 feb 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Brevi particolari All those monies which may from time to time owing to malton motors limited by bmw (GB) limited in respect of refunds of monies paid by or by direction of malton motors limited to bmw (GB) limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis the debenture provides that malton motors limited shall not without the prior written consent of bmw finance (GB) limited create or permit to come into being any mortgage charge or assignment in respect of the monies assigned by the debenture. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0