COINMECHS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOINMECHS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00556643
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COINMECHS LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova COINMECHS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kingsway Buildings
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Mid Glamorgan
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COINMECHS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per COINMECHS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 22 nov 2011

    • Capitale: GBP 8.02479
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Philip Jones il 01 feb 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Graham Clarke il 01 feb 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    13 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    6 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    16 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine403a

    Chi sono gli amministratori di COINMECHS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, Philip
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Kingsway Buildings
    Mid Glamorgan
    Segretario
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Kingsway Buildings
    Mid Glamorgan
    BritishAccountant121167180001
    CLARKE, Graham
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Kingsway Buildings
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Kingsway Buildings
    Mid Glamorgan
    EnglandBritishDirector109781090001
    BROOKMAN, Denise Yvonne
    6 St Margarets Close
    TQ1 4NR Torquay
    Devon
    Segretario
    6 St Margarets Close
    TQ1 4NR Torquay
    Devon
    British21953080001
    CLARKE, Graham
    Walnut House
    Manor House Lane, Higher Heath
    SY13 2HL Whitchurch
    Shropshire
    Segretario
    Walnut House
    Manor House Lane, Higher Heath
    SY13 2HL Whitchurch
    Shropshire
    BritishDirector109781090001
    DODD, Gruffydd
    30 Landmark Place
    CF10 2HT Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario
    30 Landmark Place
    CF10 2HT Cardiff
    South Glamorgan
    BritishCompany Secretary122932920001
    JONES, William Brian
    Corner View
    4 Swn Yr Afon
    CF42 6NX Treorchy
    Rhondda Cynon Taff
    Segretario
    Corner View
    4 Swn Yr Afon
    CF42 6NX Treorchy
    Rhondda Cynon Taff
    BritishDirector56013520002
    VOOGHT, Susanne
    Avoca Summerfield Road
    Shiphay
    TQ2 7DL Torquay
    Devon
    Segretario
    Avoca Summerfield Road
    Shiphay
    TQ2 7DL Torquay
    Devon
    British55279460002
    BROOKMAN, Denise Yvonne
    6 St Margarets Close
    TQ1 4NR Torquay
    Devon
    Amministratore
    6 St Margarets Close
    TQ1 4NR Torquay
    Devon
    BritishAdministration Director21953080001
    CLARKE, Garry George
    29 Lower Drive
    Besford
    WR8 9AH Worcester
    Amministratore
    29 Lower Drive
    Besford
    WR8 9AH Worcester
    EnglandBritishAccountant105348160001
    DODD, Gruffydd
    30 Landmark Place
    CF10 2HT Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    30 Landmark Place
    CF10 2HT Cardiff
    South Glamorgan
    BritishDirector122932920001
    EDWARDS, Randall James
    Springfield
    Broughton
    CF71 7QR Cowbridge
    South Glamorgan
    Amministratore
    Springfield
    Broughton
    CF71 7QR Cowbridge
    South Glamorgan
    WalesBritishDirector122932750001
    FRASER-WILLIAMS, Eileen
    Fir Trees
    Clayhead Road
    Baldrine
    Lonan
    Isle Of Man
    Amministratore
    Fir Trees
    Clayhead Road
    Baldrine
    Lonan
    Isle Of Man
    BritishDirector21953090002
    HENDERSON, Michael Rylan
    St Annes Lodge St Annes Court
    Talygarn
    CF72 9HH Pontyclun
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    St Annes Lodge St Annes Court
    Talygarn
    CF72 9HH Pontyclun
    Mid Glamorgan
    WalesBritishDirector56013550002
    JONES, Bernard William Richard
    Green Acres
    Laleston
    CF32 0HN Bridgend
    Amministratore
    Green Acres
    Laleston
    CF32 0HN Bridgend
    WalesBritishDirector64815520001
    LANYON, Mark Evan
    56 Coed Mieri
    Tyla Garw
    CF72 9UW Pontyclun
    Amministratore
    56 Coed Mieri
    Tyla Garw
    CF72 9UW Pontyclun
    BritishDirector56012990001
    LYONS, Alastair David
    Hencliffe Cottage Farm
    Winksley
    HG4 3PQ Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Hencliffe Cottage Farm
    Winksley
    HG4 3PQ Ripon
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director75697200002
    THOMPSON, Paul Adrian
    5 Lon Y Fro
    Pentyrch
    CF15 9TE Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    5 Lon Y Fro
    Pentyrch
    CF15 9TE Cardiff
    South Glamorgan
    BritishDirector59700930002
    VOOGHT, Susanne
    Avoca Summerfield Road
    Shiphay
    TQ2 7DL Torquay
    Devon
    Amministratore
    Avoca Summerfield Road
    Shiphay
    TQ2 7DL Torquay
    Devon
    United KingdomBritishDirector55279460002
    WILLIAMS, George
    Fir Trees
    Clayhead Road
    ISLE MAN Baldrine
    Lonan
    Amministratore
    Fir Trees
    Clayhead Road
    ISLE MAN Baldrine
    Lonan
    BritishDirector21953100001
    WILMOT, Gillian Caroline
    The Lodge 2 Church Lane
    Lockington
    DE74 2TF Derby
    Leicestershire
    Amministratore
    The Lodge 2 Church Lane
    Lockington
    DE74 2TF Derby
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector52569670002
    COJEAN LIMITED
    Burleigh Manor
    Peel Road
    Douglas
    Isle Of Man
    Amministratore
    Burleigh Manor
    Peel Road
    Douglas
    Isle Of Man
    32586640001
    FILBUK NOMINEES LIMITED
    Eversheds
    Fitzalan House, Fitzalan Road
    CF24 0EE Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Eversheds
    Fitzalan House, Fitzalan Road
    CF24 0EE Cardiff
    South Glamorgan
    70441730001

    COINMECHS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 lug 2004
    Consegnato il 11 ago 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to any security beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    2 pavor road, torquay TQ1 8BU t/n DN834, intellectual property: (1) trade mark number 1260379, coinmechs, registered, 9, coinmechs limited, (2) trade mark number 2042765, leisuretronic, registered, 9, coinmechs limited;. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 11 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 30 lug 2004
    Consegnato il 04 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Noteholders
    Transazioni
    • 04 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 nov 1993
    Consegnato il 24 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 24 mar 1987
    Consegnato il 01 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 pavor road, torquay, devon. Title no dn 834 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 29 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 20 gen 1984
    Consegnato il 26 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts & other debts floating charge over undertaking and all property and assets and present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 11 gen 1978
    Consegnato il 16 gen 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & premises being:- land at the junction of fore. Street, and pavor road, torquay, devon title no dn 834 together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 gen 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 15 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0