CAPARO BURTON LIMITED
Panoramica
Nome della società | CAPARO BURTON LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00558933 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CAPARO BURTON LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CAPARO BURTON LIMITED?
Indirizzo della sede legale | c/o AMY CHISMON 7 More London Riverside SE1 2RT London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CAPARO BURTON LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
STEEL STOCK (BURTON ON TRENT) LIMITED | 24 set 1990 | 24 set 1990 |
AIREX LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
AIRBORNE INDUSTRIES LIMITED | 20 dic 1955 | 20 dic 1955 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CAPARO BURTON LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per CAPARO BURTON LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Patrick Dancaster come amministratore in data 11 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Caparo House 103 Baker Street London W1U 6LN a C/O Amy Chismon 7 More London Riverside London SE1 2RT in data 15 nov 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Claire Smith come amministratore in data 03 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Claire Smith come amministratore in data 17 feb 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Georgina Mason come amministratore in data 16 feb 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Hyland come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Miss Georgina Mason come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Stilwell come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Stilwell come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una societ à dormiente redatto al 31 dic 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CAPARO BURTON LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAILEY, Stephen Geoffrey | Segretario | Abbey Gardens ST18 0RY Great Haywood 1 Staffordshire | British | Accountant | 108203800001 | |||||
CHEUNG, Wing Yee | Segretario | 78 Park Hill Road Harborne B17 9HJ Birmingham | British | Financial Controller | 59538730002 | |||||
PEGLER, Ruth | Segretario | 12 Barker Road B74 2NY Sutton Coldfield West Midlands | British | Accountant | 42051530002 | |||||
PRICE, Sharon Ann | Segretario | 80 Grafton Road Oldbury B68 8BJ Warley West Midlands | British | Group Financial Controller | 77855650002 | |||||
RAWLINGS, Kevin Hedley | Segretario | 75 Harrington Croft B71 3RJ West Bromwich West Midlands | British | Group Corporate Services Manag | 84159580002 | |||||
STILWELL, Michael James | Segretario | Caparo House 103 Baker Street W1U 6LN London | 150778980001 | |||||||
WARD, Elizabeth Katherine | Segretario | Thistledown House Cheltenham Road WR11 6LF Evesham Worcestershire | British | 18385840002 | ||||||
BACHE, Mark John Thomas | Amministratore | 47 Chesterwood Road Kings Heath B13 0QG Birmingham West Midlands | British | Accountant | 42051490001 | |||||
BAILEY, Stephen Geoffrey | Amministratore | Abbey Gardens ST18 0RY Great Haywood 1 Staffordshire | England | British | Accountant | 108203800001 | ||||
CHEUNG, Wing Yee | Amministratore | 78 Park Hill Road Harborne B17 9HJ Birmingham | British | Financial Controller | 59538730002 | |||||
DANCASTER, David Patrick | Amministratore | Kenilworth Avenue SW19 7LN London 1 | England | British | Finance Director | 55380530001 | ||||
HYLAND, Matthew William Edward | Amministratore | Popes Lane B69 4PJ Oldbury Caparo House West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | None | 152453950001 | ||||
MASON, Georgina | Amministratore | Caparo House 103 Baker Street W1U 6LN London | England | British | Group Tax And Financial Controller | 173302440001 | ||||
PEGLER, Ruth | Amministratore | 12 Barker Road B74 2NY Sutton Coldfield West Midlands | British | Accountant | 42051530002 | |||||
PRICE, Sharon Ann | Amministratore | 80 Grafton Road Oldbury B68 8BJ Warley West Midlands | British | Group Financial Controller | 77855650002 | |||||
RAWLINGS, Kevin Hedley | Amministratore | 75 Harrington Croft B71 3RJ West Bromwich West Midlands | United Kingdom | British | Group Corporate Services Manag | 84159580002 | ||||
SMITH, Claire | Amministratore | Caparo House 103 Baker Street W1U 6LN London | England | British | Director Of Finace Operations | 195772990001 | ||||
SMITH, John Godfrey | Amministratore | Chequerfield House 32 Showell Lane Lower Penn WV4 4TT Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | Finance Director | 56051330001 | ||||
STEELE, Colin Grant | Amministratore | Hindrum Cokes Lane HP8 4UD Chalfont St Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | Accountant | 10618480001 | ||||
STILWELL, Michael James | Amministratore | Caparo House 103 Baker Street W1U 6LN London | United Kingdom | British | Accountant | 142098630001 | ||||
WARD, Elizabeth Katherine | Amministratore | Thistledown House Cheltenham Road WR11 6LF Evesham Worcestershire | British | Chartered Accountant | 18385840002 |
CAPARO BURTON LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Further guarantee & debenture | Creato il 13 feb 1978 Consegnato il 21 feb 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Further guarantee and debenture | Creato il 21 set 1977 Consegnato il 27 set 1977 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein. To the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All that property undertaking and assets xharged by the principal deed and further deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture supplemental to deed 03/06/75 | Creato il 23 lug 1976 Consegnato il 10 ago 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company &/or any of the existing companies &/or nelson planning LTD. To the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 03 giu 1975 Consegnato il 10 giu 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the five other companies named in doc 53. to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari By way of fixed and floating charge. Undertaking and all property and goodwill assets present and future including uncalled capital (see doc 53). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 26 set 1974 Consegnato il 02 ott 1974 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of fixed and floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including & goodwill uncalled capital. Together with all fixtures etc. (see doc 50). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0