FRASERFORT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFRASERFORT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00562745
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FRASERFORT LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova FRASERFORT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St. James House 3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    Essex
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FRASERFORT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per FRASERFORT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2022

    18 pagineAA

    Stato del capitale al 28 set 2023

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Modifica dei dettagli di Dtp Finance Number 1 Limited come persona con controllo significativo il 07 ago 2023

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Valor Hospitality Europe Ltd St. James House, 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road Romford Essex RM1 3NH United Kingdom a St. James House 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road Romford Essex RM1 3NH in data 07 ago 2023

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Warunya Punawakul il 24 mar 2023

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Wanida Suksuwan il 24 mar 2023

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Hansa Susayan il 24 mar 2023

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Dtp Finance Number 1 Limited come persona con controllo significativo il 24 mar 2023

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Queens Court 9-17 Eastern Road Romford Essex RM1 3NG a Valor Hospitality Europe Ltd St. James House, 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road Romford Essex RM1 3NH in data 24 mar 2023

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 005627450027 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Wanida Suksuwan come amministratore in data 10 dic 2019

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di FRASERFORT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PUNAWAKUL, Warunya
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    ThailandThai265448120001
    SUKSUWAN, Wanida
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    ThailandThai265450970001
    SUSAYAN, Hansa
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    ThailandThai265450980001
    BURGESS, Keith John
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    Segretario
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    British7009790002
    CHRISTIAN, Tracy Joanne
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    Segretario
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    British102667300001
    COUGHLAN, Sally Ann
    38 Barley Mead
    CM3 4RP Danbury
    Essex
    Segretario
    38 Barley Mead
    CM3 4RP Danbury
    Essex
    British107832420001
    JONES, Vanessa
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    Segretario
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    British72146200001
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    Segretario
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    British7901050001
    WALLER, Ronald John
    Brindles 118 Hanging Hill Lane
    CM13 2HN Brentwood
    Essex
    Segretario
    Brindles 118 Hanging Hill Lane
    CM13 2HN Brentwood
    Essex
    British1210620001
    WATERS, Jonathan Roy
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    Segretario
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    British129848360001
    ALLSOP, Heather Louise
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    Amministratore
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    British101912850001
    ARZI, David
    38th Floor
    NY 10036 New York
    One Bryant Park
    Usa
    Amministratore
    38th Floor
    NY 10036 New York
    One Bryant Park
    Usa
    United StatesAmerican190079640001
    BAIRSTOW, John
    Frieze Cottage Coxtie Green Road
    South Weald
    CM14 5RE Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Frieze Cottage Coxtie Green Road
    South Weald
    CM14 5RE Brentwood
    Essex
    British537400001
    BELL, Gerald James
    Cavewood Rectory Lane
    Datchworth
    SG3 6RD Knebworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cavewood Rectory Lane
    Datchworth
    SG3 6RD Knebworth
    Hertfordshire
    British47018930002
    BOULD, Andrew Robin Douglas
    508 Uxbridge Road
    HA5 4SG Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    508 Uxbridge Road
    HA5 4SG Pinner
    Middlesex
    British36875610001
    BRAIDLEY, Jonathan Patrick
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    Mcap Global Finance (Uk) Llp
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    Mcap Global Finance (Uk) Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritish190075510001
    CAIRNS, Michael Anthony
    Birchlands
    Old Avenue
    KT13 0PY Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Birchlands
    Old Avenue
    KT13 0PY Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish36488470001
    COLES, Alan Clifford
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    EnglandBritish101144900002
    COLLYER, Brian Charles
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    Amministratore
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    Canadian101144260001
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    Amministratore
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    EnglandBritish14330100002
    GOIN, Russell Todd
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    Amministratore
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    American108675490001
    HERSEY, David Michael
    Greenways
    Ridgeway Hutton Mount
    CM13 2LS Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Greenways
    Ridgeway Hutton Mount
    CM13 2LS Brentwood
    Essex
    British17567250001
    KABALAN, Fadi
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    Amministratore
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    EnglandBritish133846470001
    KRAIS, Ashley Simon
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    Amministratore
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    United KingdomBritish105921220001
    KULA, Christopher Andre
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    Mcap Global Finance (Uk) Llp
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    Mcap Global Finance (Uk) Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritish,Canadian,German219684180001
    LE POIDEVIN, Andrew Daryl
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish4958800007
    MAIDEN, George Barry
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British8832120001
    MARCUS, Martin Alan
    17 Monkhams Drive
    IG8 0LG Woodford Green
    Essex
    Amministratore
    17 Monkhams Drive
    IG8 0LG Woodford Green
    Essex
    British35543430001
    MENARD, Veronique Pascale Dominique
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    Amministratore
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    United KingdomFrench141156250001
    METCALFE, Michael Stuart
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish40294180002
    MOORE, Richard John
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    Amministratore
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    EnglandBritish101144680001
    MULAHASANI, Heather Louise
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    Amministratore
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    EnglandBritish136994090001
    OGDEN, Kathryn
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    Amministratore
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    American114248790002
    PORTER, Allan William
    147 Worrin Road
    CM15 8JR Shenfield
    Essex
    Amministratore
    147 Worrin Road
    CM15 8JR Shenfield
    Essex
    British17567090001
    QUINN, Martin Joseph
    34 Francis Grove
    Wimbledon
    SW19 4DT London
    Westmont Management Limited
    England
    Amministratore
    34 Francis Grove
    Wimbledon
    SW19 4DT London
    Westmont Management Limited
    England
    EnglandIrish186571310001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FRASERFORT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    06 apr 2016
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5335775
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per FRASERFORT LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    09 giu 201725 gen 2018La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    FRASERFORT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 28 nov 2017
    Consegnato il 28 nov 2017
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 28 nov 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 nov 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 23 lug 2015
    Consegnato il 05 ago 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    F/H land and buildings k/a the stable block, mill lane, sindlesham t/no BK245962.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Agent
    Transazioni
    • 05 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 22 feb 2011
    Consegnato il 02 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (For details of properties charged please refer to form MG01) fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 02 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 23 feb 2005
    Consegnato il 11 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from an obligor or by some other person of each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a the inn on the avenue (now known as cardiff moat house) eastern avenue cardiff south glamorgan t/n WA164477.
    Persone aventi diritto
    • G S Mortgage Funding No.1 Limited (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 11 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 feb 2005
    Consegnato il 11 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by an obligor or by some other person of each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gs Mortgage Funding No.1 Limited (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 11 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 01 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 23 feb 2005
    Consegnato il 04 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Cardiff moat house, circle way east, llanedeyrn, cardiff, south glamorgan. L/h property being the inn on the avenue (now k/a cardiff moat house), eastern avenue, cardiff, south glamorgan t/no. WA164477.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transazioni
    • 04 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A composite guarantee and debenture
    Creato il 23 feb 2005
    Consegnato il 04 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transazioni
    • 04 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 24 nov 2004
    Consegnato il 14 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transazioni
    • 14 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 giu 2004
    Consegnato il 25 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Coproration PLC
    Transazioni
    • 25 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed to the composite guarantee and debenture
    Creato il 08 giu 2004
    Consegnato il 11 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders Defined in Theterm Facility Agreement)
    Transazioni
    • 11 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 25 mar 2004
    Consegnato il 26 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders)
    Transazioni
    • 26 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 mar 1993
    Consegnato il 01 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or queen's moat houses PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The inn on the avenue,eastern avenue,cardiff,south glamorgan.t/no.wa 164477.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 dic 1986
    Consegnato il 16 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of a legal mortgage the leicestershire moat house hotel, wigston road, oadby, leicestershire and/or the proceeds of sale thereof together with.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 10 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 21 giu 1982
    Consegnato il 16 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due under the terms of a personal bond of even date.
    Brevi particolari
    Forth bridges lodge hotel, south queensferry west lothian.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 19 apr 1982
    Consegnato il 27 apr 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H europa lodge, north stafford, grays, essex, T.n: ex 236833.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 19 apr 1982
    Consegnato il 27 apr 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H europa lodge, watling street, gravesend.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 mag 1981
    Consegnato il 08 mag 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    7 colburn road, broadstairs, kent K394393. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 apr 1981
    Consegnato il 24 apr 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital. Together with all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 apr 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 16 set 1980
    Consegnato il 18 set 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Waltham forest hotel,oak hill,woodford green,essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 set 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 16 set 1980
    Consegnato il 18 set 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Canons hotel,wadesmill road,ware,herts.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 set 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 23 apr 1980
    Consegnato il 01 mag 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 old watling street hamstead hartfordshire title no hd 28681. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mag 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 03 mar 1980
    Consegnato il 13 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H leicestershire moat house oadby leicestershire title no lt 40442.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 03 mar 1980
    Consegnato il 12 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £145,000 and all monies due or to become due from the company and/or queens moat houses LTD to eveands brewery LTD
    Brevi particolari
    Land situate fronting wigston rd, oadby leicester together with hotel & premises known as leicestershire moat house, wigston rd, oadby. Together with all fixtures. (See doc M65 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Everards Brewery Limited
    Transazioni
    • 12 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 07 ago 1979
    Consegnato il 17 ago 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H the leicestershire moat house (previously known as the hermitage hotel) oadby leicestershire title no lt 65560.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 24 lug 1979
    Consegnato il 30 lug 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    42 forest drive woodford green waltham forest essex and a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank Limited
    Transazioni
    • 30 lug 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 02 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0