NSS NEWSAGENTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NSS NEWSAGENTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00568277 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NSS NEWSAGENTS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova NSS NEWSAGENTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Mccoll's House Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Essex |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di NSS NEWSAGENTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 26 nov 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per NSS NEWSAGENTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Simon Jeremy Ian Fuller come amministratore in data 22 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Robbie Ian Bell come amministratore in data 31 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Jeremy Ian Fuller il 24 ott 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 29 ago 2018
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 26 nov 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 27 nov 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 nov 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Mr Simon Jeremy Ian Fuller come amministratore in data 26 apr 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di James Lancaster come amministratore in data 26 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Kingsley John Tedder come segretario in data 12 ago 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 24 nov 2013 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Martyn James Aguss come amministratore in data 30 lug 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Martin Mccoll House Ashwells Road, Pilgrims Hatch, Brentwood Essex CM15 9ST* in data 21 gen 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di NSS NEWSAGENTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLER, Simon Jonathan | Segretario | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | British | 88269280005 | ||||||
| BELL, Robbie Ian | Amministratore | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | England | British | 97384120002 | |||||
| MILLER, Simon Jonathan | Amministratore | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | England | British | 88269280005 | |||||
| BARNES, Christopher Howard | Segretario | 11 Hepplewhite Close Baughurst RG26 5HD Basingstoke Hampshire | British | 25597650001 | ||||||
| GOSNELL, Michael James | Segretario | The Birches 1 Lowfield Close GU18 5QT Lightwater Surrey | British | 10496160001 | ||||||
| TAYLOR, Philip John Graham | Segretario | Cherry Tree House 19 Hill Road GU27 2JN Haslemere Surrey | British | 10082610001 | ||||||
| TEDDER, Kingsley John | Segretario | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | British | 101631010002 | ||||||
| AGUSS, Martyn James | Amministratore | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | England | British | 107991420002 | |||||
| COX, Allister Russell | Amministratore | The Small House Mynthurst Leigh RH2 8RJ Reigate Surrey | England | British | 31500810002 | |||||
| CULLENS, Alan | Amministratore | 4 Alexandra House Queens Hill Lodge SL5 7EQ Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 6875310002 | |||||
| FULLER, Simon Jeremy Ian | Amministratore | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | England | British | 181763320002 | |||||
| HANNA, Robert Houston | Amministratore | Cherry Garth Stokesheath Road Oxshott KT22 0PS Leatherhead Surrey | British | 10082620001 | ||||||
| LANCASTER, James | Amministratore | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | England | British | 147052660001 | |||||
| TAYLOR, Philip John Graham | Amministratore | Cherry Tree House 19 Hill Road GU27 2JN Haslemere Surrey | British | 10082610001 | ||||||
| WHITE, Philip Ernest | Amministratore | 17 Mayfields Sindlesham RG11 5BY Wokingham Berkshire | British | 10118800001 | ||||||
| WILKINSON, Stephen William | Amministratore | Martin Mccoll House Ashwells Road, CM15 9ST Pilgrims Hatch, Brentwood Essex | United Kingdom | British | 101631100002 | |||||
| WOOLHOUSE, Anthony Peter | Amministratore | Wellbourne Vicarage Hill GU9 8HG Farnham Surrey | British | 10496200001 | ||||||
| WYATT, Peter Robert Michael | Amministratore | Frogs Close Clayford Lane TA22 9RH Dulverton West Somerset | British | 10082630001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NSS NEWSAGENTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Mccoll Limited | 06 apr 2016 | Ashwells Road Pilgrims Hatch CM15 9ST Brentwood Mccolls House Essex England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
NSS NEWSAGENTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 28 nov 1998 Consegnato il 08 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 24 lug 1995 Consegnato il 31 lug 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Agreement | Creato il 15 giu 1976 Consegnato il 29 giu 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0