FOSTER & PLUMPTON LIMITED

FOSTER & PLUMPTON LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFOSTER & PLUMPTON LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00573130
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FOSTER & PLUMPTON LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova FOSTER & PLUMPTON LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FOSTER & PLUMPTON LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per FOSTER & PLUMPTON LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Christian Keen come amministratore in data 18 mag 2022

    1 pagineTM01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 apr 2021

    LRESSP

    Memorandum e Statuto

    19 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Marcus Hilger come amministratore in data 25 nov 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Christian Keen come amministratore in data 25 nov 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 apr 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 apr 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Marcus Hilger il 09 mar 2018

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Hanns Martin Lipp come amministratore in data 31 dic 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Marcus Hilger come amministratore in data 13 nov 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 mar 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Nomina di Hanns Martin Lipp come amministratore in data 21 dic 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thorsten Beer come amministratore in data 21 dic 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mar 2016

    Stato del capitale al 08 mar 2016

    • Capitale: GBP 6,010
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di FOSTER & PLUMPTON LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEGG, Nichola Louise
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Segretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    163214890001
    HALL, Wendy Margaret
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritish172979860001
    BRADLEY, Roger Watson
    30 Moorhead Terrace
    Nab Wood
    BD18 4LB Shipley
    West Yorkshire
    Segretario
    30 Moorhead Terrace
    Nab Wood
    BD18 4LB Shipley
    West Yorkshire
    British104475190001
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Segretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Segretario
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Segretario
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Segretario
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    STEWART, Brian
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    British980530001
    BARNETT, Geoffrey
    3 Nursery Walk
    HU16 4QJ Cottingham
    North Humberside
    Amministratore
    3 Nursery Walk
    HU16 4QJ Cottingham
    North Humberside
    British8920710001
    BEER, Thorsten
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGerman172030260001
    BIRMINGHAM, Terence John
    Tall Trees Ferry Road
    DN19 7BA Barrow Upon Humber
    South Humberside
    Amministratore
    Tall Trees Ferry Road
    DN19 7BA Barrow Upon Humber
    South Humberside
    British8572180001
    BRADLEY, Roger Watson
    30 Moorhead Terrace
    Nab Wood
    BD18 4LB Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    30 Moorhead Terrace
    Nab Wood
    BD18 4LB Shipley
    West Yorkshire
    British104475190001
    ENGLAND, Philip Nicholas
    5 Park Avenue
    Peper Harrow Park
    GU8 6BA Godalming
    Surrey
    Amministratore
    5 Park Avenue
    Peper Harrow Park
    GU8 6BA Godalming
    Surrey
    British43835770003
    FOSTER, Bernard
    8 Carrington Avenue
    HU16 4DY Cottingham
    North Humberside
    Amministratore
    8 Carrington Avenue
    HU16 4DY Cottingham
    North Humberside
    British26253450001
    FOSTER, Charles Henry
    Walkington House Townend Road
    Walkington
    HU17 8SY Beverley
    North Humberside
    Amministratore
    Walkington House Townend Road
    Walkington
    HU17 8SY Beverley
    North Humberside
    British41225420001
    FOSTER, Ida
    8 Carrington Avenue
    HU16 4DY Cottingham
    North Humberside
    Amministratore
    8 Carrington Avenue
    HU16 4DY Cottingham
    North Humberside
    British26478090001
    GEORGE, Anthony Herbert
    39 Derrymore Road
    Willerby
    HU10 6ET Hull
    North Humberside
    Amministratore
    39 Derrymore Road
    Willerby
    HU10 6ET Hull
    North Humberside
    British26478100001
    HILGER, Marcus
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    GermanyGerman238936580003
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Amministratore
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    British39644740002
    KEEN, Christian
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritish54544790004
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Amministratore
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritish8991780003
    KING, Richard William
    2 Long Garden Mews
    Long Garden Walk
    GU9 7HX Farnham
    Surrey
    Amministratore
    2 Long Garden Mews
    Long Garden Walk
    GU9 7HX Farnham
    Surrey
    British38834940003
    LIPP, Hanns Martin
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGerman220582440001
    MAJOR, Michael Evelyn
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    Amministratore
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    British31230890001
    MCLINTOCK, Clive Holt
    1 Blackhall Place
    Blackhall Lane
    TN15 0HT Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    1 Blackhall Place
    Blackhall Lane
    TN15 0HT Sevenoaks
    Kent
    British66692740001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Amministratore
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Germany62107000001
    ORME, Allan Cameron
    Cornerstones Lime Walk
    Dibden Purlieu
    SO4 5RB Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Cornerstones Lime Walk
    Dibden Purlieu
    SO4 5RB Southampton
    Hampshire
    British1271730001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    STEWART, Brian
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish980530001
    VIZARD, Ronald Charles, Harold
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    British122881190001
    WICKS, David Frederick
    8 Gloucester Drive
    Kempshott Rise
    RG22 4PH Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    8 Gloucester Drive
    Kempshott Rise
    RG22 4PH Basingstoke
    Hampshire
    British1257240001
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish120451550002

    Chi sono le persone con controllo significativo di FOSTER & PLUMPTON LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    06 apr 2016
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneGreat Britain
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01938797
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    FOSTER & PLUMPTON LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of variation
    Creato il 08 ott 1993
    Consegnato il 15 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Varying the terms of an agreement and undertaking dated 30TH october 1992;a retention of title agreement dated 30TH october 1992 and a debenture dated 3RD november 1992 as defined in this deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aah Pharmaceuticals Limited
    Transazioni
    • 15 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 nov 1992
    Consegnato il 04 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £1,605,000.00 and all monies due or to become due from the company under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aah Pharmaceuticals Limited
    Transazioni
    • 04 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Retention of title agreement
    Creato il 30 ott 1992
    Consegnato il 19 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Firstly all pharmacuetical and ancillary products supplied by aah to the company under th terms of the agreement and secondly the proceeds of sale of all such products.
    Persone aventi diritto
    • Aah Pharmaceuticals Limited
    Transazioni
    • 19 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 20 ott 1992
    Consegnato il 04 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See doc ref M429C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 ott 1986
    Consegnato il 08 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold - units 1 & 2 booth ferix road gode. By way of equitable charge all moneys received of any insurance whatsoever in respect of loss or damage by fire or otherwise to the buildings or any part thereof being subject to the security.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee & debenture
    Creato il 23 dic 1985
    Consegnato il 02 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 18 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 19 nov 1980
    Consegnato il 28 nov 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or the become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital fixtures fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 nov 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 22 feb 1980
    Consegnato il 06 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold 314 hessle road hull. Humberside.title no. Hs 45815.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 12 mag 1977
    Consegnato il 25 mag 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    258 hessle road, kingston upon hull, humberside, title no. Hs 9250.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    FOSTER & PLUMPTON LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 apr 2021Inizio della liquidazione
    11 ago 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0