H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED

H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàH.T.WEBB AND COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00575309
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova e oli e grassi commestibili (46330) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 giu 2013

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 mar 2013

    Stato del capitale al 25 mar 2013

    • Capitale: GBP 500,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    12 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jan Egtved Pedersen il 06 dic 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Lauritzen il 06 dic 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Tanjot Soar il 06 dic 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine225

    Chi sono gli amministratori di H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SOAR, Tanjot
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Segretario
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    British123350000001
    LAURITZEN, Peter
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    EnglandDanish123354600001
    PEDERSEN, Jan Egtved
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    EnglandDanish123347470001
    BALL, Ute Suse
    60 Sycamore Drive
    LE6 0EW Groby
    Leicestershire
    Segretario
    60 Sycamore Drive
    LE6 0EW Groby
    Leicestershire
    British118371550001
    BANCROFT, Lynne Deborah
    Playstole
    Chapel Lane Sissinghurst
    TN17 2JN Cranbrook
    Kent
    Segretario
    Playstole
    Chapel Lane Sissinghurst
    TN17 2JN Cranbrook
    Kent
    British70267830001
    JARVIS, Peter James
    184 Riddlesdown Road
    CR8 1DF Purley
    Surrey
    Segretario
    184 Riddlesdown Road
    CR8 1DF Purley
    Surrey
    British54493370001
    PRICE, John Philip
    20 Rossmore Court
    Park Road
    NW1 6XX London
    Segretario
    20 Rossmore Court
    Park Road
    NW1 6XX London
    British51592560002
    RAMSDEN, Andrew Nicholas
    The Old Forge
    Fall House Lane
    WF12 0NJ Dewsbury
    West Yorkshire
    Segretario
    The Old Forge
    Fall House Lane
    WF12 0NJ Dewsbury
    West Yorkshire
    British74484590001
    REYNOLDS, Andrew David Finch
    25 Franconia Road
    Clapham
    SW4 9NB London
    Segretario
    25 Franconia Road
    Clapham
    SW4 9NB London
    British63987530001
    YATES, Gordon
    3 Cornwallis Avenue
    CT6 6UQ Herne Bay
    Kent
    Segretario
    3 Cornwallis Avenue
    CT6 6UQ Herne Bay
    Kent
    British10502580001
    ALLIKER, Anthony John
    Treetops 508 Loose Road
    ME15 9UF Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Treetops 508 Loose Road
    ME15 9UF Maidstone
    Kent
    British10502610001
    BANCROFT, Lynne Deborah
    Playstole
    Chapel Lane Sissinghurst
    TN17 2JN Cranbrook
    Kent
    Amministratore
    Playstole
    Chapel Lane Sissinghurst
    TN17 2JN Cranbrook
    Kent
    EnglandBritish70267830001
    CHRISTIANSEN, Mikael
    Tarran Barn
    Hazelheads Lane
    HG5 0NX Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Tarran Barn
    Hazelheads Lane
    HG5 0NX Knaresborough
    North Yorkshire
    Danish89938470001
    CLARKE, Peter James
    21 Fennel Close
    Dickens Place
    ME1 1LW Rochester
    Kent
    Amministratore
    21 Fennel Close
    Dickens Place
    ME1 1LW Rochester
    Kent
    British91221920001
    DAVIDSON, Richard Colin Neil
    Maplewell Farm
    Maplewell Road
    LE12 8QY Woodhouse Eaves
    Leicestershire
    Amministratore
    Maplewell Farm
    Maplewell Road
    LE12 8QY Woodhouse Eaves
    Leicestershire
    United KingdomBritish110114680001
    EARPS, David Ian
    39 Dovedale Road
    West Bridgford
    NG2 6JB Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    39 Dovedale Road
    West Bridgford
    NG2 6JB Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish74248350001
    GILBERT, Martin James
    10 Knowle Green
    S17 3AP Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    10 Knowle Green
    S17 3AP Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish65655390002
    HEASMAN, Paul William
    7 Kesteven Close
    Halling
    ME2 1LZ Rochester
    Kent
    Amministratore
    7 Kesteven Close
    Halling
    ME2 1LZ Rochester
    Kent
    British82924260001
    INKPIN, Grant Roger
    Yew Tree House
    Wetherby Road
    LS22 4EP Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Yew Tree House
    Wetherby Road
    LS22 4EP Wetherby
    West Yorkshire
    British76825990001
    JARVIS, Peter James
    184 Riddlesdown Road
    CR8 1DF Purley
    Surrey
    Amministratore
    184 Riddlesdown Road
    CR8 1DF Purley
    Surrey
    EnglandBritish54493370001
    JONES, Roger Francis
    8 Northbrook Drive
    HA6 2YU Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    8 Northbrook Drive
    HA6 2YU Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish84336140001
    KIRKPATRICK, Peter John
    30 Ennerdale Drive
    Aughton
    L39 5HF Ormskirk
    Lancashire
    Amministratore
    30 Ennerdale Drive
    Aughton
    L39 5HF Ormskirk
    Lancashire
    British65033740001
    MORTENSEN, Ib
    Oak Beams
    Montreal Road
    TN13 2EP Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Oak Beams
    Montreal Road
    TN13 2EP Sevenoaks
    Kent
    Danish92120800001
    PEET, Nigel David
    49 Heworth Village
    YO31 1AE York
    Amministratore
    49 Heworth Village
    YO31 1AE York
    United KingdomBritish26623160002
    POPE, Charles Philip Torrington
    17 Festival Avenue
    DA3 7HR New Barn
    Kent
    Amministratore
    17 Festival Avenue
    DA3 7HR New Barn
    Kent
    British72399120001
    PRESTON, Frederick Alan
    Birchwood 73 Tunbury Avenue
    Walderslade
    ME5 9EJ Chatham
    Kent
    Amministratore
    Birchwood 73 Tunbury Avenue
    Walderslade
    ME5 9EJ Chatham
    Kent
    British56295570001
    RAMSDEN, Andrew Nicholas
    The Old Forge
    Fall House Lane
    WF12 0NJ Dewsbury
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Forge
    Fall House Lane
    WF12 0NJ Dewsbury
    West Yorkshire
    British74484590001
    SALKELD, David John
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish111995510001
    SMITH, Timothy John
    Swanland Lodge
    West End, Swanland
    HU14 3PE Hull
    East Yorkshire
    Amministratore
    Swanland Lodge
    West End, Swanland
    HU14 3PE Hull
    East Yorkshire
    United KingdomBritish84729640001
    VON MUHLENEN, Roger
    Ch-3186 Dudingen
    FOREIGN
    Switzerland
    Amministratore
    Ch-3186 Dudingen
    FOREIGN
    Switzerland
    Swiss10502620001
    WEBB, Anne Marie
    The Hermitage Les Maindonnaux
    St Martin
    Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    The Hermitage Les Maindonnaux
    St Martin
    Guernsey
    Channel Islands
    Swedish9818800002
    WEBB, John Ernest
    The Hermitage
    Les Maindonnaux
    GY4 6AH St Martin
    Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    The Hermitage
    Les Maindonnaux
    GY4 6AH St Martin
    Guernsey
    Channel Islands
    British9818790004

    H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 nov 1998
    Consegnato il 10 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 27 nov 1995
    Consegnato il 14 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a land at springhead orchard springhead enterprise park northfleet kent with the goodwill of the business and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 apr 1991
    Consegnato il 26 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land at spring head enterprise park springhead road northfleet kent t/n k 696044 and assigns goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 21 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 29 ago 1990
    Consegnato il 04 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 29 ott 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 apr 1984
    Consegnato il 19 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £140,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Merchant Investors (Trustee Services) Limited
    • John Ernest Webb
    • Graham Paul Nicholls
    Transazioni
    • 19 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 26 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 mar 1980
    Consegnato il 20 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & buildings 336 st james road, camberwell, london SE1.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank LTD
    Transazioni
    • 20 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 29 ott 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 mar 2014Data di scioglimento
    19 giu 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0