POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED

POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPOLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00576290
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Arterial Road
    SS15 6EE Laindon
    Essex
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    W.PARKINSON & SON(OF BRADFORD)LIMITED27 dic 195627 dic 1956

    Quali sono gli ultimi bilanci di POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Central Office Eagle Way Brentwood Essex CM13 3BW a Arterial Road Laindon Essex SS15 6EE in data 05 set 2019

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    3 pagineAA

    Stato del capitale al 15 lug 2019

    • Capitale: GBP 2
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    As the company no longer had any assets or liabilities and did not trade, that pursuant to section 641 of the company act 2006, the company reduce it share to £2 and pursuant to section 610(4) of the companies act 2006 it share premium to nil 25/06/2019
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Clive Henry Bailey come amministratore in data 08 ago 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Corey Martin Macgillivray come amministratore in data 08 ago 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Lowe come amministratore in data 08 ago 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Stuart Edgar Foulds come amministratore in data 18 set 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Glenn Hood come amministratore in data 18 set 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Cessazione della carica di Paul Alexander Macniven come amministratore in data 31 ott 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    2 pagineAA

    Nomina di Mr Michael Peter Darnell come segretario in data 26 lug 2016

    2 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 dic 2015

    Stato del capitale al 17 dic 2015

    • Capitale: GBP 30,000
    SH01

    Nomina di Mary Lucy Ransome come segretario in data 29 set 2015

    2 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Stuart David Mustoe il 15 lug 2015

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DARNELL, Michael Peter
    Charter Court, Newcomen Way
    Severalls Industrial Park
    CO4 9YA Colchester
    2
    England
    Segretario
    Charter Court, Newcomen Way
    Severalls Industrial Park
    CO4 9YA Colchester
    2
    England
    212057000001
    RANSOME, Mary Lucy
    Newcomen Way, Colchester Business Park
    CO4 9YA Colchester
    2 Charter Court
    Essex
    England
    Segretario
    Newcomen Way, Colchester Business Park
    CO4 9YA Colchester
    2 Charter Court
    Essex
    England
    203536940001
    FOULDS, Stuart Edgar
    SS15 6EE Laindon
    Arterial Road
    Essex
    England
    Amministratore
    SS15 6EE Laindon
    Arterial Road
    Essex
    England
    ScotlandBritish183160840001
    MUSTOE, Stuart David
    Charter Court, Newcomen Way
    Colchester Business Park
    CO4 9YA Colchester
    2
    Essex
    England
    Amministratore
    Charter Court, Newcomen Way
    Colchester Business Park
    CO4 9YA Colchester
    2
    Essex
    England
    EnglandBritish186382260001
    HUGHES, Graham Paul
    7 Sackville Close
    CM1 2LU Chelmsford
    Essex
    Segretario
    7 Sackville Close
    CM1 2LU Chelmsford
    Essex
    Other52315640002
    MACK, Lewis Bernard
    8 Crescent Gardens
    LS17 8DR Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    8 Crescent Gardens
    LS17 8DR Leeds
    West Yorkshire
    British5774080001
    PAGE, Clive Charles
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    Segretario
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    British20963910001
    MATHESON & CO LIMITED
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Segretario
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    1947590001
    ANDERSON, Ryan Jason
    Noak Hill Rd
    CM12 9UP Billericay
    252
    Essex
    England
    Amministratore
    Noak Hill Rd
    CM12 9UP Billericay
    252
    Essex
    England
    EnglandUs Citizen133391500001
    BAILEY, Clive Henry
    Central Office
    Eagle Way
    CM13 3BW Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Central Office
    Eagle Way
    CM13 3BW Brentwood
    Essex
    EnglandBritish96018870001
    BEYNON, Peter
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish38504390006
    BURGESS, Christopher Martin
    Rose Villas Main Street
    Sutton On The Forrest
    YO6 1DW York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Rose Villas Main Street
    Sutton On The Forrest
    YO6 1DW York
    North Yorkshire
    EnglandBritish5774090001
    CHECKLEY, Kenneth
    Thatched Cottage Leez Lane
    Hartford End
    CM3 1JP Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Thatched Cottage Leez Lane
    Hartford End
    CM3 1JP Chelmsford
    Essex
    British11513480004
    COWPER, John Bernard
    3 Gilbey Green
    Newport
    CB11 3RS Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    3 Gilbey Green
    Newport
    CB11 3RS Saffron Walden
    Essex
    British24251610001
    HAYDEN, Christopher William Roberts
    The Wilderness
    Pytches Road
    IP12 1EP Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    The Wilderness
    Pytches Road
    IP12 1EP Woodbridge
    Suffolk
    United KingdomBritish55991230008
    HOOD, Stephen Glenn
    Eagle Way
    CM13 3BW Brentwood
    Central Office
    Essex
    Amministratore
    Eagle Way
    CM13 3BW Brentwood
    Central Office
    Essex
    UkBritish145363880001
    JACKSON, Eric
    Spring Grove House
    Clayton West
    HD8 9HH Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Spring Grove House
    Clayton West
    HD8 9HH Huddersfield
    West Yorkshire
    British5774100001
    JONES, Alun Morton
    Fen House
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    Fen House
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Suffolk
    United KingdomBritish12785600004
    KERR, Stuart Donald
    Central Office
    Eagle Way
    CM13 3BW Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Central Office
    Eagle Way
    CM13 3BW Brentwood
    Essex
    EnglandBritish186382100001
    KIERNAN, Paul Roger
    Willow Green
    CM4 0DQ Ingatestone
    41
    Essex
    England
    Amministratore
    Willow Green
    CM4 0DQ Ingatestone
    41
    Essex
    England
    British133388000001
    LOWE, David
    Eagle Way
    Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1 447
    Essex
    England
    Amministratore
    Eagle Way
    Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1 447
    Essex
    England
    EnglandBritish162848040001
    MACGILLIVRAY, Corey Martin
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    Amministratore
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    United StatesAmerican158956920001
    MACK, Lewis Bernard
    8 Crescent Gardens
    LS17 8DR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 Crescent Gardens
    LS17 8DR Leeds
    West Yorkshire
    British5774080001
    MACNIVEN, Paul Alexander
    447 Eagle Way
    Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1
    Essex
    England
    Amministratore
    447 Eagle Way
    Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1
    Essex
    England
    GermanyBritish181941880001
    MYERS, Bryan David
    Mevissenstrasse 16
    Cologne
    50668
    Germany
    Amministratore
    Mevissenstrasse 16
    Cologne
    50668
    Germany
    British98436230001
    PARKER, Nigel Martin
    71a Wensleydale Road
    TW12 2LP Hampton
    Middlesex
    Amministratore
    71a Wensleydale Road
    TW12 2LP Hampton
    Middlesex
    EnglandBritish41112840001
    POTTS, Derek
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    Amministratore
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish52485510001
    RITCHIE, John Muir
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    Amministratore
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    British22325820001
    STREETS, Harold
    Long Acre Green Lane
    Scawthorpe
    DN5 7UT Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Long Acre Green Lane
    Scawthorpe
    DN5 7UT Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandEnglish19492250001
    THORLEY, David Ian
    14 Triumph Road
    Glenfield
    LE3 8FR Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    14 Triumph Road
    Glenfield
    LE3 8FR Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritish97880070001
    TURNER, Mark C
    Eagle Way
    Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    Amministratore
    Eagle Way
    Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    United KingdomAmerican161305720001
    WATKINS, Terry Christopher
    Heathercliffe Lodge
    Penistone
    S30 6FF Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Heathercliffe Lodge
    Penistone
    S30 6FF Sheffield
    South Yorkshire
    British5774110001
    WILLIAMS, Steven Wyn
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish54580940001
    WITT, John Raymond
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    Canadian51303670001

    Chi sono le persone con controllo significativo di POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Ford Retail Group Ltd
    Charter Court, Newcomen Way
    Severalls Industrial Park
    CO4 9YA Colchester
    Trustford
    England
    06 apr 2016
    Charter Court, Newcomen Way
    Severalls Industrial Park
    CO4 9YA Colchester
    Trustford
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUk
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione950395
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A bulk deposit mortgage
    Creato il 04 gen 1993
    Consegnato il 09 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies deposited from time to time by the co. With the chargee pursuant to a sor agreement dated 01.09.92.
    Persone aventi diritto
    • Ford Credit PLC
    Transazioni
    • 09 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from polar motor company (york) limited to the chargee on any acount whatsoever and by the mortgagor under te terms of the charge.
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments & premises land lying to the east of lumb lane bradford W. yorkshire t/n wyk 13808.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from polar motor company (york) limited to the chargee on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the chage.
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments & premises 78 and 80 bowland street bradford t/n wyk 15028.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from polar motor company (york) limited to the chargee on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    F/H lands & hereditaments & premises:- 119 manningham lane bradford t/n wyk 85549.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments & premises land off st judes place bradford and 52 and 56 to 72 (even nos.), 74 and 76, 67 and 69 all at bowland street bradford and 2 to 28 (even nos) elmsall street bradford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments & premises st judes school st judes street bradford t/n wyk 11105.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments & premises 111 manningham lane bradford t/n wyk 85543.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from polar motot company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments & premises being:- 121 manningham lane bradford t/n wyk 104611.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments and premises being:- 3-29 (odd nos.) st judes street bradford t/n wyk 104613.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments and premises being:- 125 manningham lane bradford t/n wyk 101742.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments and premises being:- land lying to the north east of st judes street bradford t/n wyk 97959.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments and premises being:- site of former parish church of st.judes manningham bradford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments and premises being:- 123 and 127 manningham lane bradford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments and premises being:- land with workshop bowland street bradford and st judes place bradford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgage under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    F/H lands herditaments & premises being:- dwelling houses and land 46 48 50 bowland street bradford st judes place and st judes square manningham bradford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgage under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments & premises being:- 2-10 (even nos.) st.judes place bradford and 1, 3-10, and 12 st judes square, bradford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 07 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgage under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments & premises being:- shops and office 113/117 manningham lane bradford and land at bowland street bradford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 04 ago 1987
    Consegnato il 06 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 31 dic 1984
    Consegnato il 21 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1) the benefit of all contracts for the hire of motor vehicles on conditional sale, lease or contract hire with ford credit 2) all right and title to the motor vehicles comprised in their security 3) all proceeds of sale & insurance monies recievable in respect of the assets comprised in this security.
    Persone aventi diritto
    • Ford Motor Credit Company
    Transazioni
    • 21 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 23 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 09 ott 1978
    Consegnato il 13 ott 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the:- undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital. Shares, stocks and all other securities.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 15 giu 1977
    Consegnato il 27 giu 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies deposited from time to time with fons motor credit company LTD persuant to the terms of a sale or return agreement dated 1-9-74.
    Persone aventi diritto
    • Ford Motor Credit Company
    Transazioni
    • 27 giu 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 23 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 mag 1977
    Consegnato il 09 giu 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1. f/h property known as comprising strip of land lying between the commercial workshops and st judes church off bowland street bradford. Described in statutory declaration dated 26 april 1977. (see doc M65) 2. site of former st jude's church bradford, west yorkshire. Title no wyk 97959.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 mag 1977
    Consegnato il 09 giu 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property 3-29 (odd) st jude's street, bradford, west yorkshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 mag 1977
    Consegnato il 08 giu 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the east of lumb lane, bradford, west yorkshire title no wyk 13808. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 mag 1977
    Consegnato il 08 giu 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    78 and 80 bowland street bradford, west yorkshire title no. Wyk 15028. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0