DAWES GROUP LIMITED

DAWES GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDAWES GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00581187
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DAWES GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova DAWES GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o DELOITTE LLP
    2 Harman Street
    M60 2AT Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DAWES GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HERBERT DAWE LIMITED29 mar 195729 mar 1957

    Quali sono gli ultimi bilanci di DAWES GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per DAWES GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Indirizzo della sede legale modificato da Level 13 the Broadgate Tower Primrose Street London EC2A 2EW in data 13 dic 2012

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di John Tennent Terras come segretario in data 30 nov 2012

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di John Tennent Terras come amministratore in data 30 nov 2012

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jeremy John Foster Blood come amministratore in data 30 nov 2012

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di William Hornby Gore come amministratore in data 30 nov 2012

    2 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Nomina di Jeremy John Foster Blood come amministratore in data 01 feb 2012

    3 pagineAP01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    11 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Conflicts of interest/auth share cap be dissapplied 01/02/2012
    RES13

    Indirizzo della sede legale modificato da Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE United Kingdom in data 23 feb 2012

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Anne Louise Oliver come segretario in data 01 feb 2012

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Sean Michael Paterson come amministratore in data 01 feb 2012

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anne Louise Oliver come amministratore in data 01 feb 2012

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Charles Low come amministratore in data 01 feb 2012

    2 pagineTM01

    Nomina di John Tennent Terras come segretario in data 01 feb 2012

    3 pagineAP03

    Nomina di Mr William Hornby Gore come amministratore in data 01 feb 2012

    3 pagineAP01

    Nomina di John Tennent Terras come amministratore in data 01 feb 2012

    3 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Ashby House 1 Bridge Street Staines Middlesex TW18 4TP in data 22 dic 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 18 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 dic 2011

    Stato del capitale al 01 dic 2011

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Anne Louise Oliver il 01 dic 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Anne Louise Oliver il 01 dic 2011

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Sean Michael Paterson il 17 ott 2011

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Sean Michael Paterson come amministratore in data 29 set 2011

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di DAWES GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Segretario
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    BritishHead Of Uk Tax132259650001
    GOULD, Gerald Edward
    Sunnyview
    Caundle Marsh
    DT9 5LX Sherborne
    Dorset
    Segretario
    Sunnyview
    Caundle Marsh
    DT9 5LX Sherborne
    Dorset
    British14319010001
    HITCHINER, Christopher David
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    Segretario
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    BritishDeputy Company Secretary71528270003
    OLIVER, Anne Louise
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Segretario
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    BritishUk Tax Manager132910690001
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Segretario
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    BritishCompany Secretary80951870003
    TERRAS, John Tennent
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13 The Broadgate Tower
    United Kingdom
    Segretario
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13 The Broadgate Tower
    United Kingdom
    British166972570001
    ARMSTRONG, John Dillworth
    White Cottage
    Westerland Marldon
    TQ3 1RR Paignton
    Amministratore
    White Cottage
    Westerland Marldon
    TQ3 1RR Paignton
    EnglandBritishCompany Director20064560001
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Amministratore
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    ScotlandBritishHead Of Uk Tax132259650001
    BLOOD, Jeremy John Foster
    The Broadgate Tower
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13
    United Kingdom
    Amministratore
    The Broadgate Tower
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector106494920001
    DOWDESWELL, Michael John
    15 Manor Park
    Tockington
    BS32 4NS Bristol
    South Gloucestershire
    Amministratore
    15 Manor Park
    Tockington
    BS32 4NS Bristol
    South Gloucestershire
    United KingdomBritishLicenced Victualler10396210001
    FURSE, Timothy Machin
    Rock House
    Fownhope
    HR1 4NT Herefordshire
    Amministratore
    Rock House
    Fownhope
    HR1 4NT Herefordshire
    BritishDirector32520640003
    GAYNOR, Patrick
    Linch Old Rectory
    Redford
    GU29 0QD Midhurst
    West Sussex
    Amministratore
    Linch Old Rectory
    Redford
    GU29 0QD Midhurst
    West Sussex
    EnglandBritishSolicitor55361720004
    GAYNOR, Patrick Spencer
    18 Colestown Street
    SW11 3EH London
    Amministratore
    18 Colestown Street
    SW11 3EH London
    BritishCompany Director55361720001
    GIBBS, Peter Bridger
    The Glebe Water Lane
    Coombe Bissett
    SP5 4LR Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    The Glebe Water Lane
    Coombe Bissett
    SP5 4LR Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director6877320001
    GORE, William Hornby
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13 The Broadgate Tower
    United Kingdom
    Amministratore
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13 The Broadgate Tower
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector94619220003
    GREGORY, Trevor John
    The Hollies
    HR2 8JE Llanwarne
    Herefordshire
    Amministratore
    The Hollies
    HR2 8JE Llanwarne
    Herefordshire
    United KingdomBritishAccountant106240790001
    HITCHINER, Christopher David
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritishSolicitor71528270003
    HORSLEY, Paul Mark
    Wishford House West Street
    Great Wishford
    SP2 0PQ Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Wishford House West Street
    Great Wishford
    SP2 0PQ Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director30381120003
    JAMET, Jean Francois
    3 Sion Hill Place
    BA1 5SJ Bath
    Amministratore
    3 Sion Hill Place
    BA1 5SJ Bath
    EnglandFrenchCommercial Director83396080001
    LAWTON, Simon Marcus
    28 Henleaze Avenue
    BS9 4ET Bristol
    Avon
    Amministratore
    28 Henleaze Avenue
    BS9 4ET Bristol
    Avon
    United KingdomBritishFinance Director68807890001
    LOW, John Charles
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Amministratore
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant162758370001
    MARDELL, James Charles
    Ashleigh Park
    Bampton
    EX16 9LF Tiverton
    31
    Devon
    Amministratore
    Ashleigh Park
    Bampton
    EX16 9LF Tiverton
    31
    Devon
    United KingdomBritishCompany Director173260370001
    NEWELL, Guy Barrington
    Bracken House Buttercliffe Rise
    Long Ashton
    BS41 9JA Bristol
    Avon
    Amministratore
    Bracken House Buttercliffe Rise
    Long Ashton
    BS41 9JA Bristol
    Avon
    EnglandBritishCompany Director87977070001
    OLIVER, Anne Louise
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Amministratore
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    United KingdomBritishUk Tax Manager132910690001
    PATERSON, Sean Michael
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Amministratore
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    ScotlandBritishAccountant141021760002
    PAYNE, William John
    Scottsdale
    TD6 9QE Melrose
    5
    Roxburghshire
    Amministratore
    Scottsdale
    TD6 9QE Melrose
    5
    Roxburghshire
    ScotlandBritishSolicitor136005370001
    RUDD, Michael
    1 Croome Close
    Hampton Dene
    HR1 1UY Hereford
    Amministratore
    1 Croome Close
    Hampton Dene
    HR1 1UY Hereford
    BritishDistribution And Logistics Dir47523920001
    STEBBINGS, William George
    Burghill
    HR4 7RX Hereford
    The Forge
    Herefordshire
    Amministratore
    Burghill
    HR4 7RX Hereford
    The Forge
    Herefordshire
    BritishSolicitor129413480001
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Amministratore
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    BritishCompany Secretary80951870003
    TEDFORD, Craig
    2 Rosslyn Terrace
    Dowanhill
    G12 9NB Glasgow
    Amministratore
    2 Rosslyn Terrace
    Dowanhill
    G12 9NB Glasgow
    United KingdomBritishCompany Director106867030001
    TERRAS, John Tennent
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13 The Broadgate Tower
    United Kingdom
    Amministratore
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    Level 13 The Broadgate Tower
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector133751640001
    TYRRELL, Raymond Warley
    4 Chiltern Park
    Thornbury
    BS35 2HX Bristol
    Avon
    Amministratore
    4 Chiltern Park
    Thornbury
    BS35 2HX Bristol
    Avon
    BritishDirector10396200001
    WALLER, Andrew Austin
    3 Little Brind Road
    Upper Newbold
    S41 8XW Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    3 Little Brind Road
    Upper Newbold
    S41 8XW Chesterfield
    Derbyshire
    BritishDirector60988410002

    DAWES GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 15 gen 2003
    Consegnato il 22 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the group or any member or the group to any creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that f/h land k/a the land and buildings lying to the north of eign street, land at the junction of whitecross street and plough lane in the parish of all saints within the city of hereford numbered 111 and 111A, land k/a kings acre sports ground pentland gardens hereford and wells t/n HE9350 (for further properties charged refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Intercreditor Agent
    Transazioni
    • 22 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 12 dic 1993
    Consegnato il 21 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company and all patents,patent applications,inventions,trade marks,trade names etc.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 dic 1986
    Consegnato il 18 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land at yalberton industrial estate paignton devon.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 05 lug 1985
    Consegnato il 15 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts and other debts.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 21 giu 1979
    Consegnato il 03 lug 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land hereditaments and premises dawes mineral water factory, offices and land at curledge street paignton together with all fixtures etc present & future.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 26 ott 1961
    Consegnato il 02 nov 1961
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc.
    Brevi particolari
    Undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 1961Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0